Última actualización: 18 de Septiembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A82324807 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Montesa Numero 35, Escalera Izquierda, 2º Derec (Madrid). |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Presidente | Servant-Le Priol Charlotte Laurence Marie | 29/03/2021 | 25/01/2023 |
Presidente | Servant-Le Priol Charlotte Laurence Marie | 03/06/2016 | 25/01/2023 |
Consejero | Servant-Le Priol Charlotte Laurence Marie | 03/06/2016 | 25/01/2023 |
Consejero | Servant-Le Priol Charlotte Laurence Marie | 29/03/2021 | 25/01/2023 |
Apoderado | Servant-Le Priol Charlotte Laurence Marie | 03/06/2016 | 25/01/2023 |
Consejero | Servant Pauline Claude Marie | 06/07/2020 | 25/01/2023 |
Secretario | Ribalta Noguera Cristina | Desconocido | 25/01/2023 |
Apoderado | Nuñez Nuñez David | 06/07/2020 | 25/01/2023 |
Auditor | Morison Acpm Auditores SLP | 17/10/2022 | 25/01/2023 |
Apoderado | Martinez Berrocal Celia Maria | 09/07/2021 | 25/01/2023 |
Consejero | Le Priol Mathieu Joseph Therese | 13/07/2017 | 25/01/2023 |
Consejero | Le Priol Mathieu Joseph Therese | 29/12/2021 | 25/01/2023 |
Apoderado | Le Priol Mathieu Joseph Therese | 06/07/2020 | 25/01/2023 |
Consejero | Ardid Gumiel Andres | 10/02/2015 | 25/01/2023 |
Consejero | Ardid Gumiel Andres | 19/02/2020 | 25/01/2023 |
Apo.Man.Soli | Nuñez Nuñez David | 25/07/2014 | 06/07/2020 |
Apoderado | Le Priol Mathieu Joseph Therese | 13/07/2017 | 06/07/2020 |
Consejero | Ardid Gumiel Andres | 09/02/2010 | 06/07/2020 |
Apoderado | Ardid Gumiel Andres | Desconocido | 06/07/2020 |
Apoderado | Chevrot Pascal | Desconocido | 07/09/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Lavinia Seleccion SA.
18
Sep 2023
Con fecha 18/09/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Le Priol Mathieu Joseph Therese |
Adm. Unico | Lavinia Seleccion SA |
Datos registrales: T 34830 , F 7, S 8, H M 321348, I/A 52
25
Ene 2023
Con fecha 25/01/2023 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 38087 , F 90, S 8, H M 233071, I/A 56
25
Ene 2023
Con fecha 25/01/2023 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 38087 , F 90, S 8, H M 233071, I/A 56
25
Ene 2023
Se disuelve y extingue la sociedad al haber sido absorbida por la domiciliada en Madrid denominada " COSMOFI SA.
Datos registrales: T 38087 , F 90, S 8, H M 233071, I/A 56
25
Ene 2023
Con fecha 25/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Servant-Le Priol Charlotte Laurence Marie |
Apoderado | Nuñez Nuñez David |
Apoderado | Martinez Berrocal Celia Maria |
Apoderado | Le Priol Mathieu Joseph Therese |
Datos registrales: T 38087 , F 90, S 8, H M 233071, I/A 56
25
Ene 2023
Con fecha 25/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Servant-Le Priol Charlotte Laurence Marie |
Consejero | Servant Pauline Claude Marie |
Secretario | Ribalta Noguera Cristina |
Consejero | Le Priol Mathieu Joseph Therese |
Datos registrales: T 38087 , F 90, S 8, H M 233071, I/A 56
24
Nov 2022
Con fecha 24/11/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias COSMOFI SA.
Datos registrales: T 38087 , F 89, S 8, H M 233071, I/A 55
17
Oct 2022
Con fecha 17/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Morison Acpm Auditores SLP |
Datos registrales: T 38087 , F 89, S 8, H M 233071, I/A 54
29
Dic 2021
Con fecha 29/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Le Priol Mathieu Joseph Therese |
Datos registrales: T 38087 , F 89, S 8, H M 233071, I/A 53
09
Jul 2021
Con fecha 09/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Martinez Berrocal Celia Maria |
Datos registrales: T 38087 , F 89, S 8, H M 233071, I/A 52
29
Mar 2021
Con fecha 29/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Servant-Le Priol Charlotte Laurence Marie |
Datos registrales: T 38087 , F 88, S 8, H M 233071, I/A 51
06
Jul 2020
Con fecha 06/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Le Priol Mathieu Joseph Therese |
Datos registrales: T 38087 , F 87, S 8, H M 233071, I/A 50
06
Jul 2020
Con fecha 06/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Nuñez Nuñez David |
Datos registrales: T 38087 , F 86, S 8, H M 233071, I/A 49
06
Jul 2020
Con fecha 06/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Nuñez Nuñez David |
Apoderado | Le Priol Mathieu Joseph Therese |
Apoderado | Ardid Gumiel Andres |
Datos registrales: T 38087 , F 85, S 8, H M 233071, I/A 48
06
Jul 2020
Con fecha 06/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Servant Pauline Claude Marie |
Datos registrales: T 38087 , F 85, S 8, H M 233071, I/A 47
06
Jul 2020
Con fecha 06/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Ardid Gumiel Andres |
Datos registrales: T 38087 , F 85, S 8, H M 233071, I/A 47
19
Feb 2020
Con fecha 19/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Ardid Gumiel Andres |
Datos registrales: T 38087 , F 85, S 8, H M 233071, I/A 46
07
Sep 2018
Con fecha 07/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Chevrot Pascal |
Datos registrales: T 38087 , F 85, S 8, H M 233071, I/A 45
24
Ene 2018
Con fecha 24/01/2018, la sociedad cambia su domicilio social a C/ MONTESA NUMERO 35, ESCALERA IZQUIERDA, 2º DEREC (MADRID).
Datos registrales: T 27422 , F 32, S 8, H M 233071, I/A 44
31
Jul 2017
Con fecha 31/07/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificación del artículo 25 de los estatutos sociales..
Datos registrales: T 27422 , F 32, S 8, H M 233071, I/A 43
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-183-28 | Madrid | 25/09/2023 | |
BORME-A-2023-22-28 | Madrid | 01/02/2023 | |
BORME-A-2022-229-28 | Madrid | 01/12/2022 | |
BORME-A-2022-203-28 | Madrid | 24/10/2022 | |
BORME-A-2022-3-28 | Madrid | 05/01/2022 | |
BORME-A-2021-135-28 | Madrid | 16/07/2021 | |
BORME-A-2021-64-28 | Madrid | 07/04/2021 | |
BORME-A-2020-133-28 | Madrid | 13/07/2020 | |
BORME-A-2020-39-28 | Madrid | 26/02/2020 | |
BORME-A-2018-178-28 | Madrid | 14/09/2018 | |
BORME-A-2018-23-28 | Madrid | 01/02/2018 | |
BORME-A-2017-149-28 | Madrid | 07/08/2017 | |
BORME-A-2017-139-28 | Madrid | 24/07/2017 | |
BORME-A-2016-204-28 | Madrid | 25/10/2016 | |
BORME-A-2016-111-28 | Madrid | 13/06/2016 | |
BORME-A-2016-110-28 | Madrid | 10/06/2016 | |
BORME-A-2015-33-28 | Madrid | 18/02/2015 | |
BORME-A-2014-147-28 | Madrid | 05/08/2014 | |
BORME-A-2013-31-28 | Madrid | 14/02/2013 | |
BORME-A-2012-68-28 | Madrid | 10/04/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades