Última actualización: 28 de Agosto de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B58344540 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Cl Longitudinal 4 Num.22 Esc.B P.2 Despacho 74 (Barcelona). |
Capital social | 6.000.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPR.143 RRM | Schara Batlle Sabina Jenifer | 28/08/2023 | Actualidad |
ADM.UNICO | Masami Schara SL | 28/08/2023 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Torras Perez Manuel Angel | 03/06/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Ruiz Ortega Silvia | 03/06/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Roca Pellicer Roger | 03/06/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Muñoz Ramos Montserrat | 03/06/2021 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Bnfix Pich Auditores SLP | 24/07/2020 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Bnfix Pich Auditores SLP | 19/12/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Lukas Reinhold Bruder | 11/12/2017 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Batlle Soler Ana Maria | 01/10/2015 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Abante Pich Auditores SLP | 06/08/2014 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Abante Pich Auditores SLP | 19/07/2011 | Actualidad |
APODERADO | Schara Batlle Sabina Jennifer | 23/07/2010 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJERO | Torras Perez Manuel Angel | 22/03/2018 | 28/08/2023 |
CONSEJERO | Schara Batlle Michael Alexander | 20/01/2022 | 28/08/2023 |
CONSEJERO | Schara Batlle Anna Marlene | 20/01/2022 | 28/08/2023 |
CONSEJERO | Sabine Jenifer Schara Batlle | 22/03/2018 | 28/08/2023 |
CONS. DELEG. | Sabine Jenifer Schara Batlle | 22/03/2018 | 28/08/2023 |
PRESIDENTE | Michael Hans Georg Schara | 22/03/2018 | 28/08/2023 |
CONSEJERO | Michael Hans Georg Schara | 22/03/2018 | 28/08/2023 |
SECRETARIO | Garcia Sanchez Jose Maria | 22/03/2018 | 28/08/2023 |
CONSEJERO | Garcia Sanchez Jose Maria | 22/03/2018 | 28/08/2023 |
CONSEJERO | Batlle Soler Ana Maria | 22/03/2018 | 28/08/2023 |
CONS. DELEG. | Michael Hans Georg Schara | 22/03/2018 | 15/03/2021 |
CONS. DELEG. | Batlle Soler Ana Maria | 22/03/2018 | 15/03/2021 |
ADMINISTR. | Michael Hans Georg Schara | Desconocido | 22/03/2018 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por La Charcuteria Alemana Comercial SL.
28
Ago 2023
Con fecha 28/08/2023, la sociedad cambia su domicilio social a CL LONGITUDINAL 4 NUM.22 ESC.B P.2 DESPACHO 74 (BARCELONA).
Datos registrales: T 47395 , F 183, S 8, H B 80075, I/A 39
28
Ago 2023
Con fecha 28/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Schara Batlle Sabina Jenifer |
ADM.UNICO | Masami Schara SL |
Datos registrales: T 47395 , F 183, S 8, H B 80075, I/A 39
28
Ago 2023
Con fecha 28/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Torras Perez Manuel Angel |
CONSEJERO | Schara Batlle Michael Alexander |
CONSEJERO | Schara Batlle Anna Marlene |
CONS. DELEG. | Sabine Jenifer Schara Batlle |
CONSEJERO | Michael Hans Georg Schara |
SECRETARIO | Garcia Sanchez Jose Maria |
CONSEJERO | Batlle Soler Ana Maria |
Datos registrales: T 47395 , F 183, S 8, H B 80075, I/A 39
31
May 2023
Sociedades absorbidas: LA CHARCUTERIA ALEMANA SL.
Datos registrales: T 47395 , F 182, S 8, H B 80075, I/A 38
20
Ene 2022
Con fecha 20/01/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Schara Batlle Michael Alexander |
CONSEJERO | Schara Batlle Anna Marlene |
Datos registrales: T 47395 , F 181, S 8, H B 80075, I/A 37
03
Jun 2021
Con fecha 03/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Torras Perez Manuel Angel |
Datos registrales: T 47395 , F 181, S 8, H B 80075, I/A 36
03
Jun 2021
Con fecha 03/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Ruiz Ortega Silvia |
APODERAD.SOL | Roca Pellicer Roger |
APODERAD.SOL | Muñoz Ramos Montserrat |
Datos registrales: T 47395 , F 181, S 8, H B 80075, I/A 35
15
Mar 2021
Con fecha 15/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Michael Hans Georg Schara |
CONS. DELEG. | Batlle Soler Ana Maria |
Datos registrales: T 47395 , F 181, S 8, H B 80075, I/A 34
22
Feb 2021
Con fecha 22/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Schara Batlle Sabina Jenifer |
ADM.UNICO | La Charcuteria Alemana Comercial SL |
Datos registrales: T 45293 , F 164, S 8, H B 100976, I/A 27
22
Feb 2021
Con fecha 22/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Schara Batlle Sabina Jenifer |
ADM.UNICO | La Charcuteria Alemana Comercial SL |
Datos registrales: T 46266 , F 177, S 8, H B 91613, I/A 30
24
Jul 2020
Con fecha 24/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Bnfix Pich Auditores SLP |
Datos registrales: T 39315 , F 110, S 8, H B 80075, I/A 33
13
Jun 2019
Con fecha 13/06/2019, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 1.200.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 25.00% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 6.000.000,0€.
Datos registrales: T 39315 , F 110, S 8, H B 80075, I/A 32
22
Mar 2018
Con fecha 22/03/2018, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART.19.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 39315 , F 109, S 8, H B 80075, I/A 31
22
Mar 2018
Con fecha 22/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Torras Perez Manuel Angel |
CONSEJERO | Sabine Jenifer Schara Batlle |
CONSEJERO | Michael Hans Georg Schara |
CONSEJERO | Garcia Sanchez Jose Maria |
CONS. DELEG. | Batlle Soler Ana Maria |
Datos registrales: T 39315 , F 109, S 8, H B 80075, I/A 31
22
Mar 2018
Con fecha 22/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADMINISTR. | Michael Hans Georg Schara |
Datos registrales: T 39315 , F 109, S 8, H B 80075, I/A 31
19
Dic 2017
Con fecha 19/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Bnfix Pich Auditores SLP |
Datos registrales: T 39315 , F 109, S 8, H B 80075, I/A 30
11
Dic 2017
Con fecha 11/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Lukas Reinhold Bruder |
Datos registrales: T 39315 , F 107, S 8, H B 80075, I/A 29
07
Feb 2017
Con fecha 07/02/2017, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 800.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 20.00% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 4.800.000,0€.
Datos registrales: T 39315 , F 107, S 8, H B 80075, I/A 28
01
Oct 2015
Con fecha 01/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Batlle Soler Ana Maria |
Datos registrales: T 39315 , F 106, S 8, H B 80075, I/A 27
25
Nov 2014
Con fecha 25/11/2014, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 508.504,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 25.43% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 2.508.504,0€.
Datos registrales: T 39315 , F 105, S 8, H B 80075, I/A 25
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2023-168-08 | Barcelona | 04/09/2023 |
BORME-A-2023-106-08 | Barcelona | 07/06/2023 |
BORME-A-2022-21-08 | Barcelona | 01/02/2022 |
BORME-A-2021-112-08 | Barcelona | 15/06/2021 |
BORME-A-2021-56-08 | Barcelona | 24/03/2021 |
BORME-A-2021-41-08 | Barcelona | 02/03/2021 |
BORME-A-2020-148-08 | Barcelona | 03/08/2020 |
BORME-A-2019-120-08 | Barcelona | 26/06/2019 |
BORME-A-2018-64-08 | Barcelona | 03/04/2018 |
BORME-A-2017-245-08 | Barcelona | 28/12/2017 |
BORME-A-2017-239-08 | Barcelona | 19/12/2017 |
BORME-A-2017-32-08 | Barcelona | 15/02/2017 |
BORME-A-2015-193-08 | Barcelona | 08/10/2015 |
BORME-A-2014-230-08 | Barcelona | 02/12/2014 |
BORME-A-2014-153-08 | Barcelona | 13/08/2014 |
BORME-A-2014-17-08 | Barcelona | 27/01/2014 |
BORME-A-2013-32-08 | Barcelona | 15/02/2013 |
BORME-A-2011-144-08 | Barcelona | 29/07/2011 |
BORME-A-2010-147-08 | Barcelona | 03/08/2010 |
BORME-A-2009-24-08 | Barcelona | 05/02/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades