info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 0
Cargos no vigentes 5
Apariciones en BORME 8
Cargos directivos en empresas
Esta persona no tiene ningún cargo en la actualidad, o no hay datos disponibles.
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Manc. Ralph Lauren España SL 11/04/2016 05/10/2017
Apo.Manc. Acqui Polo España SL 06/04/2016 20/02/2017
Apo.Man.Soli Lvmh Iberia SL 13/05/2013 14/10/2013
Apo.Man.Soli Lvmh Iberia SL 01/07/2013 14/10/2013
Apoderado Lvmh Iberia SL 12/09/2011 08/05/2013
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Van Raemdonck Geoffroy .

05

Oct 2017

Revocaciones

Con fecha 05/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Van Raemdonck Geoffroy Charles Leon Robert Jose Ma
Apo.Manc. Van Raemdonck Geoffroy
Apo.Sol. Kemmett Simon William
Apo.Manc. Kemmett Simon

PDF Anuncio nº 405782 de 2017

Datos registrales: T 35533 , F 42, S 8, H M 176703, I/A 69

11

Abr 2016

Nombramientos

Con fecha 11/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Van Raemdonck Geoffroy
Apo.Manc. Suzuki Soko
Apo.Manc. Sawicki Monika
Apo.Manc. Onofri Nicolas Patrick
Apo.Manc. Milley Francis John
Apo.Manc. Martinez Cruz Jose Juan
Apo.Manc. Lund Christoffer
Apo.Manc. Kerschen Marco Rene Leon Robert
Apo.Manc. Kemmett Simon
Apo.Manc. Gradek-De Muynck Agnieszka
Apo.Manc. Flaux Damien Eric Michael
Apo.Manc. Demoulin Reka
Apo.Manc. Cugni Daniel Jean

PDF Anuncio nº 170058 de 2016

Datos registrales: T 16264 , F 214, S 8, H M 176703, I/A 61

06

Abr 2016

Nombramientos

Con fecha 06/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Van Raemdonck Geoffroy
Apo.Manc. Suzuki Soko
Apo.Manc. Sawicki Monika
Apo.Manc. Onofri Nicolas Patrick
Apo.Manc. Milley Francis John
Apo.Manc. Martinez Cruz Jose Juan
Apo.Manc. Lund Christoffer
Apo.Manc. Kerschen Marco Rene Leon Robert
Apo.Manc. Kemmett Simon
Apo.Manc. Gradek-De Muynck Agnieszka
Apo.Manc. Flaux Damien Eric Michael
Apo.Manc. Demoulin Reka
Apo.Manc. Cugni Daniel Jean

PDF Anuncio nº 163624 de 2016

Datos registrales: T 26695 , F 69, S 8, H M 246778, I/A 32

14

Oct 2013

Revocaciones

Con fecha 14/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Zanardi-Landi Christopher Charles
Apo.Man.Soli Van Raemdonck Geoffroy
Apo.Man.Soli Toma Paride
Apo.Man.Soli Perez Serena Jose Luis
Apo.Man.Soli Mosconi Elena
Apo.Man.Soli Dubois Frederic
Apo.Man.Soli Brunetiere Rebours Isabelle
Apo.Man.Soli Bravo Sjodin Eva Cristina
Apo.Man.Soli Bordas Vincent Serge Gilbert

PDF Anuncio nº 451313 de 2013

Datos registrales: T 27495 , F 23, S 8, H M 194452, I/A 106

01

Jul 2013

Nombramientos

Con fecha 01/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Van Raemdonck Geoffroy
Apo.Man.Soli Bravo Sjodin Eva Cristina
Apo.Man.Soli Bordas Vincent Serge Gilbert

PDF Anuncio nº 311645 de 2013

Datos registrales: T 27495 , F 22, S 8, H M 194452, I/A 105

13

May 2013

Nombramientos

Con fecha 13/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Zanardi-Landi Christopher Charles
Apo.Man.Soli Van Raemdonck Geoffroy
Apo.Man.Soli Toma Paride
Apo.Man.Soli Perez Serena Jose Luis
Apo.Man.Soli Mosconi Elena
Apo.Man.Soli Dubois Frederic
Apo.Man.Soli Brunetiere Rebours Isabelle
Apo.Man.Soli Bravo Sjodin Eva Cristina
Apo.Man.Soli Bordas Vincent Serge Gilbert

PDF Anuncio nº 229886 de 2013

Datos registrales: T 27495 , F 21, S 8, H M 194452, I/A 104

08

May 2013

Revocaciones

Con fecha 08/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Van Raemdonck Geoffroy
Apoderado Toma Paride
Apoderado Perez Serena Jose Luis
Apoderado Gallot Jean Marc
Apoderado Delso Mion Carlos
Apoderado Brunetiere Rebours Isabelle
Apoderado Bordas Vincent Serge Gilbert
Apoderado Abad Acosta Enrique

PDF Anuncio nº 225180 de 2013

Datos registrales: T 27495 , F 20, S 8, H M 194452, I/A 102

12

Sep 2011

Nombramientos

Con fecha 12/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Van Raemdonck Geoffroy
Apoderado Toma Paride
Apoderado Perez Serena Jose Luis
Apoderado Gallot Jean Marc
Apoderado Delso Mion Carlos
Apoderado Brunetiere Rebours Isabelle
Apoderado Bordas Vincent Serge Gilbert
Apoderado Abad Acosta Enrique

PDF Anuncio nº 381193 de 2011

Datos registrales: T 27495 , F 17, S 8, H M 194452, I/A 97

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2017-197-28 Madrid 16/10/2017
PDF BORME-A-2016-74-28 Madrid 19/04/2016
PDF BORME-A-2016-71-28 Madrid 14/04/2016
PDF BORME-A-2013-202-28 Madrid 22/10/2013
PDF BORME-A-2013-128-28 Madrid 09/07/2013
PDF BORME-A-2013-93-28 Madrid 21/05/2013
PDF BORME-A-2013-91-28 Madrid 17/05/2013
PDF BORME-A-2011-181-28 Madrid 22/09/2011

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret