Última actualización: 20 de Marzo de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.
Cargos activos | 13 |
---|---|
Cargos no vigentes | 115 |
Apariciones en BORME | 200 |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Landcompany 2020 SL | 20/03/2024 | Actualidad |
Apoderado | Landcompany 2020 SL | 25/10/2023 | Actualidad |
Apoderado | Nalmar Estate SL | 10/09/2022 | Actualidad |
Representan | Ad Home Torrejon SA | 07/07/2022 | Actualidad |
Representan | Druet Real Estate SL | 20/06/2022 | Actualidad |
Apoderado | Quabit Palmaces SL | 30/05/2019 | Actualidad |
Apo.Sol. | Quabit Aguas Vivas SL | 05/07/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Quabit Aguas Vivas SL | 05/07/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Quabit Sureste SL | 04/07/2018 | Actualidad |
Apo.Sol. | Quabit Sureste SL | 04/07/2018 | Actualidad |
Apo.Manc. | Iber Activos Inmobiliarios SL | 22/04/2015 | Actualidad |
Apoderado | Iber Activos Inmobiliarios SL | 27/11/2014 | Actualidad |
Apo.Man.Soli | Masia De Monte Sano SL | 12/05/2014 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Representan | Landscape Corsan SL | 03/01/2013 | 21/02/2023 |
REPR.143 RRM | Masia De Monte Sano SL | Desconocido | 07/09/2022 |
Apo.Sol. | Quabit Hortaleza SL | 04/07/2018 | 20/04/2022 |
Apo.Sol. | Quabit Hortaleza SL | 04/07/2018 | 20/04/2022 |
Apoderado | Quabit El Vado SL | 30/05/2019 | 20/04/2022 |
Apo.Sol. | Quabit Distrito Centro SL | 04/07/2018 | 20/04/2022 |
Apo.Sol. | Quabit Distrito Centro SL | 04/07/2018 | 20/04/2022 |
Apoderado | Quabit Corredor Henares SL | 21/01/2019 | 20/04/2022 |
Apoderado | Quabit Corredor Henares SL | 21/01/2019 | 20/04/2022 |
Apoderado | Quabit Corredor Henares SL | 21/01/2019 | 20/04/2022 |
Apoderado | El Balcon De Las Cañas SL | 03/02/2012 | 20/04/2022 |
Apo.Man.Soli | Quabit Bonaire SL | 07/05/2019 | 15/12/2021 |
Apoderado | Quabit Alcarria SL | 17/11/2017 | 15/12/2021 |
Apo.Man.Soli | Iber Activos Inmobiliarios SL | 01/12/2017 | 15/12/2021 |
Apoderado | Global Quabit Sur SL | 30/11/2017 | 15/12/2021 |
Apoderado | Global Quabit SL | 03/01/2017 | 15/12/2021 |
Apoderado | Global Quabit SL | 15/11/2017 | 15/12/2021 |
Apoderado | Global Quabit Desarrollos Inmobiliarios SL | 17/11/2017 | 15/12/2021 |
Apoderado | Global Quabit Cañaveral Tercera Fase SL | 12/12/2017 | 15/12/2021 |
Apo.Sol. | Bulwin Investments SA | 19/09/2014 | 15/12/2021 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Prieto Ruiz Javier Manuel .
20
Mar 2024
Con fecha 20/03/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Datos registrales: T 45574 , F 13, S 8, H M 688510, I/A 96
25
Oct 2023
Con fecha 25/10/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sagrario Bueno Laura |
Apoderado | Reñon Ferreiro Maria |
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apoderado | Perez Almansa Daniel |
Apoderado | Pedreño Celdran Maria Del Mar |
Apoderado | Nombela Sanchez Maria Gemma |
Apoderado | Molina Perez Raquel |
Apoderado | Martinez Gomez Maria Josefa |
Apoderado | Garcia Garcia Maria Laura |
Apoderado | Fernandez Casado Gema Maria |
Apoderado | Dorado Calvo Maria |
Datos registrales: T 45574 , F 8, S 8, H M 688510, I/A 88
10
Sep 2022
Con fecha 10/09/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Datos registrales: T 43716 , F 176, S 8, H M 666857, I/A 10
07
Sep 2022
Con fecha 07/09/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Prieto Ruiz Javier Manuel |
CONSEJERO | Neinor Peninsula SL |
CONSEJERO | El Balcon De Las Cañas SL |
Datos registrales: T 45371 , F 101, S 8, H B 485554, I/A 30
07
Jul 2022
Con fecha 07/07/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Torres De La Llana Alberto |
Representan | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Secretario | Guadahermosa Proyectos Urbanisticos 2001 SL |
Consejero | Cobo Moral Pablo |
Datos registrales: T 43795 , F 161, S 8, H M 772913, I/A 1
20
Jun 2022
Con fecha 20/06/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Secretario | Juan Antonio Ibañez Lopez |
Consejero | Ibañez Lopez Juan Antonio |
Consejero | Guadahermosa Proyectos Urbanisticos 2001 SL |
Con.Delegado | Cobo Moral Pablo |
Datos registrales: T 41060 , F 101, S 8, H M 728154, I/A 4
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Sol. | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 41591 , F 92, S 8, H M 586440, I/A 6
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apo.Man.Soli | Ruiz Garcia Eduardo |
Apo.Man.Soli | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Man.Soli | Monserrat Lorente Ramon |
Apo.Sol. | Melero Bowen Miguel Angel |
Apo.Man.Soli | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 38867 , F 217, S 8, H M 690879, I/A 10
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apoderado | Ruiz Garcia Eduardo |
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apoderado | Melero Bowen Miguel Angel |
Apoderado | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 37019 , F 11, S 8, H M 661373, I/A 10
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apo.Man.Soli | Ruiz Garcia Eduardo |
Apo.Man.Soli | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Man.Soli | Monserrat Lorente Ramon |
Apo.Man.Soli | Melero Bowen Miguel Angel |
Apo.Man.Soli | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 38240 , F 83, S 8, H M 680438, I/A 9
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apo.Man.Soli | Ruiz Garcia Eduardo |
Apo.Man.Soli | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apoderado | Melero Bowen Miguel Angel |
Apo.Man.Soli | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 41859 , F 150, S 8, H M 668032, I/A 11
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apo.Man.Soli | Ruiz Garcia Eduardo |
Apo.Man.Soli | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Man.Soli | Melero Bowen Miguel Angel |
Apo.Man.Soli | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 42842 , F 92, S 8, H M 657475, I/A 8
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apoderado | Ruiz Garcia Eduardo |
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Man.Soli | Melero Bowen Miguel Angel |
Apoderado | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 36643 , F 105, S 8, H M 629544, I/A 16
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apoderado | Ruiz Garcia Eduardo |
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Man.Soli | Melero Bowen Miguel Angel |
Apoderado | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 41267 , F 196, S 8, H M 645688, I/A 10
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apoderado | Ruiz Garcia Eduardo |
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apoderado | Melero Bowen Miguel Angel |
Apoderado | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 36483 , F 81, S 8, H M 645901, I/A 12
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apoderado | Ruiz Garcia Eduardo |
Apo.Man.Soli | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Man.Soli | Melero Bowen Miguel Angel |
Apo.Man.Soli | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 41776 , F 2, S 8, H M 645506, I/A 11
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apo.Manc. | Ruiz Garcia Eduardo |
Apo.Manc. | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apoderado | Melero Bowen Miguel Angel |
Apo.Manc. | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 36175 , F 115, S 8, H M 650087, I/A 8
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apoderado | Ruiz Garcia Eduardo |
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Man.Soli | Melero Bowen Miguel Angel |
Apoderado | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 36233 , F 24, S 8, H M 651062, I/A 8
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apoderado | Ruiz Garcia Eduardo |
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apo.Man.Soli | Melero Bowen Miguel Angel |
Apoderado | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 41972 , F 81, S 8, H M 626506, I/A 19
15
Dic 2021
Con fecha 15/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanchez De Lamadrid Camps Gabriel |
Apoderado | Ruiz Garcia Eduardo |
Apoderado | Prieto Ruiz Javier Manuel |
Apoderado | Herranz Garcia Miguel Angel |
Datos registrales: T 38235 , F 96, S 8, H M 680353, I/A 5
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-62-28 | Madrid | 27/03/2024 | |
BORME-A-2023-209-28 | Madrid | 02/11/2023 | |
BORME-A-2022-178-28 | Madrid | 16/09/2022 | |
BORME-A-2022-176-08 | Barcelona | 14/09/2022 | |
BORME-A-2022-134-28 | Madrid | 14/07/2022 | |
BORME-A-2022-121-28 | Madrid | 27/06/2022 | |
BORME-A-2021-243-28 | Madrid | 22/12/2021 | |
BORME-A-2021-212-28 | Madrid | 04/11/2021 | |
BORME-A-2021-179-28 | Madrid | 16/09/2021 | |
BORME-A-2021-171-28 | Madrid | 06/09/2021 | |
BORME-A-2021-130-28 | Madrid | 09/07/2021 | |
BORME-A-2021-111-28 | Madrid | 14/06/2021 | |
BORME-A-2021-110-28 | Madrid | 11/06/2021 | |
BORME-A-2021-64-28 | Madrid | 07/04/2021 | |
BORME-A-2020-217-28 | Madrid | 11/11/2020 | |
BORME-A-2020-63-28 | Madrid | 31/03/2020 | |
BORME-A-2019-243-28 | Madrid | 20/12/2019 | |
BORME-A-2019-109-28 | Madrid | 11/06/2019 | |
BORME-A-2019-107-28 | Madrid | 07/06/2019 | |
BORME-A-2019-106-28 | Madrid | 06/06/2019 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades