info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 7
Cargos no vigentes 9
Apariciones en BORME 24
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Manc. Promontoria Omega SL 24/10/2023 Actualidad
Apo.Manc. Promontoria Poseidon SL 19/05/2023 Actualidad
Apo.Manc. Promontoria Omega SL 18/06/2021 Actualidad
Apo.Sol. Sky Cim Spain SL 25/05/2021 Actualidad
Apoderado Funcalata Servicios Y Gestiones SL 21/05/2021 Actualidad
Apo.Sol. Banco Santander SA 20/11/2018 Actualidad
Apo.Manc. Banco Santander SA 20/11/2018 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Manc. Promontoria Omega SL 30/11/2020 16/12/2021
Apo.Manc. Promontoria Omega SL 21/05/2019 18/06/2021
Apoderado Gescobro Collection Services SL 30/07/2018 15/06/2020
Apo.Manc. Tdx Indigo Iberia SL 24/02/2014 14/02/2019
Miem.Com.Ctr Fondomutua Empleo Moderado FP 04/07/2014 28/09/2018
Apoderado Tdx Indigo Iberia SL 26/10/2011 24/02/2014
Apoderado Tdx Indigo Iberia SL 26/04/2010 26/10/2011
Apoderado Tdx Indigo Iberia SL 27/07/2009 26/04/2010
Apoderado Tdx Indigo Iberia SL Desconocido 27/07/2009
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Mato Garcia Agustin Iñigo .

24

Oct 2023

Nombramientos

Con fecha 24/10/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Van Vliet Jasper Jan
Apo.Manc. Van Der Heijde Patrick
Apo.Manc. Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
Apo.Manc. Van De Werken Arjen
Apo.Manc. Schipper Gerardus Johannes
Apo.Manc. Romero Alonso Francisco
Apo.Manc. Puig Ruano Ursula
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Lazareva Anna
Apo.Manc. Hofland Raoul Rene
Apo.Manc. Gonzalez Perez Saul
Apo.Manc. Deler Pamblanco Silvia
Apo.Manc. Carrer Vives Albert
Apo.Manc. Baaijens Lukas Christiaan
Apo.Manc. Astarloa Echevarrieta Maria

PDF Anuncio nº 463213 de 2023

Datos registrales: T 42862 , F 6, S 8, H M 679704, I/A 21

19

May 2023

Nombramientos

Con fecha 19/05/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Romero Alonso Francisco
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Martinez Miralles Riquelme Ana
Apo.Manc. Gonzalez Perez Saul

PDF Anuncio nº 240913 de 2023

Datos registrales: T 44176 , F 213, S 8, H M 779015, I/A 13

16

Dic 2021

Revocaciones

Con fecha 16/12/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Van Vliet Jasper Jan
Apo.Manc. Van Der Heijde Patrick
Apo.Manc. Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
Apo.Manc. Van De Werken Arjen
Apo.Manc. Schipper Gerardus Johannes
Apo.Manc. Romero Alonso Francisco
Apo.Manc. Puig Ruano Ursula
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Martinez Miralles Riquelme Ana
Apo.Manc. Honing Irma Desiree
Apo.Manc. Hofland Raoul Rene
Apo.Manc. Gonzalez Perez Saul
Apo.Manc. Baaijens Lukas Christiaan
Apo.Manc. Alvarez Llorca Mercedes

PDF Anuncio nº 554100 de 2021

Datos registrales: T 39819 , F 159, S 8, H M 679704, I/A 16

18

Jun 2021

Nombramientos

Con fecha 18/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Van Vliet Jasper Jan
Apo.Manc. Van Der Heijde Patrick
Apo.Manc. Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
Apo.Manc. Van De Werken Arjen
Apo.Manc. Schipper Gerardus Johannes
Apo.Manc. Puig Ruano Ursula
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Honing Irma Desiree
Apo.Manc. Hofland Raoul Rene
Apo.Manc. Gonzalez Perez Saul
Apo.Manc. Baaijens Lukas Christiaan
Apo.Manc. Astarloa Echevarrieta Maria

PDF Anuncio nº 310829 de 2021

Datos registrales: T 39819 , F 156, S 8, H M 679704, I/A 14

18

Jun 2021

Revocaciones

Con fecha 18/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Van Vliet Jasper Jan
Apo.Manc. Van Der Heijde Patrick
Apo.Manc. Van Der Donk Wilco Adrianus Wilheimus Maria
Apo.Manc. Van De Werken Arjen
Apo.Manc. Schipper Gerardus Johannes
Apo.Manc. Romero Alonso Francisco
Apo.Manc. Puig Ruano Ursula
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Honing Irma Desiree
Apo.Manc. Hofland Raoul Rene
Apo.Manc. Gonzalez Perez Saul
Apo.Manc. Baaijens Lukas Christiaan
Apo.Manc. Alvarez Llorca Mercedes

PDF Anuncio nº 310829 de 2021

Datos registrales: T 39819 , F 156, S 8, H M 679704, I/A 14

25

May 2021

Nombramientos

Con fecha 25/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Romero Alonso Francisco
Apo.Sol. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Sol. Lopez Casanova Carlos
Apo.Sol. Gonzalez Perez Saul
Apo.Sol. Gescobro Collection Services SL

PDF Anuncio nº 262963 de 2021

Datos registrales: T 34844 , F 105, S 8, H M 585929, I/A 14

21

May 2021

Nombramientos

Con fecha 21/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Romero Alonso Francisco
Apoderado Mato Garcia Agustin Iñigo
Apoderado Lopez Casanova Carlos
Apoderado Gonzalez Perez Saul
Apoderado Gescobro Collection Services SL

PDF Anuncio nº 258288 de 2021

Datos registrales: T 33532 , F 224, S 8, H M 603594, I/A 26

30

Nov 2020

Nombramientos

Con fecha 30/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Van Vliet Jasper Jan
Apo.Manc. Van Der Heijde Patrick
Apo.Manc. Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
Apo.Manc. Van De Werken Arjen
Apo.Manc. Schipper Gerardus Johannes
Apo.Manc. Romero Alonso Francisco
Apo.Manc. Puig Ruano Ursula
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Martinez Miralles Riquelme Ana
Apo.Manc. Honing Irma Desiree
Apo.Manc. Hofland Raoul Rene
Apo.Manc. Gonzalez Perez Saul
Apo.Manc. Baaijens Lukas Christiaan
Apo.Manc. Alvarez Llorca Mercedes

PDF Anuncio nº 430680 de 2020

Datos registrales: T 39819 , F 152, S 8, H M 679704, I/A 11

15

Jun 2020

Revocaciones

Con fecha 15/06/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Mato Garcia Agustin Iñigo

PDF Anuncio nº 189262 de 2020

Datos registrales: T 36454 , F 80, S 8, H M 654964, I/A 18

21

May 2019

Nombramientos

Con fecha 21/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Van Vliet Jasper Jan
Apo.Manc. Van Der Heijde Patrick
Apo.Manc. Van Der Donk Wilco Adrianus Wilheimus Maria
Apo.Manc. Van De Werken Arjen
Apo.Manc. Schipper Gerardus Johannes
Apo.Manc. Romero Alonso Francisco
Apo.Manc. Puig Ruano Ursula
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Honing Irma Desiree
Apo.Manc. Hofland Raoul Rene
Apo.Manc. Gonzalez Perez Saul
Apo.Manc. Baaijens Lukas Christiaan
Apo.Manc. Alvarez Llorca Mercedes

PDF Anuncio nº 226207 de 2019

Datos registrales: T 38197 , F 223, S 8, H M 679704, I/A 6

14

Feb 2019

Revocaciones

Con fecha 14/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado North Clare Louise
Apoderado Mettler Deanna Rae
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apoderado Fernandez Garcia Juan Jose
Apoderado Dobricic Mark David
Apoderado De La Peña Spagnoletta Daniel Enrique
Apo.Manc. Contreras Vicente Daniel
Apo.Man.Soli Alonso Elizo Jose Maria

PDF Anuncio nº 83066 de 2019

Datos registrales: T 27655 , F 204, S 8, H M 434058, I/A 30

20

Nov 2018

Nombramientos

Con fecha 20/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Santos De Betancourt Teresa
Apo.Manc. Sanchez Gascon Lorena
Apo.Manc. Salcedo Molinero Sergio
Apo.Manc. Muños Linde Carlos Alberto
Apo.Manc. Mohamed Benaisa Faisal
Apo.Manc. Medina Cuadros Amelia
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Lopez Casanova Carlos
Apo.Manc. Gonzalez Perez Saul
Apo.Manc. Gomez Lopez Natalia
Apo.Manc. Gimenez Tost Juan
Apo.Manc. Gilperez Garcia Alberto
Apo.Manc. Felez Diaz Raquel
Apo.Manc. Del Monte Perez Alberto
Apo.Manc. Amieva Melendo Guillermo

PDF Anuncio nº 475399 de 2018

Datos registrales: T 1184 , F 194, S 8, H S 1960, I/A 3675

20

Nov 2018

Nombramientos

Con fecha 20/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Santos De Betancourt Teresa
Apo.Sol. Sanchez Gascon Lorena
Apo.Sol. Salcedo Molinero Sergio
Apo.Sol. Muños Linde Carlos Alberto
Apo.Sol. Mohamed Benaisa Faisal
Apo.Sol. Medina Cuadros Amelia
Apo.Sol. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Sol. Lopez Casanova Carlos
Apo.Sol. Gonzalez Perez Saul
Apo.Sol. Gomez Lopez Natalia
Apo.Sol. Gimenez Tost Juan
Apo.Sol. Gilperez Garcia Alberto
Apo.Sol. Felez Diaz Raquel
Apo.Sol. Del Monte Perez Alberto
Apo.Sol. Amieva Melendo Guillermo

PDF Anuncio nº 475397 de 2018

Datos registrales: T 1184 , F 192, S 8, H S 1960, I/A 3673

28

Sep 2018

Ceses/Dimisiones

Con fecha 28/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Miem.Com.Ctr Mato Garcia Agustin Iñigo
Miem.Com.Ctr Jarrin Garcia Carolina

PDF Anuncio nº 401743 de 2018

Datos registrales: T 21964 , F 190, S 8, H M 391402, I/A 37

30

Jul 2018

Nombramientos

Con fecha 30/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Mato Garcia Agustin Iñigo

PDF Anuncio nº 325852 de 2018

Datos registrales: T 36454 , F 61, S 8, H M 654964, I/A 10

04

Jul 2014

Nombramientos

Con fecha 04/07/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Miem.Com.Ctr Tudela Hernandez Julio
Miem.Com.Ctr Mato Garcia Agustin Iñigo
Miem.Com.Ctr Jarrin Garcia Carolina
Miem.Com.Ctr Fernandez Lopez Emilio

PDF Anuncio nº 288633 de 2014

Datos registrales: T 21964 , F 185, S 8, H M 391402, I/A 21

24

Feb 2014

Nombramientos

Con fecha 24/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Sanders Mark David
Consejero Ruiz Lopez Juan Ramon
Consejero Remon Patricio
Apo.Manc. Mato Garcia Agustin Iñigo
Apo.Manc. Franklin Martyn Lee
Apo.Manc. Davis Andrea Jayne
Apo.Manc. Contreras Vicente Daniel
Apo.Manc. Alonso Martinez Carlos

PDF Anuncio nº 101432 de 2014

Datos registrales: T 27655 , F 57, S 8, H M 434058, I/A 19

24

Feb 2014

Revocaciones

Con fecha 24/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Sanders Mark David
Apoderado Saenz Santolaya David
Apoderado Sabatell Martinez Luis
Apoderado Onyett Mark James
Apoderado Montero Aramburu Luis
Apoderado Mato Garcia Agustin Iñigo
Apoderado Incles Jason
Apoderado Fuller Kevin Alexander
Apoderado Franklin Martyn Lee
Apoderado Alfaya Gonzalez Anton
Apoderado Albright Jonathon William

PDF Anuncio nº 101432 de 2014

Datos registrales: T 27655 , F 57, S 8, H M 434058, I/A 19

26

Oct 2011

Nombramientos

Con fecha 26/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Sanders Mark David
Apoderado Saenz Santolaya David
Apoderado Sabatell Martinez Luis
Apoderado Onyett Mark James
Apoderado Montero Aramburu Luis
Apoderado Mato Garcia Agustin Iñigo
Apoderado Incles Jason
Apoderado Franklin Martyn Lee
Apoderado Alfaya Gonzalez Anton
Apoderado Albright Jonathon William

PDF Anuncio nº 441349 de 2011

Datos registrales: T 27655 , F 53, S 8, H M 434058, I/A 14

26

Oct 2011

Revocaciones

Con fecha 26/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Squirrell Robert Alan
Apoderado Sanders Mark David
Apoderado Saenz Santolaya David
Apoderado Onyett Mark James
Apoderado Montero Aramburu Luis
Apoderado Mato Garcia Agustin Iñigo
Apoderado Aranguren Delgado Javier
Apoderado Albright Jonathon William

PDF Anuncio nº 441349 de 2011

Datos registrales: T 27655 , F 53, S 8, H M 434058, I/A 14

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2023-208-28 Madrid 31/10/2023
PDF BORME-A-2023-98-28 Madrid 26/05/2023
PDF BORME-A-2021-244-28 Madrid 23/12/2021
PDF BORME-A-2021-120-28 Madrid 25/06/2021
PDF BORME-A-2021-102-28 Madrid 01/06/2021
PDF BORME-A-2021-100-28 Madrid 28/05/2021
PDF BORME-A-2020-235-28 Madrid 09/12/2020
PDF BORME-A-2020-118-28 Madrid 22/06/2020
PDF BORME-A-2019-99-28 Madrid 28/05/2019
PDF BORME-A-2019-36-28 Madrid 21/02/2019
PDF BORME-A-2018-228-39 Cantabria 28/11/2018
PDF BORME-A-2018-193-28 Madrid 05/10/2018
PDF BORME-A-2018-150-28 Madrid 06/08/2018
PDF BORME-A-2014-130-28 Madrid 11/07/2014
PDF BORME-A-2014-44-28 Madrid 05/03/2014
PDF BORME-A-2011-211-28 Madrid 07/11/2011
PDF BORME-A-2010-85-28 Madrid 06/05/2010
PDF BORME-A-2009-148-28 Madrid 06/08/2009

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret