info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 2
Cargos no vigentes 14
Apariciones en BORME 21
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Man.Soli Distribucion Y Explotacion De Maquinas Automaticas Del Norte SA 28/09/2011 Actualidad
Apo.Man.Soli Trebe Vending SL 26/08/2011 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Man.Soli Pelican Rouge Coffee Solutions SA 14/02/2011 22/08/2013
Apo.Man.Soli Nordis Social Coffee SL 14/02/2011 21/08/2013
Apo.Man.Soli Acorn Spain 1 SL 14/02/2011 21/08/2013
Apoderado Demas SL 02/06/2011 13/08/2013
Apo.Man.Soli Benazahora Cafe SRL 24/05/2011 03/12/2012
Apoderado Autobar Norte SA 25/02/2009 31/01/2012
Apo.Manc. Servicio De Venta Automatica SA 02/08/2011 18/01/2012
Apo.Man.Soli S V D Servicio De Vending Y Distribucion SL 04/10/2011 18/01/2012
Apoderado Pt Logistica Y Comercializacion Vending SL 28/09/2011 18/01/2012
Apoderado Demas SL 02/06/2011 02/06/2011
Apoderado Pelican Rouge Coffee Solutions SA Desconocido 14/02/2011
Apoderado Pelican Rouge Coffee Solutions SA Desconocido 14/02/2011
Apoderado Nordis Social Coffee SL 30/12/2008 14/02/2011
Apoderado Acorn Spain 1 SL Desconocido 14/02/2011
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Greenwood Michael Frank .

22

Ago 2013

Revocaciones

Con fecha 22/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Walford Anthony William Cecil
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James

PDF Anuncio nº 385758 de 2013

Datos registrales: T 28691 , F 225, S 8, H M 61661, I/A 82

21

Ago 2013

Revocaciones

Con fecha 21/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James

PDF Anuncio nº 382783 de 2013

Datos registrales: T 21078 , F 184, S 8, H M 374093, I/A 16

21

Ago 2013

Revocaciones

Con fecha 21/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James

PDF Anuncio nº 382780 de 2013

Datos registrales: T 29474 , F 97, S 8, H M 295720, I/A 13

13

Ago 2013

Revocaciones

Con fecha 13/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James

PDF Anuncio nº 375096 de 2013

Datos registrales: T 4890, L 3798, F 4, S 8, H MA 13085, I/A 27

04

Oct 2011

Nombramientos

Con fecha 04/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Man.Soli Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel
Apo.Man.Soli Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 409679 de 2011

Datos registrales: T 23484 , F 84, S 8, H M 164767, I/A 27

28

Sep 2011

Nombramientos

Con fecha 28/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 400422 de 2011

Datos registrales: T 23579 , F 179, S 8, H M 423126, I/A 8

28

Sep 2011

Nombramientos

Con fecha 28/09/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Sol. Roe Timothy Michael
Apo.Sol. Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Sol. Caballero Alemany Manuel
Apo.Man.Soli Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 399897 de 2011

Datos registrales: T 2204 , F 201, S 8, H SS 6176, I/A 56

26

Ago 2011

Nombramientos

Con fecha 26/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Sol. Lawrie John Graham
Apo.Sol. Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Sol. Caballero Alemany Manuel
Apo.Man.Soli Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 362507 de 2011

Datos registrales: T 1768 , F 76, S 8, H SS 16154, I/A 12

02

Ago 2011

Nombramientos

Con fecha 02/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Wyatt Bristow Andrew
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Man.Soli Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Manc. Greenwood Michael Frank
Apo.Manc. Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 338865 de 2011

Datos registrales: T 26355 , F 39, S 8, H M 24803, I/A 142

02

Jun 2011

Nombramientos

Con fecha 02/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 254743 de 2011

Datos registrales: T 4569, L 3478, F 193, S 8, H MA 13085, I/A 22

02

Jun 2011

Revocaciones

Con fecha 02/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 254743 de 2011

Datos registrales: T 4569, L 3478, F 193, S 8, H MA 13085, I/A 22

02

Jun 2011

Nombramientos

Con fecha 02/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 254742 de 2011

Datos registrales: T 4569, L 3478, F 191, S 8, H MA 13085, I/A 21

24

May 2011

Nombramientos

Con fecha 24/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Sol. Roe Timothy Michael
Vicepresid. Lawrie John Graham
Consejero Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Sol. Caballero Alemany Manuel
Presidente Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 235578 de 2011

Datos registrales: T 1081 , F 96, S 8, H CA 11822, I/A 7

14

Feb 2011

Nombramientos

Con fecha 14/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Wyatt Bristow Andrew
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Man.Soli Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 94306 de 2011

Datos registrales: T 27580 , F 122, S 8, H M 61661, I/A 70

14

Feb 2011

Revocaciones

Con fecha 14/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Wyatt Bristow Andrew
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apo.Sol. Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Drawent James
Apoderado Darwent James
Apo.Sol. Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 94306 de 2011

Datos registrales: T 27580 , F 122, S 8, H M 61661, I/A 70

14

Feb 2011

Nombramientos

Con fecha 14/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Wyatt Bristow Andrew
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Man.Soli Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 87113 de 2011

Datos registrales: T 21078 , F 179, S 8, H M 374093, I/A 12

14

Feb 2011

Revocaciones

Con fecha 14/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 87113 de 2011

Datos registrales: T 21078 , F 179, S 8, H M 374093, I/A 12

14

Feb 2011

Nombramientos

Con fecha 14/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Man.Soli Wyatt Bristow Andrew
Apo.Man.Soli Villalba Diaz Antonio
Apo.Man.Soli Roe Timothy Michael
Apo.Man.Soli Lawrie John Graham
Apo.Man.Soli Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apo.Man.Soli Greenwood Michael Frank
Apo.Man.Soli Darwent James
Apo.Man.Soli Caballero Alemany Manuel

PDF Anuncio nº 87093 de 2011

Datos registrales: T 17254 , F 98, S 8, H M 295720, I/A 7

14

Feb 2011

Revocaciones

Con fecha 14/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Lawrie John Graham
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Greenwood Michael Frank
Apoderado Darwent James
Apoderado Caballero Alemany Manuel
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 87093 de 2011

Datos registrales: T 17254 , F 98, S 8, H M 295720, I/A 7

25

Feb 2009

Nombramientos

Con fecha 25/02/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Villalba Diaz Antonio
Apoderado Roe Timothy Michael
Apoderado Huarte Iribarren Jose Ignacio
Apoderado Herrero Ayestaran Joaquin
Apoderado Greenwood Michael Frank
Consejero Graham Lawrie John
Apoderado Darwent James
Apoderado Bristow Andrew Wyatt

PDF Anuncio nº 117468 de 2009

Datos registrales: T 768 , F 10, S 8, H NA004017, I/A00054

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2013-167-28 Madrid 03/09/2013
PDF BORME-A-2013-165-28 Madrid 30/08/2013
PDF BORME-A-2013-160-29 Málaga 23/08/2013
PDF BORME-A-2011-197-28 Madrid 17/10/2011
PDF BORME-A-2011-192-20 Guipúzcoa 07/10/2011
PDF BORME-A-2011-192-28 Madrid 07/10/2011
PDF BORME-A-2011-170-20 Guipúzcoa 06/09/2011
PDF BORME-A-2011-155-28 Madrid 16/08/2011
PDF BORME-A-2011-113-29 Málaga 14/06/2011
PDF BORME-A-2011-105-11 Cádiz 02/06/2011
PDF BORME-A-2011-42-28 Madrid 02/03/2011
PDF BORME-A-2011-39-28 Madrid 25/02/2011
PDF BORME-A-2009-45-31 Navarra 06/03/2009
PDF BORME-A-2009-8-28 Madrid 14/01/2009

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret