info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 0
Cargos no vigentes 6
Apariciones en BORME 12
Cargos directivos en empresas
Esta persona no tiene ningún cargo en la actualidad, o no hay datos disponibles.
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Sol. Celgene SL 19/04/2023 18/01/2024
Apo.Manc. Celgene Research SL 21/06/2018 12/12/2023
Apo.Manc. Celgene SL 23/10/2017 11/03/2021
Apo.Manc. Celgene Research SL 20/02/2017 21/06/2018
Apo.Manc. Celgene SL 13/07/2016 23/10/2017
Apoderado Salesforce Systems Spain SL 13/06/2013 18/05/2017
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Bonzli Michael Hussein .

18

Ene 2024

Revocaciones

Con fecha 18/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 32 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 41637 de 2024

Datos registrales: T 42435 , F 190, S 8, H M 385890, I/A 87

12

Dic 2023

Revocaciones

Con fecha 12/12/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Schafer Luc
Apo.Manc. Bonzli Michael Hussein

PDF Anuncio nº 547626 de 2023

Datos registrales: T 7008 , F 71, S 8, H SE 84906, I/A 41

19

Abr 2023

Nombramientos

Con fecha 19/04/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Stewart Michael David
Apo.Sol. Solovyov Alexander
Apo.Sol. Bonzli Michael Hussein
Apo.Sol. Ashford Lorna

PDF Anuncio nº 194341 de 2023

Datos registrales: T 42435 , F 186, S 8, H M 385890, I/A 82

11

Mar 2021

Revocaciones

Con fecha 11/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Wuthrich Olivier
Apo.Sol. Stultz Katherine Vega
Apo.Manc. Schafer Luc
Apo.Manc. Ramos Sandra
Apo.Manc. Pignolet David
Apo.Manc. Petremand Anne Claude
Apoderado Pedurthe Lauga Pascal Frederic
Apoderado Mccrossan Maire Amanda Bryn
Apo.Manc. Llamazares Blanco Dina
Apo.Manc. Johannesen Sarah Elizabeth
Apo.Manc. Garcia Medinilla Cristina
Apoderado Garcia Fernandez Jose Luis
Apoderado De Leusse Marie Alain Georges Jean Francois
Apo.Manc. Bonzli Michael Hussein
Apoderado Biller Jonathan Prim

PDF Anuncio nº 128817 de 2021

Datos registrales: T 33691 , F 223, S 8, H M 385890, I/A 55

21

Jun 2018

Nombramientos

Con fecha 21/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Wuthrich Olivier Andre Bernard
Apo.Manc. Walter Pignolet David
Apo.Manc. Villalba Fernandez-Ortega David
Apo.Manc. Schafer Luc
Apo.Manc. Ramos Alves Sandra Maria
Apo.Manc. Oehen Jurg
Apo.Manc. Llamazares Blanco Diana
Apo.Manc. Johannesen Sarah Elizabeth
Apo.Manc. De Leusse Marie Alain Georges Jean Francois
Apo.Manc. David Bradley Michael
Apo.Manc. Carmichael James
Apo.Manc. Bonzli Michael Hussein
Apo.Manc. Biller Jonathan Prim

PDF Anuncio nº 274116 de 2018

Datos registrales: T 6283 , F 202, S 8, H SE 84906, I/A 29

21

Jun 2018

Revocaciones

Con fecha 21/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Wuthrich Olivier
Apo.Manc. Villalba Fernandez-Ortega David
Apo.Manc. Schafer Luc
Apo.Manc. Ramos Sandra
Apo.Manc. Pignolet David
Apo.Manc. Petremand Anne Claude
Apo.Manc. Pedurthe Lauga Pascal Frederic
Apo.Manc. Oehen Jurg
Apo.Manc. Mccrossan Maire Amanda Bryn
Apo.Manc. Johannesen Sarah Elizabeth
Apo.Manc. Endes Gyorgy Janos
Apo.Manc. De Leusse Marie Alain Georges Jean Francois
Apo.Manc. David Bradley Michael
Apo.Manc. Carmichael James
Apo.Manc. Bonzli Michael Hussein

PDF Anuncio nº 274116 de 2018

Datos registrales: T 6283 , F 202, S 8, H SE 84906, I/A 29

23

Oct 2017

Nombramientos

Con fecha 23/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Schafer Luc
Apo.Manc. Llamazares Blanco Dina
Apo.Manc. Bonzli Michael Hussein

PDF Anuncio nº 429272 de 2017

Datos registrales: T 33691 , F 215, S 8, H M 385890, I/A 42

23

Oct 2017

Revocaciones

Con fecha 23/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Schafer Luc
Apo.Manc. Endes Gyorgy Janos
Apo.Manc. Bonzli Michael Hussein

PDF Anuncio nº 429272 de 2017

Datos registrales: T 33691 , F 215, S 8, H M 385890, I/A 42

18

May 2017

Revocaciones

Con fecha 18/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Scott Claire Elizabeth
Apoderado Rhoades Iv Thomas Perry
Apoderado Poulin Emmanuel Jean Jacques
Apoderado Pointet Jane Bernadette
Apo.Sol. Fontanals De Miguel Belen
Apo.Sol. Bustillo Muñoz Cristina
Apoderado Bonzli Michael Hussein
Apo.Sol. Azpitarte Melero Marta

PDF Anuncio nº 220210 de 2017

Datos registrales: T 22872 , F 225, S 8, H M 394078, I/A 28

20

Feb 2017

Nombramientos

Con fecha 20/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Endes Gyorgy Janos
Apo.Manc. Bonzli Michael Hussein

PDF Anuncio nº 101665 de 2017

Datos registrales: T 6283 , F 200, S 8, H SE 84906, I/A 24

13

Jul 2016

Nombramientos

Con fecha 13/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Endes Gyorgy Janos
Apo.Manc. Bonzli Michael Hussein

PDF Anuncio nº 307950 de 2016

Datos registrales: T 33691 , F 214, S 8, H M 385890, I/A 39

13

Jun 2013

Nombramientos

Con fecha 13/06/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Wettermark Joachim
Apoderado Vallotton Samuel
Apoderado Troufanov Ivan Andreevich
Apoderado Rhoades Iv Thomas Perry
Apoderado Poulin Emmanuel Jean Jacques
Apoderado Moura Neto Jose Luiz
Apoderado Jaccottet Stephane Jean Claude Frederic
Apoderado Bonzli Michael Hussein
Apoderado Allen Elizabeth Chow

PDF Anuncio nº 283289 de 2013

Datos registrales: T 22872 , F 221, S 8, H M 394078, I/A 18

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2024-18-28 Madrid 25/01/2024
PDF BORME-A-2023-243-41 Sevilla 26/12/2023
PDF BORME-A-2023-79-28 Madrid 26/04/2023
PDF BORME-A-2021-53-28 Madrid 18/03/2021
PDF BORME-A-2018-124-41 Sevilla 29/06/2018
PDF BORME-A-2017-208-28 Madrid 31/10/2017
PDF BORME-A-2017-98-28 Madrid 26/05/2017
PDF BORME-A-2017-43-41 Sevilla 02/03/2017
PDF BORME-A-2016-141-28 Madrid 26/07/2016
PDF BORME-A-2013-115-28 Madrid 20/06/2013

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret