info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 1
Cargos no vigentes 19
Apariciones en BORME 19
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apoderado Fox Networks Group España SL 25/09/2019 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Sol. The Disney Store Spain SL 28/01/2020 22/06/2023
Apo.Sol. The Disney Store Spain SL 28/01/2020 22/06/2023
Apo.Manc. The Disney Store Spain SL 28/01/2020 22/06/2023
Apo.Manc. The Disney Store Spain SL 28/01/2020 22/06/2023
Apo.Manc. The Disney Store Spain SL 28/01/2020 22/06/2023
Apoderado The Walt Disney Company Iberia SL 07/02/2020 03/06/2023
Apoderado The Walt Disney Company Iberia SL 27/05/2019 03/06/2023
Apoderado The Walt Disney Company Iberia SL 27/05/2019 03/06/2023
Apoderado The Walt Disney Company Iberia SL 27/05/2019 03/06/2023
Apoderado Hispano Foxfilm Sae 26/09/2019 02/07/2020
Apo.Man.Soli Twentieth Century Fox Home Entertainment España SA 25/02/2020 09/06/2020
Apo.Sol. The Disney Store Spain SL 20/08/2019 28/01/2020
Apo.Man.Soli The Disney Store Spain SL 20/08/2019 28/01/2020
Apo.Manc. The Disney Store Spain SL 06/07/2017 20/08/2019
Apo.Manc. The Walt Disney Company Iberia SL 05/07/2017 27/05/2019
Apo.Manc. The Disney Store Spain SL 13/10/2015 06/07/2017
Apo.Manc. The Disney Store Spain SL 30/01/2017 06/07/2017
Apoderado The Walt Disney Company Iberia SL 25/09/2015 05/07/2017
Apoderado Jetix España SL 13/10/2015 07/06/2016
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Belzer Gregory Lee .

03

Jun 2023

Revocaciones

Con fecha 03/06/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Wren Amanda Louise Rachel
Apoderado Woo Show Wing Priscille
Apoderado Steinbach Joerg
Apoderado Smith Matthew Alexander
Apoderado Ortiz Gutierrez Marco Vinicio
Apoderado Guthrie John Willian
Apoderado Grahovac Nevena
Apoderado Graf Michelle L
Apoderado Gombert Michael Roger
Apoderado Belzer Gregory Lee
Apoderado Arbolino Stefanie
Apoderado Amos Estime

PDF Anuncio nº 264536 de 2023

Datos registrales: T 34160 , F 220, S 8, H M 264876, I/A 121

25

Feb 2020

Nombramientos

Con fecha 25/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Rodriguez Marengo Ignacio
Apo.Man.Soli Morais Carneiro Luis Mario
Apo.Man.Soli Meshkova Nadejda Georgieva
Apo.Manc. Martinez Delgado Marta Elena
Apo.Man.Soli Martin Prieto Agustin
Apo.Man.Soli Lopez Perez Josue
Apo.Sol. Esteban Iriarte Jesus
Apo.Sol. Caux Marc Ambroise
Apo.Man.Soli Benyon Gary Mark
Apo.Man.Soli Belzer Gregory Lee
Apo.Sol. Arzu Roderick Sidney
Apo.Sol. Amselem Simon
Apo.Man.Soli Amaro Soteras Jaime
Apo.Man.Soli Aguilar Torres Juan

PDF Anuncio nº 98212 de 2020

Datos registrales: T 27010 , F 206, S 8, H M 75324, I/A 85

07

Feb 2020

Nombramientos

Con fecha 07/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Benyon Gary Mark
Apoderado Belzer Gregory Lee
Apoderado Amaro Soteras Jaime

PDF Anuncio nº 70253 de 2020

Datos registrales: T 34160 , F 147, S 8, H M 264876, I/A 108

28

Ene 2020

Nombramientos

Con fecha 28/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 24 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 51454 de 2020

Datos registrales: T 35211 , F 172, S 8, H M 124110, I/A 87

28

Ene 2020

Revocaciones

Con fecha 28/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Tornos Oliveros Luis
Apoderado Rodriguez Echeverria Leticia
Apo.Manc. Reed Marsha Leigh
Apoderado Pressler Paul
Apo.Sol. Perez Mansilla Delgado Patricia
Apoderado Pastor Gili Ignacio
Apoderado Parker Mark Dudley
Apoderado Parker Dudley Mark
Apoderado Nanula Richard D
Apo.Manc. Murray Linda Michelle
Apoderado Morris Peter Ian
Apo.Sol. Meshkova Nadejda Georgieva
Apo.Sol. Mazaltob Ledicia Benady Ruth
Apo.Sol. Mateo Serrano Alberto Rodrigo
Apo.Manc. Martinez Delgado Marta Elena
Apo.Man.Soli Martin Nieto Agustin
Apo.Sol. Marban Garcia Antonio
Apo.Sol. Mafuz Gumiel Rosa Maria
Apoderado Lima Das Neves De Oliveira Francisco Albero
Apoderado Lilly Mark Russell
Apoderado Levy Jacques
Apoderado Juan Francisco Andres Perez
Apoderado John Gary
Apoderado Hobson John Robert
Apoderado Gulias Roo Jose Manuel
Apo.Sol. Grahovac Nevena
Apo.Sol. Graf Michelle L
Apo.Sol. Gombert Michael Roger
Apo.Sol. Garcia Garcia Antonio Marban
Apoderado Garaboa Lopez Carlos
Apoderado Foreman Mitchell Barnett
Apoderado Forcheiro Roberto
Apo.Sol. Fernandez Garcia Edurne
Apoderado Dominguez Perez Daniel
Apoderado De Oliveira Lima Das Neves Francisco Alberto
Apo.Sol. Crowley Daniel Joseph
Apoderado Cheema Harpreet Singh
Apoderado Cartwright Jacqueline Anne
Apoderado Brown Stuart
Apo.Manc. Bilic Tatjana
Apoderado Bermingham Tracy Anne
Apo.Manc. Benyon Gary Mark
Apoderado Benady Ruth
Apo.Man.Soli Belzer Gregory Lee
Apoderado Asquith Ann
Apo.Sol. Arbolino Stefanie
Apoderado Andres Perez Juan Francisco
Apo.Manc. Amselem Simon
Apo.Sol. Amos Estime
Apo.Man.Soli Amaro Soteras Jaime
Este acto mercantil contiene 78 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 51453 de 2020

Datos registrales: T 35211 , F 166, S 8, H M 124110, I/A 86

26

Sep 2019

Nombramientos

Con fecha 26/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Summers De Orueta Maria
Apoderado Rodriguez Marengo Ignacio
Apoderado Muro Brussi Pedro Manuel
Apoderado Morais Carneiro Luis Mario
Apoderado Meshkova Nadejda Georgieva
Apoderado Martinez Delgado Marta Elena
Apoderado Martin Santo Tomas Raquel
Apoderado Martin Nieto Agustin
Apoderado Marban Garcia Antonio
Apoderado Lopez Perez Josue
Apoderado Benyon Gary Mark
Apoderado Belzer Gregory Lee
Apoderado Arzu Roderick Sidney
Apoderado Amselem Simon
Apoderado Amaro Soleras Jaime

PDF Anuncio nº 411519 de 2019

Datos registrales: T 24996 , F 116, S 8, H M 14564, I/A 64

25

Sep 2019

Nombramientos

Con fecha 25/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Sanchez Almazan Tatiana
Apoderado Morais Carneiro Luis Mario
Apoderado Meshkova Nadejda Georgieva
Apoderado Martinez Delgado Marta Elena
Apoderado Martin Nieto Agustin
Apoderado Marban Garcia Antonio
Apoderado Lopez Perez Josue
Apoderado Benyon Gary Mark
Apoderado Belzer Gregory Lee
Apoderado Amselem Simon
Apoderado Amaro Soteras Jaime
Apoderado Abadia Jimenez Patricia

PDF Anuncio nº 409402 de 2019

Datos registrales: T 31979 , F 223, S 8, H M 268214, I/A 95

20

Ago 2019

Nombramientos

Con fecha 20/08/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Wren Amanda Louise Rachel
Apo.Sol. Woo Show Wing Priscille
Apo.Sol. Timar Fulcher Mimi Valerie
Apo.Sol. Steinbach Joerg
Apo.Sol. Smith Matthew Alexander
Apo.Sol. Ortiz Gutierrez Marco Vinicio
Apo.Man.Soli Morais Carneiro Luis Mario
Apo.Sol. Meshkova Nadejda Georgieva
Apo.Sol. Mark Benyon Gary
Apo.Sol. Marban Garcia Antonio
Apo.Sol. Guthrie John Willian
Apo.Sol. Grahovac Nevena
Apo.Sol. Graf Michelle L
Apo.Sol. Gombert Michael Roger
Apo.Sol. Crowley Daniel Joseph
Apo.Man.Soli Belzer Gregory Lee
Apo.Sol. Arbolino Stefanie
Apo.Sol. Amos Estime

PDF Anuncio nº 370311 de 2019

Datos registrales: T 35211 , F 165, S 8, H M 124110, I/A 84

20

Ago 2019

Revocaciones

Con fecha 20/08/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado De Salas Hermann Eva
Apo.Manc. Benyon Gary Mark
Apo.Manc. Belzer Gregory Lee

PDF Anuncio nº 370311 de 2019

Datos registrales: T 35211 , F 165, S 8, H M 124110, I/A 84

27

May 2019

Revocaciones

Con fecha 27/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Zoradi Mark
Apo.Manc. Widger Andrew Thomas
Apo.Manc. Vila Villar Jose
Apoderado Vasallo Tome Francisco Javier
Apo.Sol. Sourdeau Vincent George Andre
Apoderado Solier Fernandez Diego Adrian
Apo.Man.Soli Sanmartin Antelo Gonzalo
Apo.Man.Soli Sanchez Menendez Ana
Apoderado Salter Stuart
Apo.Man.Soli Romero Barrero Casimiro
Apoderado Rodriguez Etcheverria Leticia
Apoderado Reed Marsha Leigh
Apoderado Ramos Varela Ines
Apoderado Poveda Criado Miguel Angel
Apoderado Perez Mansilla Delgado Patricia
Apo.Sol. Perez Baeza Isabel
Apoderado Olivie Gonzalez Del Rivero Maria Del Carmen
Apoderado Noqueira Rivera David
Apo.Manc. Murray Linda Michelle
Apoderado Muro Brussi Pedro Manuel
Apo.Manc. Mehmood Karim Tariq
Apoderado Mateo Serrano Alberto Rodrigo
Apoderado Martinez Fernandez Luis-Javier
Apoderado Martinez Delgado Marta Elena
Apo.Manc. Martin Nieto Agustin
Apoderado Marti Anton Marisa
Apo.Manc. Marban Garcia Antonio
Apoderado Mafuz Gumiel Rosa Maria
Apoderado Lopez Perez Josue
Apoderado Jongmans Rob
Apoderado Hubay Cebrian Laszlo Isvan
Apoderado Gonzalez Cuin Juan
Apoderado Ezpeleta De La Fuente Marta
Apoderado Esteban Iriarte Jesus
Apoderado De Salas Hermann Eva
Apoderado De Oliveira Lima Das Neves Francisco Alberto
Apo.Manc. Cheema Harpreet Singh
Apoderado Chapman Brett Robert
Apoderado Cendra Aparicio Jose Maria
Apoderado Cebrian Laszlo Istvan Hubay
Apo.Manc. Bilic Tatjana
Apo.Manc. Bermingham Tracy Anne
Apo.Manc. Benyon Gary Mark
Apo.Manc. Belzer Gregory Lee
Apoderado Andres Perez Juan Francisco
Apo.Manc. Amselem Simon
Apoderado Amaro Soteras Jaime
Este acto mercantil contiene 47 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 235528 de 2019

Datos registrales: T 34160 , F 138, S 8, H M 264876, I/A 104

27

May 2019

Nombramientos

Con fecha 27/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Este acto mercantil contiene 36 cargos y solo se muestran los 20 primeros.
PDF Anuncio nº 235527 de 2019

Datos registrales: T 34160 , F 135, S 8, H M 264876, I/A 103

06

Jul 2017

Nombramientos

Con fecha 06/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Obert Alessandra
Apo.Sol. Marban Garcia Antonio
Consejero Bilic Tatjana
Apo.Manc. Benyon Gary Mark
Apo.Manc. Belzer Gregory Lee

PDF Anuncio nº 289252 de 2017

Datos registrales: T 35211 , F 162, S 8, H M 124110, I/A 78

06

Jul 2017

Revocaciones

Con fecha 06/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Widger Andrew Thomas
Apo.Manc. Smith Christofer John Garner
Apo.Manc. Michelle Murray Linda
Apo.Manc. Mehmood Karim Tariq
Apo.Manc. Mateo Serrano Alberto Rodrigo
Apo.Manc. Mark Benyon Gary
Apo.Manc. Marban Garcia Antonio
Apo.Manc. Headley Jonathan Scott
Apo.Manc. Garaboa Lopez Carlos
Apo.Manc. De Salas Hermann Eva
Apoderado Crowley Joseph Daniel
Apo.Sol. Crowley Daniel Joseph
Apo.Manc. Cheema Harpreet Singh
Apo.Manc. Bilic Tatjana
Apo.Manc. Bermingham Tracy Anne
Apo.Manc. Belzer Gregory Lee
Apo.Manc. Amselem Simon
Apo.Manc. Amaro Soteras Jaime

PDF Anuncio nº 289252 de 2017

Datos registrales: T 35211 , F 162, S 8, H M 124110, I/A 78

05

Jul 2017

Nombramientos

Con fecha 05/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Bilic Tatjana
Apo.Manc. Benyon Gary Mark
Apo.Manc. Belzer Gregory Lee

PDF Anuncio nº 286981 de 2017

Datos registrales: T 34160 , F 134, S 8, H M 264876, I/A 100

05

Jul 2017

Revocaciones

Con fecha 05/07/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Widger Andrew Thomas
Apo.Manc. Murray Linda Michelle
Apoderado Mehmood Karim Tariq
Apoderado Mateo Serrano Alberto Rodrigo
Apoderado Marban Garcia Antonio
Apoderado Headley Jonathan Scott
Apo.Manc. De Salas Hermann Eva
Apo.Manc. Cheema Harpreet Singh
Apo.Manc. Bermingham Tracy Anne
Apo.Manc. Benyon Gary Mark
Apoderado Belzer Gregory Lee
Apo.Manc. Amselem Simon
Apoderado Amaro Soteras Jaime

PDF Anuncio nº 286981 de 2017

Datos registrales: T 34160 , F 134, S 8, H M 264876, I/A 100

30

Ene 2017

Nombramientos

Con fecha 30/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Widger Andrew Thomas
Apo.Manc. Reed Marsha Leigh
Apo.Manc. Murray Linda Michelle
Apo.Manc. Mehmood Karim Tariq
Apo.Manc. Mateo Serrano Alberto Rodrigo
Apo.Manc. Martinez Delgado Marta Elena
Apo.Manc. Marban Garcia Antonio
Apo.Manc. Headley Jonathan Scott
Apo.Manc. Garaboa Lopez Carlos
Apo.Manc. De Salas Hermann Eva
Apo.Manc. Cheema Harpreet Singh
Apo.Sol. Bilic Tatjana
Apo.Manc. Bermingham Tracy Anne
Apo.Manc. Benyon Gary Mark
Apo.Manc. Belzer Gregory Lee
Apo.Manc. Amselem Simon
Apo.Manc. Amaro Soteras Jaime

PDF Anuncio nº 61026 de 2017

Datos registrales: T 20907 , F 128, S 8, H M 124110, I/A 77

13

Oct 2015

Nombramientos

Con fecha 13/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Simth Cristopher John Garner
Apoderado Rosso Edgardo
Apoderado Mateo Serrano Alberto Rodrigo
Apoderado Martin Nieto Agustin
Apoderado Marban Garcia Antonio
Apoderado Lopez Perez Josue
Apoderado Headley Jonathan Scott
Apoderado De Salas Hermann Eva
Apoderado Belzer Gregory Lee
Apoderado Amselem Simon
Apoderado Amaro Soteras Jaime

PDF Anuncio nº 422413 de 2015

Datos registrales: T 32787 , F 100, S 8, H M 238194, I/A 38

13

Oct 2015

Nombramientos

Con fecha 13/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Smith Christofer John Garner
Apo.Sol. Rosso Edgardo
Apo.Sol. Reed Marsha Leigh
Apo.Sol. Mateo Serrano Alberto Rodrigo
Apo.Man.Soli Martinez Delgado Marta Elena
Apo.Man.Soli Martin Nieto Agustin
Apo.Manc. Marban Garcia Antonio
Apo.Man.Soli Lopez Perez Josue
Apo.Manc. Headley Jonathan Scott
Apo.Sol. Garaboa Lopez Carlos
Apo.Manc. De Salas Hermann Eva
Apo.Manc. Belzer Gregory Lee
Apo.Manc. Amselem Simon
Apo.Sol. Amaro Soteras Jaime

PDF Anuncio nº 422071 de 2015

Datos registrales: T 20907 , F 124, S 8, H M 124110, I/A 74

25

Sep 2015

Nombramientos

Con fecha 25/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Solier Fernandez Diego Adrian
Apoderado Smith Christopher John Garner
Apoderado Rosso Edgardo
Apoderado Mateo Serrano Alberto Rodrigo
Apoderado Martinez Delgado Marta Elena
Apoderado Martin Nieto Agustin
Apoderado Marban Garcia Antonio
Apoderado Lopez Perez Josue
Apoderado Headley Jonathan Scott
Apoderado Ezpeleta De La Fuente Marta
Apoderado De Salas Hermann Eva
Apoderado Belzer Gregory Lee
Apoderado Amselem Simon
Apoderado Amaro Soteras Jaime

PDF Anuncio nº 399880 de 2015

Datos registrales: T 16505 , F 220, S 8, H M 264876, I/A 93

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2023-109-28 Madrid 12/06/2023
PDF BORME-A-2020-43-28 Madrid 03/03/2020
PDF BORME-A-2020-31-28 Madrid 14/02/2020
PDF BORME-A-2020-23-28 Madrid 04/02/2020
PDF BORME-A-2019-190-28 Madrid 03/10/2019
PDF BORME-A-2019-189-28 Madrid 02/10/2019
PDF BORME-A-2019-163-28 Madrid 27/08/2019
PDF BORME-A-2019-103-28 Madrid 03/06/2019
PDF BORME-A-2017-132-28 Madrid 13/07/2017
PDF BORME-A-2017-131-28 Madrid 12/07/2017
PDF BORME-A-2017-26-28 Madrid 07/02/2017
PDF BORME-A-2015-201-28 Madrid 21/10/2015
PDF BORME-A-2015-190-28 Madrid 05/10/2015

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret