info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a una persona física.

Cargos activos 1
Cargos no vigentes 24
Apariciones en BORME 34
Cargos directivos en empresas
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Consejero Sociedad Gestora De Television Net Tv SA 07/08/2017 Actualidad
Mostrar cargos no vigentes
Cargos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Presidente Viacom International Media Networks España SL 03/04/2013 18/10/2022
Consejero Viacom International Media Networks España SL 18/05/2009 18/10/2022
Con.Delegado Viacom International Media Networks España SL 03/04/2013 18/10/2022
Apoderado Viacom International Media Networks España SL 11/02/2020 18/10/2022
Apoderado Viacom International Media Networks España SL Desconocido 18/10/2022
Presidente Paramount Network España SL 01/04/2013 17/10/2022
Consejero Paramount Network España SL 21/06/2012 17/10/2022
Con.Delegado Paramount Network España SL 01/04/2013 17/10/2022
Apo.Manc. Paramount Network España SL 07/05/2018 17/10/2022
Consejero Sociedad Gestora De Television Net Tv SA 07/03/2012 21/03/2022
Apo.Manc. Viacom International Media Networks España SL 08/05/2018 11/02/2020
Apoderado Viacom International Media Networks España SL 01/07/2013 08/05/2018
Apo.Manc. Paramount Network España SL 08/07/2013 07/05/2018
Presidente Mtv Channel España SL 01/04/2013 03/11/2015
Consejero Mtv Channel España SL 18/05/2009 03/11/2015
Con.Delegado Mtv Channel España SL 01/04/2013 03/11/2015
Apo.Manc. Mtv Channel España SL 04/07/2013 03/11/2015
Apoderado Paramount Network España SL 21/06/2012 08/07/2013
Apo.Manc. Mtv Channel España SL 14/02/2012 04/07/2013
Apoderado Viacom International Media Networks España SL 10/02/2012 01/07/2013
Ver más
person Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Annecchino Raffaele .

18

Oct 2022

Revocaciones

Con fecha 18/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 467576 de 2022

Datos registrales: T 30974 , F 144, S 8, H M 220693, I/A 68

18

Oct 2022

Ceses/Dimisiones

Con fecha 18/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Goller Thomas
Secretario Chames Miguel Sebastian
Presidente Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 467576 de 2022

Datos registrales: T 30974 , F 144, S 8, H M 220693, I/A 68

17

Oct 2022

Revocaciones

Con fecha 17/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Annechino Raffaele
Apo.Manc. Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 464701 de 2022

Datos registrales: T 40110 , F 224, S 8, H M 537803, I/A 35

17

Oct 2022

Ceses/Dimisiones

Con fecha 17/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
VsecrNoConsj Palomo Duran Francisco Javier
Consejero Goller Thomas
SecreNoConsj Chames Miguel Sebastian
Consejero Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 464701 de 2022

Datos registrales: T 40110 , F 224, S 8, H M 537803, I/A 35

21

Mar 2022

Ceses/Dimisiones

Con fecha 21/03/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Vocento Gestion De Medios Y Servicios SL
Consejero The Walt Disney Company LTD
Consejero The Walt Disney Company Iberia SL
VsecrNoConsj Molowny Marquez Lourdes
Consejero Iribarnegaray Olaso Iñigo
Consejero Gidron Sanchez Daniel
Secretario Blanco Gomez Enrique
Vicesecret. Ayuela De Rueda Maria
Consejero Argaya Amigo Iñigo
Presidente Arechabaleta Torrontegui Iñaki
Consejero Annecchino Raffaele
Representan Amselem Simon
Representan Amaro Soteras Jaime

PDF Anuncio nº 136114 de 2022

Datos registrales: T 34541 , F 217, S 8, H M 237828, I/A 69

11

Feb 2020

Nombramientos

Con fecha 11/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Zeiger Susan
Apoderado Vicente Rangel Carmen
Apoderado Thompson Jonathan
Apoderado Sharma Natasha
Apoderado Margaret Jeane
Apoderado Kushner Jay
Apoderado Hurd Nick
Apoderado Herdin Jenifer
Apoderado Goller Thomas
Apoderado Gill-Charest Katherine
Apoderado Gil Antoñanzas Manuel
Apoderado Foley Brooke
Apoderado Delgado Aguiar Jose Maria
Apoderado Davis Wade
Apoderado Converse Lou
Apoderado Briggs Audra
Apoderado Bombassei James
Apoderado Bognar Gergely
Apoderado Bedrossian Catalina
Apoderado Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 74477 de 2020

Datos registrales: T 30974 , F 138, S 8, H M 220693, I/A 59

11

Feb 2020

Revocaciones

Con fecha 11/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vicente Rangel Carmen
Apo.Manc. Kushner Jay
Apo.Manc. Herdin Jenifer
Apo.Manc. Goller Thomas
Apo.Manc. Gill-Charest Katherine
Apo.Manc. Gil Antoñanzas Manuel
Apo.Manc. Foley Brooke
Apo.Manc. Delgado Aguiar Jose Maria
Apo.Manc. Davis Wade
Apo.Manc. Converse Lou
Apo.Manc. Bombassei James
Apo.Manc. Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 74477 de 2020

Datos registrales: T 30974 , F 138, S 8, H M 220693, I/A 59

08

May 2018

Nombramientos

Con fecha 08/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vicente Rangel Carmen
Apo.Manc. Kushner Jay
Apo.Manc. Herdin Jenifer
Apo.Manc. Goller Thomas
Apo.Manc. Gill-Charest Katherine
Apo.Manc. Gil Antoñanzas Manuel
Apo.Manc. Foley Brooke
Apo.Manc. Delgado Aguiar Jose Maria
Apo.Manc. Davis Wade
Apo.Manc. Converse Lou
Apo.Manc. Bombassei James
Apo.Manc. Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 208339 de 2018

Datos registrales: T 30974 , F 135, S 8, H M 220693, I/A 53

08

May 2018

Revocaciones

Con fecha 08/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vicente Rangel Carmen
Apoderado Toth Balasz
Apoderado Smith Mark Alistair
Apoderado Rourke Paul
Apoderado Nelson George S
Apoderado Meier Jason Karl
Apoderado Kushner Jay
Apoderado Husein Mahmud Sadrudin Kasam
Apoderado Goller Thomas
Apoderado Gill-Charest Katherine M
Apoderado Gil Antoñanzas Manuel
Apoderado Dooley Thomas E
Apoderado Davis Wade Cullen
Apoderado Connor Elaine Mary
Apoderado Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 208339 de 2018

Datos registrales: T 30974 , F 135, S 8, H M 220693, I/A 53

07

May 2018

Nombramientos

Con fecha 07/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vicente Rangel Carmen
Apo.Manc. Kushner Jay
Apo.Manc. Herdin Jenifer
Apo.Manc. Goller Thomas
Apo.Manc. Gill-Charest Katherine
Apo.Manc. Gil Antoñanzas Manuel
Apo.Manc. Foley Brooke
Apo.Manc. Delgado Aguiar Jose Maria
Apo.Manc. Davis Wade
Apo.Manc. Converse Lou
Apo.Manc. Bombassei James
Apo.Manc. Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 204654 de 2018

Datos registrales: T 34106 , F 219, S 8, H M 537803, I/A 20

07

May 2018

Revocaciones

Con fecha 07/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vicente Rangel Carmen
Apo.Manc. Toth Balasz
Apo.Manc. Smith Mark Alistair
Apo.Manc. Rourke Paul
Apo.Manc. Nelson George S
Apo.Manc. Meier Jason Karl
Apo.Manc. Kushner Jay
Apo.Manc. Husein Mahmud Sadrudin Kasam
Apo.Manc. Goller Thomas
Apo.Manc. Gill-Charest Katherine M
Apo.Manc. Gil Antoñanzas Manuel
Apo.Manc. Dooley Thomas E
Apo.Manc. Davis Wade Cullen
Apo.Manc. Converse Lou A
Apo.Manc. Connor Elaine Mary
Apo.Manc. Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 204654 de 2018

Datos registrales: T 34106 , F 219, S 8, H M 537803, I/A 20

07

Ago 2017

Reelecciones

Con fecha 07/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Consejero Enriquez Nistal Luis
Consejero Blanco Gomez Enrique
Consejero Arechabaleta Torrontegui Iñaki
Consejero Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 340403 de 2017

Datos registrales: T 34541 , F 211, S 8, H M 237828, I/A 56

08

Jul 2013

Nombramientos

Con fecha 08/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vicente Rangel Carmen
Apo.Manc. Toth Balasz
Apo.Manc. Smith Mark Alistair
Apo.Manc. Rourke Paul
Apo.Manc. Nelson George S
Apo.Manc. Meier Jason Karl
Apo.Manc. Kushner Jay
Apo.Manc. Husein Mahmud Sadrudin Kasam
Apo.Manc. Goller Thomas
Apo.Manc. Gill-Charest Katherine M
Apo.Manc. Gil Antoñanzas Manuel
Apo.Manc. Dooley Thomas E
Apo.Manc. Davis Wade Cullen
Apo.Manc. Converse Lou A
Apo.Manc. Connor Elaine Mary
Apo.Manc. Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 320781 de 2013

Datos registrales: T 29885 , F 213, S 8, H M 537803, I/A 9

08

Jul 2013

Revocaciones

Con fecha 08/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vicente Rangel Carmen
Apoderado Smith Mark Alistair
Apoderado Rourke Paul
Apoderado Goller Thomas
Apoderado Campo Dall'Orto Antonio
Apoderado Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 320781 de 2013

Datos registrales: T 29885 , F 213, S 8, H M 537803, I/A 9

04

Jul 2013

Nombramientos

Con fecha 04/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vicente Rangel Carmen
Apo.Manc. Toth Balasz
Apo.Manc. Smith Mark Alistair
Apo.Manc. Rourke Paul
Apo.Manc. Nelson George S
Apo.Manc. Meier Jason Karl
Apo.Manc. Kushner Jay
Apo.Manc. Husein Mahmud Sadrudin Kasam
Apo.Manc. Goller Thomas
Apo.Manc. Gill-Charest Katherine M
Apo.Manc. Gil Antoñanzas Manuel
Apo.Manc. Dooley Thomas E
Apo.Manc. Davis Wade Cullen
Apo.Manc. Converse Lou A
Apo.Manc. Connor Elaine May
Apo.Manc. Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 317288 de 2013

Datos registrales: T 16227 , F 206, S 8, H M 275297, I/A 28

04

Jul 2013

Revocaciones

Con fecha 04/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Vicente Rangel Carmen
Apo.Manc. Smith Mark Alistair
Apo.Manc. Rourke Paul
Apo.Manc. Golle Thomas
Apo.Manc. Campo Dall'Orto Antonio
Apo.Manc. Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 317288 de 2013

Datos registrales: T 16227 , F 206, S 8, H M 275297, I/A 28

01

Jul 2013

Nombramientos

Con fecha 01/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vicente Rangel Carmen
Apoderado Toth Balasz
Apoderado Rourke Paul
Apoderado Nelson George S
Apoderado Meier Jason Karl
Apoderado Kushner Jay
Apoderado Husein Mahmud Sadrudin Kasam
Apoderado Goller Thomas
Apoderado Gill-Charest Katherine M
Apoderado Gil Antoñanzas Manuel
Apoderado Dooley Thomas E
Apoderado Davis Wade Cullen
Apoderado Converse Lou A
Apoderado Connor Elaine Mary
Apoderado Annecchino Raffaele
Apoderado Alistair Smith Mark

PDF Anuncio nº 313331 de 2013

Datos registrales: T 30974 , F 125, S 8, H M 220693, I/A 36

01

Jul 2013

Revocaciones

Con fecha 01/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Vicente Rangel Carmen
Apoderado Rourke Paul
Apoderado Goller Thomas
Apoderado Campo Dallorto Antonio
Apoderado Annecchino Raffaele
Apoderado Alistair Smith Mark

PDF Anuncio nº 313331 de 2013

Datos registrales: T 30974 , F 125, S 8, H M 220693, I/A 36

03

Abr 2013

Nombramientos

Con fecha 03/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Vicesecret. Palomo Duran Francisco Javier
Consejero Connor Elaine Mary
Presidente Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 168771 de 2013

Datos registrales: T 18350 , F 108, S 8, H M 220693, I/A 33

01

Abr 2013

Nombramientos

Con fecha 01/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
VsecrNoConsj Palomo Duran Francisco Javier
Consejero Connor Elaine Mary
Presidente Annecchino Raffaele

PDF Anuncio nº 166274 de 2013

Datos registrales: T 16227 , F 204, S 8, H M 275297, I/A 25

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2022-204-28 Madrid 25/10/2022
PDF BORME-A-2022-203-28 Madrid 24/10/2022
PDF BORME-A-2022-60-28 Madrid 28/03/2022
PDF BORME-A-2020-33-28 Madrid 18/02/2020
PDF BORME-A-2018-93-28 Madrid 17/05/2018
PDF BORME-A-2018-91-28 Madrid 14/05/2018
PDF BORME-A-2017-157-28 Madrid 18/08/2017
PDF BORME-A-2013-133-28 Madrid 16/07/2013
PDF BORME-A-2013-131-28 Madrid 12/07/2013
PDF BORME-A-2013-129-28 Madrid 10/07/2013
PDF BORME-A-2013-67-28 Madrid 10/04/2013
PDF BORME-A-2013-66-28 Madrid 09/04/2013
PDF BORME-A-2012-125-28 Madrid 03/07/2012
PDF BORME-A-2012-124-28 Madrid 02/07/2012
PDF BORME-A-2012-55-28 Madrid 20/03/2012
PDF BORME-A-2012-39-28 Madrid 24/02/2012
PDF BORME-A-2012-37-28 Madrid 22/02/2012
PDF BORME-A-2009-192-28 Madrid 07/10/2009
PDF BORME-A-2009-191-28 Madrid 06/10/2009
PDF BORME-A-2009-99-28 Madrid 28/05/2009

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret