Última actualización: 29 de Junio de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B65288193 |
Provincia | Barcelona |
Fecha de constitución | 15 de Abril de 2010 (hace 14 años) |
Domicilio | Pz De La Sardana Num.4 (Manlleu) |
Objeto social | La promocion y desarrollo de proyectos urbanisticos, la adquisicion, construccion, venta, rehabilitacion, enajenacion y arrendamiento de inmuebles,suexplotacion en cualquier otra forma admitida en derecho, etc. |
Capital social | 2.934.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPR.143 RRM | Oller Campdelacreu Jordi | 25/05/2020 | Actualidad |
ADM.UNICO | Finausa Inversions SL | 25/05/2020 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM.SOLIDAR. | Palomar Gutierrez Ivan | 02/12/2014 | 25/05/2020 |
REPR.143 RRM | Oller Campdelacreu Jordi | 02/12/2014 | 25/05/2020 |
ADM.SOLIDAR. | Finausa Inversions SL | 02/12/2014 | 25/05/2020 |
SECRETARIO | Vila Pujol Roger | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Vila Pujol Roger | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Suñe Casas Irene | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
REPR.143 RRM | Ruiz Carrillo Diego | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Promotora Del Valles SL | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Palomar Gutierrez Ivan | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Oller Campdelacreu Jordi | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONS. DELEG. | Oller Campdelacreu Jordi | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Novellas Ferrer Josep | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Inverpro Desenvolupament SL | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
REPR.143 RRM | Gomez Silva Maria Francisca | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Baulenas Serrat Enrique | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
PRESIDENTE | Arnaus Sitja Joan | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Arnaus Sitja Joan | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONS. DELEG. | Arnaus Sitja Joan | 19/05/2011 | 02/12/2014 |
CONSEJERO | Oller Campdelacreu Jordi | 15/04/2010 | 19/05/2011 |
CONSEJERO | Arnaus Sitja Joan | 15/04/2010 | 19/05/2011 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Vic Convent SL.
29
Jun 2021
Con fecha 29/06/2021, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 34.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 1.17% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 2.934.000,0€.
Datos registrales: T 42078 , F 79, S 8, H B 398594, I/A 11
29
Jun 2021
Con fecha 29/06/2021, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 500.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 20.83% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 2.900.000,0€.
Datos registrales: T 42078 , F 79, S 8, H B 398594, I/A 11
01
Abr 2021
Con fecha 01/04/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. REGIMEN DE TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES POR ACTOS "INTER VIVOS".
Datos registrales: T 42078 , F 78, S 8, H B 398594, I/A 10
25
May 2020
Con fecha 25/05/2020, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 11, 18 Y 19 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 41831 , F 149, S 8, H B 398594, I/A 9
25
May 2020
Con fecha 25/05/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Oller Campdelacreu Jordi |
ADM.UNICO | Finausa Inversions SL |
Datos registrales: T 41831 , F 149, S 8, H B 398594, I/A 9
25
May 2020
Con fecha 25/05/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.SOLIDAR. | Palomar Gutierrez Ivan |
REPR.143 RRM | Oller Campdelacreu Jordi |
ADM.SOLIDAR. | Finausa Inversions SL |
Datos registrales: T 41831 , F 149, S 8, H B 398594, I/A 9
07
Jun 2016
Con fecha 07/06/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 8 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. REGIMEN DE TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES.
Datos registrales: T 41831 , F 149, S 8, H B 398594, I/A 8
28
Ene 2015
Con fecha 28/01/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART.12.- JUNTA GENERAL.
Datos registrales: T 41831 , F 148, S 8, H B 398594, I/A 7
02
Dic 2014
Con fecha 02/12/2014, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION ARTS.8,11,18,19,DEJANDO SIN CONTENIDO LOS ARTS. 20,21,22,24. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.
Datos registrales: T 41831 , F 147, S 8, H B 398594, I/A 6
02
Dic 2014
Con fecha 02/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.SOLIDAR. | Palomar Gutierrez Ivan |
REPR.143 RRM | Oller Campdelacreu Jordi |
ADM.SOLIDAR. | Finausa Inversions SL |
Datos registrales: T 41831 , F 147, S 8, H B 398594, I/A 6
02
Dic 2014
Con fecha 02/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Vila Pujol Roger |
CONSEJERO | Suñe Casas Irene |
REPR.143 RRM | Ruiz Carrillo Diego |
CONSEJERO | Promotora Del Valles SL |
CONSEJERO | Palomar Gutierrez Ivan |
CONSEJERO | Oller Campdelacreu Jordi |
CONSEJERO | Novellas Ferrer Josep |
CONSEJERO | Inverpro Desenvolupament SL |
REPR.143 RRM | Gomez Silva Maria Francisca |
CONSEJERO | Baulenas Serrat Enrique |
PRESIDENTE | Arnaus Sitja Joan |
Datos registrales: T 41831 , F 147, S 8, H B 398594, I/A 6
19
May 2011
Con fecha 19/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Oller Campdelacreu Jordi |
CONS. DELEG. | Arnaus Sitja Joan |
Datos registrales: T 41831 , F 145, S 8, H B 398594, I/A 5
19
May 2011
Con fecha 19/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECRETARIO | Vila Pujol Roger |
PRESIDENTE | Arnaus Sitja Joan |
Datos registrales: T 41831 , F 145, S 8, H B 398594, I/A 4
19
May 2011
Con fecha 19/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Vila Pujol Roger |
CONSEJERO | Suñe Casas Irene |
REPR.143 RRM | Ruiz Carrillo Diego |
CONSEJERO | Promotora Del Valles SL |
CONSEJERO | Palomar Gutierrez Ivan |
CONSEJERO | Oller Campdelacreu Jordi |
CONSEJERO | Novellas Ferrer Josep |
CONSEJERO | Inverpro Desenvolupament SL |
REPR.143 RRM | Gomez Silva Maria Francisca |
CONSEJERO | Baulenas Serrat Enrique |
CONSEJERO | Arnaus Sitja Joan |
Datos registrales: T 41831 , F 144, S 8, H B 398594, I/A 3
19
May 2011
Con fecha 19/05/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Vila Pujol Roger |
CONSEJERO | Suñe Casas Irene |
CONSEJERO | Sala Folguera Francesc |
CONSEJERO | Palomar Gutierrez Ivan |
CONS. DELEG. | Oller Campdelacreu Jordi |
CONSEJERO | Novellas Ferrer Josep |
CONS. DELEG. | Arnaus Sitja Joan |
Datos registrales: T 41831 , F 144, S 8, H B 398594, I/A 3
19
May 2011
Con fecha 19/05/2011, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 12: JUNTA GENERAL.ARTICULO 18: CONSEJO DE ADMINISTRACION. ARTICULO 20:DISTRIBUCION DE CARGOS. ARTICULO 21: CONVOCATORIA Y CONSTITUCION DEL CONSEJO. ARTICULO 22: ADOPCION DE ACUERDOS.
Datos registrales: T 41831 , F 141, S 8, H B 398594, I/A 2
19
May 2011
Con fecha 19/05/2011, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 600.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 33.33% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 2.400.000,0€.
Datos registrales: T 41831 , F 141, S 8, H B 398594, I/A 2
15
Abr 2010
Con fecha 15/04/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Vila Pujol Roger |
CONSEJERO | Suñe Casas Irene |
CONSEJERO | Sala Folguera Francesc |
CONSEJERO | Palomar Gutierrez Ivan |
CONS. DELEG. | Oller Campdelacreu Jordi |
SECRETARIO | Novellas Ferrer Josep |
CONS. DELEG. | Arnaus Sitja Joan |
Datos registrales: T 41831 , F 132, S 8, H B 398594, I/A 1
15
Abr 2010
Con fecha 15/04/2010 se constituye la empresa mediante escritura pública.
La empresa se crea con un capital social inicial de 1.800.000,0 euros e inicia su actividad el 01/03/2010.
El domicilio social en el momento de su constitución se establece en PZ DE LA SARDANA Num.4 (MANLLEU).
La empresa indica que su actividad es LA PROMOCION Y DESARROLLO DE PROYECTOS URBANISTICOS, LA ADQUISICION, CONSTRUCCION, VENTA, REHABILITACION, ENAJENACION Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES,SUEXPLOTACION EN CUALQUIER OTRA FORMA ADMITIDA EN DERECHO, ETC..
Datos registrales: T 41831 , F 132, S 8, H B 398594, I/A 1
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-128-08 | Barcelona | 07/07/2021 |
BORME-A-2021-68-08 | Barcelona | 13/04/2021 |
BORME-A-2020-103-08 | Barcelona | 01/06/2020 |
BORME-A-2016-114-08 | Barcelona | 16/06/2016 |
BORME-A-2015-23-08 | Barcelona | 04/02/2015 |
BORME-A-2014-236-08 | Barcelona | 11/12/2014 |
BORME-A-2011-104-08 | Barcelona | 01/06/2011 |
BORME-A-2010-80-08 | Barcelona | 29/04/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades