Última actualización: 19 de Enero de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B64594427 |
Denominación anterior | Notro Productions SL |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Cl Pujades 81-83 (Barcelona). |
Motivo de la disolución | Judicial. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERADO | Ruiz De Marcos Saul | 16/03/2011 | 19/01/2021 |
APODERADO | Prieto Sacristan Jesus | 07/08/2009 | 19/01/2021 |
APODERADO | Pastor Fernandez Marta | 27/04/2012 | 19/01/2021 |
APODERADO | Monzon Fueyo Manuel | 07/08/2009 | 19/01/2021 |
REP.ADM.CONC | Lopez-Guerrero De Vivar Javier | 19/11/2014 | 19/01/2021 |
APODERADO | Lopez Van Dam Lorenzo Luis | 06/02/2013 | 19/01/2021 |
REPR.143 RRM | Garcia Duran De Bayo Manuel | 27/04/2012 | 19/01/2021 |
APODERADO | Garcia De La Vega Ysasi Ysasmendi Alejandro | 27/04/2012 | 19/01/2021 |
APODERADO | Bergareche Mendoza Nicolas | 16/03/2011 | 19/01/2021 |
APODERADO | Bardo Ortega Alfonso | 06/02/2013 | 19/01/2021 |
ADM.CONCURS. | Account Control-Ius&Aequitas Administradores Concu | 19/11/2014 | 19/01/2021 |
ADM.UNICO | Vertice Contenidos SL | 27/04/2012 | 23/11/2016 |
APODERADO | Pastor Fernandez Marta | 07/08/2009 | 06/02/2013 |
APODERADO | Lopez Luna Eduardo | 27/04/2012 | 06/02/2013 |
APODERADO | Garcia De La Vega Ysasi Ysasmendi Alejandro | 16/03/2011 | 06/02/2013 |
APODERADO | Bardo Ortega Alfonso | 27/04/2012 | 06/02/2013 |
APODERADO | Rubio Bernal Daniel | 16/03/2011 | 27/04/2012 |
REPR.143 RRM | Prieto Sacristan Jesus | 17/06/2010 | 27/04/2012 |
APODERADO | Lopez Luna Eduardo | 16/03/2011 | 27/04/2012 |
APODERADO | Bergareche Mendoza Nicolas | 07/08/2009 | 27/04/2012 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Vertice Films SL.
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 43130 , F 207, S 8, H B 352824, I/A 23
19
Ene 2021
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE MADRID, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 642/2014, AUTO FIRME DE FECHA 14/12/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43130 , F 207, S 8, H B 352824, I/A 23
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REP.ADM.CONC | Lopez-Guerrero De Vivar Javier |
ADM.CONCURS. | Account Control-Ius&Aequitas Administradores Concu |
Datos registrales: T 43130 , F 207, S 8, H B 352824, I/A 23
04
May 2017
JUZGADO MERCANTIL 5 DE MADRID, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 642/2014, AUTO FIRME DE FECHA 24/11/2016, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION.
Datos registrales: T 43130 , F 206, S 8, H B 352824, I/A 22
23
Nov 2016
Con fecha 23/11/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Judicial.
Datos registrales: T 43130 , F 206, S 8, H B 352824, I/A 21
23
Nov 2016
JUZGADO MERCANTIL 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 642/2014, AUTO FIRME DE FECHA 04/07/2016, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43130 , F 206, S 8, H B 352824, I/A 21
23
Nov 2016
Con fecha 23/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Vertice Contenidos SL |
Datos registrales: T 43130 , F 206, S 8, H B 352824, I/A 21
01
Abr 2015
CONVERSION EN INSCRIPCION DE LA ANOTACION PREVENTIVA LETRA A,DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO,DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL Y DE ACUMULACION DEL CONCURSO AL DE LA SOCIEDAD "VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS SA".
Datos registrales: T 43130 , F 206, S 8, H B 352824, I/A 20
19
Nov 2014
J.M. 5 MADRID,CONCURSO VOLUNTARIO 642/2014, AUTO NO FIRME DE FECHA 10/10/2014, ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y ACUMULACION DEL CONCURSO AL DE LA SOCIEDAD VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS SA.
Datos registrales: T 43130 , F 204, S 8, H B 352824, I/A A
19
Nov 2014
Con fecha 19/11/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REP.ADM.CONC | Lopez-Guerrero De Vivar Javier |
ADM.CONCURS. | Account Control-Ius&Aequitas Administradores Concu |
Datos registrales: T 43130 , F 204, S 8, H B 352824, I/A A
06
Feb 2013
Con fecha 06/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Lopez Van Dam Lorenzo Luis |
APODERADO | Bardo Ortega Alfonso |
Datos registrales: T 43130 , F 202, S 8, H B 352824, I/A 19
06
Feb 2013
Con fecha 06/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Pastor Fernandez Marta |
APODERADO | Lopez Luna Eduardo |
APODERADO | Garcia De La Vega Ysasi Ysasmendi Alejandro |
APODERADO | Bardo Ortega Alfonso |
Datos registrales: T 43130 , F 202, S 8, H B 352824, I/A 19
27
Abr 2012
Con fecha 27/04/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Rubio Bernal Daniel |
APODERADO | Lopez Luna Eduardo |
APODERADO | Garcia De La Vega Ysasi Ysasmendi Alejandro |
APODERADO | Esteve Aviles Antoni |
APODERADO | Bergareche Mendoza Nicolas |
Datos registrales: T 43130 , F 202, S 8, H B 352824, I/A 18
27
Abr 2012
Con fecha 27/04/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Pastor Fernandez Marta |
APODERADO | Lopez Luna Eduardo |
APODERADO | Garcia De La Vega Ysasi Ysasmendi Alejandro |
APODERADO | Bardo Ortega Alfonso |
Datos registrales: T 41283 , F 149, S 8, H B 352824, I/A 17
27
Abr 2012
Con fecha 27/04/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Vertice Contenidos SL |
REPR.143 RRM | Garcia Duran De Bayo Manuel |
Datos registrales: T 41283 , F 149, S 8, H B 352824, I/A 16
27
Abr 2012
Con fecha 27/04/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | Vertice Cine SL |
REPR.143 RRM | Prieto Sacristan Jesus |
Datos registrales: T 41283 , F 149, S 8, H B 352824, I/A 16
01
Dic 2011
Con fecha 01/12/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Ruiz De Marcos Saul |
Datos registrales: T 41283 , F 149, S 8, H B 352824, I/A 15
02
Ago 2011
Con fecha 02/08/2011, la sociedad cambia su domicilio social a CL PUJADES 81-83 (BARCELONA).
Datos registrales: T 41283 , F 148, S 8, H B 352824, I/A 14
04
Abr 2011
CAMBIO DE SOCIO UNICO, NUEVO SOCIO:VERTICE CINE SL.
Datos registrales: T 41283 , F 148, S 8, H B 352824, I/A 13
16
Mar 2011
Con fecha 16/03/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Ruiz De Marcos Saul |
APODERADO | Rubio Bernal Daniel |
APODERADO | Lopez Luna Eduardo |
APODERADO | Garcia De La Vega Ysasi Ysasmendi Alejandro |
APODERADO | Esteve Aviles Antoni |
APODERADO | Bergareche Mendoza Nicolas |
Datos registrales: T 41283 , F 147, S 8, H B 352824, I/A 12
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2021-16-08 | Barcelona | 26/01/2021 |
BORME-A-2017-87-08 | Barcelona | 10/05/2017 |
BORME-A-2016-228-08 | Barcelona | 30/11/2016 |
BORME-A-2015-67-08 | Barcelona | 10/04/2015 |
BORME-A-2014-226-08 | Barcelona | 26/11/2014 |
BORME-A-2013-32-08 | Barcelona | 15/02/2013 |
BORME-A-2012-88-08 | Barcelona | 10/05/2012 |
BORME-A-2011-237-08 | Barcelona | 16/12/2011 |
BORME-A-2011-153-08 | Barcelona | 11/08/2011 |
BORME-A-2011-73-08 | Barcelona | 14/04/2011 |
BORME-A-2011-60-08 | Barcelona | 28/03/2011 |
BORME-A-2010-133-08 | Barcelona | 14/07/2010 |
BORME-A-2010-122-08 | Barcelona | 29/06/2010 |
BORME-A-2010-89-08 | Barcelona | 12/05/2010 |
BORME-A-2009-227-08 | Barcelona | 27/11/2009 |
BORME-A-2009-220-08 | Barcelona | 18/11/2009 |
BORME-A-2009-157-08 | Barcelona | 19/08/2009 |
BORME-A-2009-125-08 | Barcelona | 06/07/2009 |
BORME-A-2009-118-08 | Barcelona | 25/06/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades