Última actualización: 7 de Noviembre de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 5 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A97044580 |
Provincia | Valencia |
Domicilio | C/ Dr. Lluch 2 4 (Valencia). |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Martinez Sanchez Gema Matilde | 19/07/2012 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Martin Franco Jorge | 31/07/2020 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Herreruela Tellez Marta Isabel | 31/07/2020 | 07/11/2022 |
Auditor | Grant Thornton SLP | 13/12/2012 | 07/11/2022 |
Auditor | Grant Thornton SLP | 30/09/2013 | 07/11/2022 |
Auditor | Grant Thornton SLP | 30/09/2011 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Tojo Andres | 31/07/2020 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Gomez De Salazar De Viana Belen | 31/07/2020 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Diaz Larrieta Koldobika | 31/07/2020 | 07/11/2022 |
Adm. Unico | Berge Infraestructuras Y Servicios Logisticos SL | 30/07/2019 | 07/11/2022 |
Adm. Unico | Berge Infraestructuras Y Servicios Logisticos SL | 28/04/2009 | 07/11/2022 |
Adm. Unico | Berge Infraestructuras Y Servicios Logisticos SL | 30/04/2014 | 07/11/2022 |
Auditor | Audihispana Grant Thornton SLP | 24/09/2010 | 07/11/2022 |
Auditor | Audihispana Grant Thornton SLP | 12/02/2010 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Arredondo Portilla Ainhoa | 31/07/2020 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Aguirre Oloriz Ignacio | 31/07/2020 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Aguirre Aguirrezabal Juan | 31/07/2020 | 07/11/2022 |
Apo.Man.Soli | Herreruela Tellez Marta Isabel | 01/06/2016 | 11/11/2021 |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Tojo Andres | 14/06/2011 | 11/11/2021 |
Apo.Man.Soli | Diaz Larrieta Koldobika | 01/06/2016 | 11/11/2021 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Velice Logistica SA.
07
Nov 2022
Con fecha 07/11/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 113, S 8, H V 76132, I/A 147
07
Nov 2022
Con fecha 07/11/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 113, S 8, H V 76132, I/A 147
11
Nov 2021
Con fecha 11/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Herreruela Tellez Marta Isabel |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Tojo Andres |
Apo.Man.Soli | Gomez De Salazar De Viana Belen |
Apo.Man.Soli | Diaz Larrieta Koldobika |
Apo.Man.Soli | Bello Alvarez Alicia |
Apo.Man.Soli | Arredondo Portilla Ainhoa |
Apo.Man.Soli | Aguirre Oloriz Ignacio |
Apo.Man.Soli | Aguirre Aguirrezabal Juan |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 113, S 8, H V 76132, I/A 146
02
Dic 2020
Con fecha 02/12/2020, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Articulo 13 de los Estatutos, modificado.
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 113, S 8, H V 76132, I/A 145
31
Jul 2020
Con fecha 31/07/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias BERGE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS LOGISTICOS SL.
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 113, S 8, H V 76132, I/A 144
31
Jul 2020
Con fecha 31/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Martin Franco Jorge |
Apo.Man.Soli | Herreruela Tellez Marta Isabel |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Tojo Andres |
Apo.Man.Soli | Gomez De Salazar De Viana Belen |
Apo.Man.Soli | Diaz Larrieta Koldobika |
Apo.Man.Soli | Arredondo Portilla Ainhoa |
Apo.Man.Soli | Aguirre Oloriz Ignacio |
Apo.Man.Soli | Aguirre Aguirrezabal Juan |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 112, S 8, H V 76132, I/A 143
30
Jul 2019
Con fecha 30/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Berge Infraestructuras Y Servicios Logisticos SL |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 112, S 8, H V 76132, I/A 142
31
Oct 2017
Con fecha 31/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Carabal Iranzo Constantino |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 112, S 8, H V 76132, I/A 141
01
Jun 2016
Con fecha 01/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Herreruela Tellez Marta Isabel |
Apo.Man.Soli | Diaz Larrieta Koldobika |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 111, S 8, H V 76132, I/A 140
01
Jun 2016
Con fecha 01/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Dopico Ruiz Maria Aranzazu |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 111, S 8, H V 76132, I/A 140
22
Oct 2015
Con fecha 22/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gurria Garcia Luis Carlos |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 111, S 8, H V 76132, I/A 139
24
Sep 2014
Con fecha 24/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Vega Casielles Daniel |
Apoderado | Parra Sampedro Esther Maria |
Apoderado | Fernandez Alonso Carlos Maria |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 111, S 8, H V 76132, I/A 138
18
Ago 2014
Con fecha 18/08/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Zavala Prado Eduardo Maria Martin |
Apoderado | Torres Bofill Mariano Del Valle |
Apo.Manc. | Sanchez Lopez Doriga Manuel |
Apoderado | Saldaña Gasgue Jose Ramon Carmelo |
Apo.Sol. | Reino Pardiñas Fernando |
Apo.Sol. | Neira Chans Maria Jose |
Apoderado | Murillo Gil Roman Manuel |
Apo.Sol. | Marti Ruiz Jose |
Apoderado | Legaz Ardil Jose Francisco |
Apo.Sol. | Gutierrez Sanz Eloina |
Apoderado | Gual Taberna Jose Antonio |
Apoderado | Gravalos Garcia Javier Angel |
Apoderado | Goldaraz Mugica Tomas Nicolas Francisco |
Apo.Sol. | Boto Martinez Maria Mercedes |
Apo.Sol. | Blanco Diez Canseco Guillermo |
Apo.Sol. | Argany Guarro Sergi |
Apo.Sol. | Amo Gaitan Angela |
Apo.Sol. | Alcala Juarez Juan |
Datos registrales: T 9783, L 7065, F 111, S 8, H V 76132, I/A 137
30
Abr 2014
Con fecha 30/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Berge Infraestructuras Y Servicios Logisticos SL |
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 31, S 8, H V 76132, I/A 136
30
Abr 2014
Con fecha 30/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Raez Mateos Angel |
Apo.Sol. | Bevia Iborra Carlos Pedro |
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 31, S 8, H V 76132, I/A 135
24
Feb 2014
Con fecha 24/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Gutierrez Sanz Eloina |
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 31, S 8, H V 76132, I/A 134
20
Feb 2014
Con fecha 20/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Blanco Diez Canseco Guillermo |
Apo.Sol. | Baquero Mundina Javier Henri |
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 31, S 8, H V 76132, I/A 133
13
Ene 2014
Con fecha 13/01/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Garmendia Sarasola Maria Jesus |
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 31, S 8, H V 76132, I/A 132
30
Sep 2013
Con fecha 30/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Grant Thornton SLP |
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 29, S 8, H V 76132, I/A 131
25
Sep 2013
Con fecha 25/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Carabal Iranzo Constantino |
Datos registrales: T 9032, L 6317, F 29, S 8, H V 76132, I/A 130
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2022-217-46 | Valencia | 15/11/2022 | |
BORME-A-2021-221-46 | Valencia | 18/11/2021 | |
BORME-A-2020-237-46 | Valencia | 11/12/2020 | |
BORME-A-2020-152-46 | Valencia | 07/08/2020 | |
BORME-A-2019-149-46 | Valencia | 06/08/2019 | |
BORME-A-2017-213-46 | Valencia | 08/11/2017 | |
BORME-A-2016-108-46 | Valencia | 08/06/2016 | |
BORME-A-2015-207-46 | Valencia | 29/10/2015 | |
BORME-A-2014-187-46 | Valencia | 01/10/2014 | |
BORME-A-2014-160-46 | Valencia | 25/08/2014 | |
BORME-A-2014-87-46 | Valencia | 09/05/2014 | |
BORME-A-2014-42-46 | Valencia | 03/03/2014 | |
BORME-A-2014-40-46 | Valencia | 27/02/2014 | |
BORME-A-2014-12-46 | Valencia | 20/01/2014 | |
BORME-A-2013-191-46 | Valencia | 07/10/2013 | |
BORME-A-2013-188-46 | Valencia | 02/10/2013 | |
BORME-A-2013-162-46 | Valencia | 27/08/2013 | |
BORME-A-2013-50-46 | Valencia | 13/03/2013 | |
BORME-A-2012-243-46 | Valencia | 20/12/2012 | |
BORME-A-2012-156-46 | Valencia | 16/08/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades