Última actualización: 9 de Noviembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 6 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B58521626 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Av Les Garrigues 21 Po.In. Mas Blau Ii (Prat De Llobregat (El)). |
Motivo de la disolución | Judicial. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT. | Saga Auditores SL | 03/11/2010 | 09/11/2020 |
APODERADO | Ochayta Muñoz Piluca | 25/05/2012 | 09/11/2020 |
APODERADO | Muñoz Lamberti Antonio | 25/05/2012 | 09/11/2020 |
ADM.CONCURS. | Martinez Sanz Fernando | 30/12/2014 | 09/11/2020 |
APODERADO | Gomez Alabu Carmen | 25/05/2012 | 09/11/2020 |
AUDIT.CUENT. | Garralda Teus Miguel | 09/09/2009 | 09/11/2020 |
APODERADO | Flores Gordo Andres | 25/05/2012 | 09/11/2020 |
APODERADO | Barriopedro Espatolero Alfonso | 25/05/2012 | 09/11/2020 |
AUDITOR SUP. | Baez Montero Carlos | 09/09/2009 | 09/11/2020 |
CONSEJERO | Ochayta Muñoz Maria Pilar | Desconocido | 22/09/2015 |
PRESIDENTE | Muñoz Lamberti Antonio | Desconocido | 22/09/2015 |
CONSEJERO | Muñoz Lamberti Antonio | Desconocido | 22/09/2015 |
CONSEJERO | Muñoz Givica Maria Elena | Desconocido | 22/09/2015 |
SECRETARIO | Barriopedro Estatolero Alfonso | Desconocido | 22/09/2015 |
CONSEJERO | Barriopedro Estatolero Alfonso | Desconocido | 22/09/2015 |
CONSEJERO | Alabau Cebria Juan Jose | Desconocido | 22/09/2015 |
APODERADO | Viciano Agost Antonio | Desconocido | 16/03/2012 |
APODERADO | Subirana Ortells Jorge | Desconocido | 16/03/2012 |
APODERADO | Gomez Alabau Carmen | 21/05/2010 | 16/03/2012 |
APODERADO | Flores Gordo Andres | 21/05/2010 | 16/03/2012 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Transportes Buytrago Barcelona SL.
09
Nov 2020
Con fecha 09/11/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 43199 , F 13, S 8, H B 163837, I/A 35
09
Nov 2020
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 7 DE MADRID, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 558/2014, AUTO FIRME DE FECHA 02/10/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 43199 , F 13, S 8, H B 163837, I/A 35
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Judicial.
Datos registrales: T 43199 , F 12, S 8, H B 163837, I/A 34
22
Sep 2015
JUZGADO MERCANTIL 7 DE MADRID, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 558/2014, AUTO FIRME DE FECHA 16/02/2015, RECTIFICADO POR AUTO DE FECHA 24/07/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION.
Datos registrales: T 43199 , F 12, S 8, H B 163837, I/A 34
22
Sep 2015
Con fecha 22/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Ochayta Muñoz Maria Pilar |
CONSEJERO | Muñoz Lamberti Antonio |
CONSEJERO | Muñoz Givica Maria Elena |
CONSEJERO | Barriopedro Estatolero Alfonso |
CONSEJERO | Alabau Cebria Juan Jose |
Datos registrales: T 43199 , F 12, S 8, H B 163837, I/A 34
30
Dic 2014
JUZGADO MERCANTIL 7 DE MADRID, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 558/2014, AUTO FIRME DE FECHA 28/07/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES.
Datos registrales: T 43199 , F 11, S 8, H B 163837, I/A 33
30
Dic 2014
Con fecha 30/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Martinez Sanz Fernando |
Datos registrales: T 43199 , F 11, S 8, H B 163837, I/A 33
17
Sep 2012
Con fecha 17/09/2012, la sociedad cambia su domicilio social a AV LES GARRIGUES 21 PO.IN. MAS BLAU II (PRAT DE LLOBREGAT (EL)).
Datos registrales: T 43199 , F 11, S 8, H B 163837, I/A 32
25
May 2012
Con fecha 25/05/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Ochayta Muñoz Piluca |
APODERADO | Muñoz Lamberti Antonio |
APODERADO | Gomez Alabu Carmen |
APODERADO | Flores Gordo Andres |
APODERADO | Barriopedro Espatolero Alfonso |
Datos registrales: T 33874 , F 70, S 8, H B 163837, I/A 31
16
Mar 2012
Con fecha 16/03/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Viciano Agost Antonio |
APODERADO | Subirana Ortells Jorge |
APODERADO | Gomez Alabau Carmen |
APODERADO | Gimenez Latorre Ricard |
APODERADO | Flores Gordo Andres |
APODERADO | Alabau Susperregui Vicente |
Datos registrales: T 33874 , F 69, S 8, H B 163837, I/A 30
05
Ene 2011
Con fecha 05/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Martinez Fernandez Eugenio |
Datos registrales: T 33874 , F 69, S 8, H B 163837, I/A 29
03
Nov 2010
Con fecha 03/11/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Saga Auditores SL |
Datos registrales: T 33874 , F 69, S 8, H B 163837, I/A 28
21
May 2010
Con fecha 21/05/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Martinez Fernandez Eugenio |
APODERADO | Gomez Alabau Carmen |
APODERADO | Gimenez Latorre Ricard |
APODERADO | Flores Gordo Andres |
Datos registrales: T 33874 , F 68, S 8, H B 163837, I/A 27
21
May 2010
Con fecha 21/05/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Gomez Alabau Carmen |
APODERADO | Gimenez Latorre Ricard |
APODERADO | Cabane Ventura Jordi |
Datos registrales: T 33874 , F 68, S 8, H B 163837, I/A 27
09
Sep 2009
Con fecha 09/09/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Garralda Teus Miguel |
AUDITOR SUP. | Baez Montero Carlos |
Datos registrales: T 33874 , F 68, S 8, H B 163837, I/A 26
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2020-221-08 | Barcelona | 17/11/2020 |
BORME-A-2015-186-08 | Barcelona | 29/09/2015 |
BORME-A-2015-5-08 | Barcelona | 09/01/2015 |
BORME-A-2012-185-08 | Barcelona | 25/09/2012 |
BORME-A-2012-107-08 | Barcelona | 07/06/2012 |
BORME-A-2012-61-08 | Barcelona | 28/03/2012 |
BORME-A-2011-12-08 | Barcelona | 19/01/2011 |
BORME-A-2010-218-08 | Barcelona | 15/11/2010 |
BORME-A-2010-105-08 | Barcelona | 04/06/2010 |
BORME-A-2009-182-08 | Barcelona | 23/09/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades