Última actualización: 22 de Diciembre de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad de Inversión de Capital Variable |
NIF | A82795659 |
Denominación anterior | Minguez Investments SICAV |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Juan Ignacio Luca De Tena 11 (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VsecrNoConsj | Uribarri Chacon Pilar | Desconocido | 22/12/2022 |
Apoderado | Uribarri Chacon Pilar | Desconocido | 22/12/2022 |
Consejero | Sierra De Miguel Javier | 25/09/2014 | 22/12/2022 |
Ent. Gestora | Santander Private Banking Gestion SA | Desconocido | 22/12/2022 |
Apoderado | Santander Private Banking Gestion SA | Desconocido | 22/12/2022 |
Apoderado | Reyzabal Larrouy Jose Maria | Desconocido | 22/12/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 12/03/2021 | 22/12/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 25/10/2021 | 22/12/2022 |
Consejero | Montañez Hurtado Silvia | 25/09/2014 | 22/12/2022 |
Secretario | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente | 25/02/2015 | 22/12/2022 |
Secretario | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente | 30/08/2019 | 22/12/2022 |
Liquidador | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente | 22/12/2022 | 22/12/2022 |
Consejero | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente | 30/08/2019 | 22/12/2022 |
Auditor | Deloitte SL | 03/08/2009 | 22/12/2022 |
Auditor | Deloitte SL | 25/09/2014 | 22/12/2022 |
Auditor | Deloitte SL | 21/10/2013 | 22/12/2022 |
Auditor | Deloitte SL | 04/08/2016 | 22/12/2022 |
Presidente | Almagro Gimenez Maria Esperanza | 25/02/2015 | 22/12/2022 |
Consejero | Almagro Gimenez Maria Esperanza | 30/08/2019 | 22/12/2022 |
Consejero | Almagro Gimenez Antonio Vicente | 25/02/2015 | 22/12/2022 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Torreta Florida SICAV.
22
Dic 2022
Con fecha 22/12/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 24046 , F 12, S 8, H M 281089, I/A 41
22
Dic 2022
Con fecha 22/12/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 24046 , F 12, S 8, H M 281089, I/A 41
22
Dic 2022
Con fecha 22/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente |
Datos registrales: T 24046 , F 12, S 8, H M 281089, I/A 41
22
Dic 2022
Con fecha 22/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Uribarri Chacon Pilar |
Apoderado | Santander Private Banking Gestion SA |
Apoderado | Reyzabal Larrouy Jose Maria |
Apoderado | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente |
Datos registrales: T 24046 , F 12, S 8, H M 281089, I/A 41
22
Dic 2022
Con fecha 22/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Uribarri Chacon Pilar |
Ent. Gestora | Santander Private Banking Gestion SA |
Secretario | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente |
EntidDeposit | Caceis Bank Spain SA |
Presidente | Almagro Gimenez Maria Esperanza |
Consejero | Almagro Gimenez Antonio Vicente |
Datos registrales: T 24046 , F 12, S 8, H M 281089, I/A 41
25
Oct 2021
Con fecha 25/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 24046 , F 12, S 8, H M 281089, I/A 40
12
Mar 2021
Con fecha 12/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 24046 , F 12, S 8, H M 281089, I/A 39
30
Ago 2019
Con fecha 30/08/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente |
Presidente | Almagro Gimenez Maria Esperanza |
Consejero | Almagro Gimenez Antonio Vicente |
Datos registrales: T 24046 , F 11, S 8, H M 281089, I/A 38
14
Feb 2019
Con fecha 14/02/2019, la sociedad cambia su domicilio social a C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID).
Datos registrales: T 24046 , F 11, S 8, H M 281089, I/A 37
21
Sep 2017
Con fecha 21/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 24046 , F 11, S 8, H M 281089, I/A 36
18
Oct 2016
Con fecha 18/10/2016, la sociedad cambia su denominación social a TORRETA FLORIDA SICAV SA
Datos registrales: T 24046 , F 10, S 8, H M 281089, I/A 35
04
Ago 2016
Con fecha 04/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 24046 , F 10, S 8, H M 281089, I/A 34
07
Mar 2016
Con fecha 07/03/2016, la sociedad cambia su denominación social a MINGUEZ INVESTMENTS SICAV SA
Datos registrales: T 24046 , F 10, S 8, H M 281089, I/A 33
07
Oct 2015
Con fecha 07/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
EntidDeposit | Santander Securities Services SA |
Datos registrales: T 24046 , F 9, S 8, H M 281089, I/A 32
07
Oct 2015
Con fecha 07/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
EntidDeposit | Santander Investment SA |
Datos registrales: T 24046 , F 9, S 8, H M 281089, I/A 32
24
Sep 2015
Con fecha 24/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 24046 , F 9, S 8, H M 281089, I/A 31
25
Feb 2015
Con fecha 25/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Montañez Hurtado Antonio Manuel |
Datos registrales: T 24046 , F 8, S 8, H M 281089, I/A 30
25
Feb 2015
Con fecha 25/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente |
Presidente | Almagro Gimenez Maria Esperanza |
Consejero | Almagro Gimenez Antonio Vicente |
Datos registrales: T 24046 , F 8, S 8, H M 281089, I/A 29
25
Feb 2015
Con fecha 25/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Sierra De Miguel Javier |
Secretario | Montañez Hurtado Silvia |
Presidente | Montañez Hurtado Antonio Manuel |
Datos registrales: T 24046 , F 8, S 8, H M 281089, I/A 29
07
Oct 2014
Con fecha 07/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gimenez Cañizares Guillermo Vicente |
Datos registrales: T 24046 , F 8, S 8, H M 281089, I/A 28
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2022-247-28 | Madrid | 30/12/2022 | |
BORME-A-2021-210-28 | Madrid | 02/11/2021 | |
BORME-A-2021-54-28 | Madrid | 22/03/2021 | |
BORME-A-2019-171-28 | Madrid | 06/09/2019 | |
BORME-A-2019-36-28 | Madrid | 21/02/2019 | |
BORME-A-2017-189-28 | Madrid | 03/10/2017 | |
BORME-A-2016-205-28 | Madrid | 26/10/2016 | |
BORME-A-2016-153-28 | Madrid | 11/08/2016 | |
BORME-A-2016-51-28 | Madrid | 15/03/2016 | |
BORME-A-2015-198-28 | Madrid | 16/10/2015 | |
BORME-A-2015-188-28 | Madrid | 01/10/2015 | |
BORME-A-2015-45-28 | Madrid | 06/03/2015 | |
BORME-A-2015-43-28 | Madrid | 04/03/2015 | |
BORME-A-2014-196-28 | Madrid | 14/10/2014 | |
BORME-A-2014-189-28 | Madrid | 03/10/2014 | |
BORME-A-2013-226-28 | Madrid | 26/11/2013 | |
BORME-A-2013-208-28 | Madrid | 30/10/2013 | |
BORME-A-2013-207-28 | Madrid | 29/10/2013 | |
BORME-A-2012-150-28 | Madrid | 07/08/2012 | |
BORME-A-2012-149-28 | Madrid | 06/08/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades