Última actualización: 1 de Febrero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 8.000.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 01/02/2024 | Actualidad |
CONSEJERO | Jorg Christian Schrewe | 01/02/2024 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 15/02/2022 | Actualidad |
PRESIDENTE | Detlef Hubert Schotten | 19/11/2020 | Actualidad |
CONSEJERO | Detlef Hubert Schotten | 19/11/2020 | Actualidad |
SECRETARIO | Daniel Herbert Wodera | 19/11/2020 | Actualidad |
CONSEJERO | Daniel Herbert Wodera | 19/11/2020 | Actualidad |
SECRETARIO | Klaus Keysberg | 23/11/2018 | Actualidad |
CONSEJERO | Klaus Keysberg | 23/11/2018 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 17/11/2017 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Hans Martin Koelink | 28/05/2014 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Gancedo Cortijo Alex Enrique | 28/05/2014 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhouesecoopers Auditores SL | 07/01/2014 | Actualidad |
APODERADO | Martin Perez Maria Jacinta | 08/04/2013 | Actualidad |
APODERADO | Gancedo Cortijo Alex Enrique | 14/03/2013 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 16/04/2012 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 28/04/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJERO | Peter Zarth | 19/11/2020 | 01/02/2024 |
PRESIDENTE | Martin Stillger | 23/11/2018 | 19/11/2020 |
CONSEJERO | Martin Stillger | 23/11/2018 | 19/11/2020 |
SECRETARIO | Klaus Keysberg | 13/10/2014 | 19/11/2020 |
CONSEJERO | Klaus Keysberg | 13/10/2014 | 19/11/2020 |
CONSEJERO | Donya Bollwerk | 23/11/2018 | 19/11/2020 |
CONSEJERO | Jorg Heiles | 19/02/2018 | 23/11/2018 |
PRESIDENTE | Gudrun Degenhart | 27/04/2016 | 23/11/2018 |
CONSEJERO | Gudrun Degenhart | 27/04/2016 | 23/11/2018 |
CONSEJERO | Donya Bollwerk | 13/10/2014 | 19/02/2018 |
APODERADO | Sanchez Alvarez Maria De Los Angeles | Desconocido | 20/07/2016 |
APODERADO | Merino Gonzalez Jose Luis | Desconocido | 20/07/2016 |
APODERADO | Lara Castillo Maria Carmen | Desconocido | 20/07/2016 |
PRESIDENTE | Ilse Henne | 13/10/2014 | 27/04/2016 |
CONSEJERO | Ilse Henne | 13/10/2014 | 27/04/2016 |
SECRETARIO | Klaus Keysberg | 09/09/2014 | 13/10/2014 |
CONSEJERO | Klaus Keysberg | 09/09/2014 | 13/10/2014 |
PRESIDENTE | Ilse Henne | 09/09/2014 | 13/10/2014 |
CONSEJERO | Ilse Henne | 09/09/2014 | 13/10/2014 |
CONSEJERO | Gerd Heinrich Josef Krasshofer | 09/09/2014 | 13/10/2014 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Thyssenkrupp Materials Iberica SA.
01
Feb 2024
Con fecha 01/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Jorg Christian Schrewe |
Datos registrales: T 45470 , F 23, S 8, H B 36656, I/A 106
01
Feb 2024
Con fecha 01/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Peter Zarth |
Datos registrales: T 45470 , F 23, S 8, H B 36656, I/A 106
01
Feb 2024
Con fecha 01/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 45470 , F 23, S 8, H B 36656, I/A 105
15
Feb 2022
Con fecha 15/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45470 , F 22, S 8, H B 36656, I/A 104
19
Nov 2020
Con fecha 19/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Peter Zarth |
PRESIDENTE | Detlef Hubert Schotten |
SECRETARIO | Daniel Herbert Wodera |
Datos registrales: T 45470 , F 22, S 8, H B 36656, I/A 103
19
Nov 2020
Con fecha 19/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Martin Stillger |
CONSEJERO | Klaus Keysberg |
CONSEJERO | Donya Bollwerk |
Datos registrales: T 45470 , F 22, S 8, H B 36656, I/A 103
26
Nov 2019
DECLARACION DE CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO, SIENDO EL NUEVO SCCIONISTA UNICO: THYSSENKRUPP TECHNOLOGIES BETEILIGUNGEN, GMBH.
Datos registrales: T 45470 , F 22, S 8, H B 36656, I/A 102
23
Nov 2018
Con fecha 23/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Martin Stillger |
SECRETARIO | Klaus Keysberg |
CONSEJERO | Donya Bollwerk |
Datos registrales: T 45470 , F 21, S 8, H B 36656, I/A 101
23
Nov 2018
Con fecha 23/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Jorg Heiles |
CONSEJERO | Gudrun Degenhart |
Datos registrales: T 45470 , F 21, S 8, H B 36656, I/A 101
19
Feb 2018
Con fecha 19/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Jorg Heiles |
Datos registrales: T 45470 , F 21, S 8, H B 36656, I/A 100
19
Feb 2018
Con fecha 19/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Donya Bollwerk |
Datos registrales: T 45470 , F 21, S 8, H B 36656, I/A 100
17
Nov 2017
Con fecha 17/11/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45470 , F 21, S 8, H B 36656, I/A 99
20
Jul 2016
Con fecha 20/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Sanchez Alvarez Maria De Los Angeles |
APODERADO | Merino Gonzalez Jose Luis |
APODERADO | Lara Castillo Maria Carmen |
Datos registrales: T 43622 , F 40, S 8, H B 36656, I/A 98
27
Abr 2016
Con fecha 27/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Gudrun Degenhart |
Datos registrales: T 43622 , F 40, S 8, H B 36656, I/A 97
27
Abr 2016
Con fecha 27/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
PRESIDENTE | Ilse Henne |
Datos registrales: T 43622 , F 40, S 8, H B 36656, I/A 97
13
Oct 2014
Con fecha 13/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECRETARIO | Klaus Keysberg |
PRESIDENTE | Ilse Henne |
CONSEJERO | Donya Bollwerk |
Datos registrales: T 43622 , F 40, S 8, H B 36656, I/A 96
13
Oct 2014
Con fecha 13/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Klaus Keysberg |
CONSEJERO | Ilse Henne |
CONSEJERO | Gerd Heinrich Josef Krasshofer |
Datos registrales: T 43622 , F 40, S 8, H B 36656, I/A 96
09
Sep 2014
Con fecha 09/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECRETARIO | Klaus Keysberg |
PRESIDENTE | Ilse Henne |
CONSEJERO | Gerd Heinrich Josef Krasshofer |
Datos registrales: T 43622 , F 39, S 8, H B 36656, I/A 95
09
Sep 2014
Con fecha 09/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
PRESIDENTE | Joachim Otto Jacob Limberg |
SECRETARIO | Ilse Henne |
CONSEJERO | Gerd Heinrich Josef Krasshofer |
Datos registrales: T 43622 , F 39, S 8, H B 36656, I/A 95
02
Sep 2014
Sociedades absorbidas: THYSSENKRUPP STAINLESS IBERICA SA.
Datos registrales: T 43622 , F 37, S 8, H B 36656, I/A 94
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-29-08 | Barcelona | 09/02/2024 | |
BORME-A-2022-39-08 | Barcelona | 25/02/2022 | |
BORME-A-2020-229-08 | Barcelona | 27/11/2020 | |
BORME-A-2019-233-08 | Barcelona | 04/12/2019 | |
BORME-A-2018-231-08 | Barcelona | 03/12/2018 | |
BORME-A-2018-41-08 | Barcelona | 27/02/2018 | |
BORME-A-2017-224-08 | Barcelona | 24/11/2017 | |
BORME-A-2016-144-08 | Barcelona | 29/07/2016 | |
BORME-A-2016-86-08 | Barcelona | 06/05/2016 | |
BORME-A-2014-201-08 | Barcelona | 21/10/2014 | |
BORME-A-2014-178-08 | Barcelona | 18/09/2014 | |
BORME-A-2014-172-08 | Barcelona | 10/09/2014 | |
BORME-A-2014-105-08 | Barcelona | 05/06/2014 | |
BORME-A-2014-9-08 | Barcelona | 15/01/2014 | |
BORME-A-2013-187-08 | Barcelona | 01/10/2013 | |
BORME-A-2013-158-08 | Barcelona | 21/08/2013 | |
BORME-A-2013-135-08 | Barcelona | 18/07/2013 | |
BORME-A-2013-71-08 | Barcelona | 16/04/2013 | |
BORME-A-2013-57-08 | Barcelona | 25/03/2013 | |
BORME-A-2012-89-08 | Barcelona | 11/05/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades