Última actualización: 29 de Marzo de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Disuelta desde hace 4 años, 7 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B29444320 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Zurbano, Nº 49, Oficina 4 (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Vilallonga Von Hohenlohe Langenburg Flavia Ignacia | 08/10/2015 | Actualidad |
Consejero | Harrold Alan Henry | 08/10/2015 | Actualidad |
Consejero | De Hohenlohe Hubertus Rudolf | 08/10/2015 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 14/10/2011 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 29/09/2010 | Actualidad |
Apoderado | Sotillo Del Mazo Jose Juan | 04/09/2009 | Actualidad |
Apoderado | Gaspar Pardo De Andrade Ignacio | 04/09/2009 | Actualidad |
Auditor | Ernst & Young SL | 19/08/2009 | Actualidad |
SecreNoConsj | Olivera Perez-Frade Gonzalo | 01/07/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Representan | Echecopar Florez Fernando | 05/09/2019 | 29/03/2023 |
Liquidador | Directores De Transicion Y Gestion SL | 05/09/2019 | 29/03/2023 |
Presidente | Vilallonga Von Hohenlohe Langenburg Flavia Ignacia | 08/10/2015 | 05/09/2019 |
Consejero | Vilallonga Von Hohenlohe Langenburg Flavia Ignacia | 19/08/2009 | 05/09/2019 |
Consejero | Harrold Alan Henry | 09/06/2009 | 05/09/2019 |
Consejero | De Hohenlohe Hubertus Rudolf | 09/06/2009 | 05/09/2019 |
SecreNoConsj | Canals Brage Guillermo | 14/11/2012 | 05/09/2019 |
Representan | Sanchez Serrano Javier | 21/09/2015 | 09/03/2016 |
Presidente | De Hohenlohe Hubertus Rudolf | 09/06/2009 | 08/10/2015 |
Cons.Del.Sol | De Hohenlohe Hubertus Rudolf | 05/08/2009 | 08/10/2015 |
VsecrNoConsj | Carmona Garcia Maria Jesus | 14/11/2012 | 08/10/2015 |
Secretario | Olivera Perez-Frade Gonzalo | Desconocido | 05/11/2012 |
VsecrNoConsj | Artes Caselles Alberto | 13/04/2009 | 05/11/2012 |
Consejero | De Hohenlohe Pablo | 09/06/2009 | 14/06/2012 |
Cons.Del.Sol | De Hohenlohe Pablo | 05/08/2009 | 14/06/2012 |
Consejero | Van Leeuwen Johannes Jacobus | Desconocido | 09/06/2009 |
Cons.Del.Sol | De Hohenlohe Pablo | Desconocido | 09/06/2009 |
Cons.Del.Sol | De Hohenlohe Hubertus Rudolf | Desconocido | 09/06/2009 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Tenfa SL.
29
Mar 2023
Con fecha 29/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Echecopar Florez Fernando |
Liquidador | Directores De Transicion Y Gestion SL |
Datos registrales: T 30295 , F 212, S 8, H M 291387, I/A 32
18
Dic 2020
Procedimiento concursal 450/2012. FIRME: No, Fecha de resolución 23/11/2020. Auto de declaración de cumplimiento de convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE MADRID. Juez: JORGE MONTULL URQUIJO. Resoluciones: DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO.
Datos registrales: T 30295 , F 212, S 8, H M 291387, I/A B
05
Sep 2019
Con fecha 05/09/2019 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 30295 , F 211, S 8, H M 291387, I/A 31
05
Sep 2019
Con fecha 05/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Echecopar Florez Fernando |
Liquidador | Directores De Transicion Y Gestion SL |
Datos registrales: T 30295 , F 211, S 8, H M 291387, I/A 31
05
Sep 2019
Con fecha 05/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Vilallonga Von Hohenlohe Langenburg Flavia Ignacia |
Consejero | Harrold Alan Henry |
Consejero | De Hohenlohe Hubertus Rudolf |
SecreNoConsj | Canals Brage Guillermo |
Datos registrales: T 30295 , F 211, S 8, H M 291387, I/A 31
09
Mar 2016
Procedimiento concursal 450/2012. Fecha de resolución 23/10/2012. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Administrador Concursal. Fecha 12/11/2015, NIF/CIF B86326386. GESTION CONCURSAL INTEGRAL SLP.
Datos registrales: T 30295 , F 209, S 8, H M 291387, I/A 30
09
Mar 2016
Procedimiento concursal 450/2012. FIRME: Si, Fecha de resolución 12/11/2015. Sentencia de aprobación del convenio. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Resoluciones: APROBAR EL CONVENIO ACEPTADO POR LA JUNTA DE ACREEDORES DE LA CONCURSADA, EL CUAL ADQUIRIRA PLENA EFICACIA DESDE LA FECHA DE LA RESOLUCION JUDICIAL Y DESDE LA EFICACIA DEL CONVENIO CESARAN TODOS LOS EFECTOS DE LA DECLARACION DE CONCURSO Y LA ADMINISTRACION CONCURSAL.
Datos registrales: T 30295 , F 209, S 8, H M 291387, I/A 30
09
Mar 2016
Con fecha 09/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Sanchez Serrano Javier |
Datos registrales: T 30295 , F 209, S 8, H M 291387, I/A 30
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Vilallonga Von Hohenlohe Langenburg Flavia Ignacia |
Consejero | Harrold Alan Henry |
Consejero | De Hohenlohe Hubertus Rudolf |
Datos registrales: T 30295 , F 209, S 8, H M 291387, I/A 29
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Vilallonga Von Hohenlohe Langenburg Flavia Ignacia |
Datos registrales: T 30295 , F 209, S 8, H M 291387, I/A 29
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | De Hohenlohe Hubertus Rudolf |
VsecrNoConsj | Carmona Garcia Maria Jesus |
Datos registrales: T 30295 , F 209, S 8, H M 291387, I/A 29
21
Sep 2015
Procedimiento concursal 450/2012. FIRME: No, Fecha de resolución 23/10/2012. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Resoluciones: EL DEUDOR "TENFA SL" CONSERVARA LAS FACULTADES DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION SOBRE SU PATRIMONIO, QUEDANDO SOMETIDO EL EJERCICIO DE ESTAS A LA INTERVENCION DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES, MEDIANTE SU AUTORIZACION O CONFORMIDAD.
Datos registrales: T 30295 , F 208, S 8, H M 291387, I/A A
21
Sep 2015
Procedimiento concursal 450/2012. Fecha de resolución 23/10/2012. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Administrador Concursal. Fecha 23/10/2012, NIF/CIF B86326386. GESTION CONCURSAL INTEGRAL SLP.
Datos registrales: T 30295 , F 208, S 8, H M 291387, I/A A
21
Sep 2015
Procedimiento concursal 450/2012. FIRME: No, Fecha de resolución 23/10/2012. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 3 JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Resoluciones: SE DECLARA EN CONCURSO, QUE TIENE CARACTER DE VOLUNTARIO AL DEUDOR "TENFA SL".
Datos registrales: T 30295 , F 208, S 8, H M 291387, I/A A
21
Sep 2015
Con fecha 21/09/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Representan | Sanchez Serrano Javier |
Datos registrales: T 30295 , F 208, S 8, H M 291387, I/A A
14
Nov 2012
Con fecha 14/11/2012, la sociedad cambia su domicilio social a C/ ZURBANO, Nº 49, OFICINA 4 (MADRID).
Datos registrales: T 17030 , F 102, S 8, H M 291387, I/A 28
14
Nov 2012
Con fecha 14/11/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Carmona Garcia Maria Jesus |
SecreNoConsj | Canals Brage Guillermo |
Datos registrales: T 17030 , F 102, S 8, H M 291387, I/A 28
05
Nov 2012
Con fecha 05/11/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Olivera Perez-Frade Gonzalo |
VsecrNoConsj | Artes Caselles Alberto |
Datos registrales: T 17030 , F 102, S 8, H M 291387, I/A 27
14
Jun 2012
Con fecha 14/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | De Hohenlohe Pablo |
Datos registrales: T 17030 , F 102, S 8, H M 291387, I/A 26
14
Oct 2011
Con fecha 14/10/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 17030 , F 101, S 8, H M 291387, I/A 25
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2023-66-28 | Madrid | 05/04/2023 |
BORME-A-2020-247-28 | Madrid | 28/12/2020 |
BORME-A-2019-175-28 | Madrid | 12/09/2019 |
BORME-A-2016-53-28 | Madrid | 17/03/2016 |
BORME-A-2015-199-28 | Madrid | 19/10/2015 |
BORME-A-2015-185-28 | Madrid | 28/09/2015 |
BORME-A-2012-226-28 | Madrid | 26/11/2012 |
BORME-A-2012-220-28 | Madrid | 16/11/2012 |
BORME-A-2012-120-28 | Madrid | 26/06/2012 |
BORME-A-2011-204-28 | Madrid | 26/10/2011 |
BORME-A-2010-196-28 | Madrid | 11/10/2010 |
BORME-A-2009-177-28 | Madrid | 16/09/2009 |
BORME-A-2009-172-28 | Madrid | 09/09/2009 |
BORME-A-2009-155-28 | Madrid | 17/08/2009 |
BORME-A-2009-130-28 | Madrid | 13/07/2009 |
BORME-A-2009-115-28 | Madrid | 22/06/2009 |
BORME-A-2009-75-28 | Madrid | 22/04/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades