Última actualización: 10 de Julio de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 9 meses |
---|---|
Forma jurídica | Limited company |
NIF | W8261162E |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Paseo De La Castellana 7 (Madrid). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Sol. | Wise Kevin | 10/05/2017 | 10/07/2018 |
Apo.Sol. | Weelson Ryan | 10/05/2017 | 10/07/2018 |
Apoderado | Thomas Gall Oliver | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apoderado | Sansom Paul James | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apo.Sol. | Poosh Mitra Meshgin | 01/10/2010 | 10/07/2018 |
Apoderado | Perez Mansilla Delgado Patricia | 28/11/2011 | 10/07/2018 |
Apoderado | Paul Etha | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apoderado | Paul Etha | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apoderado | O'Melia Elizabeth | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apoderado | Mafuz Gumiel Rosa Maria | 28/11/2011 | 10/07/2018 |
Apoderado | Lottier Cecile Angelina | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apoderado | Jones Ceredig Ifan | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apo.Manc. | Haran Edward Joseph | 10/05/2017 | 10/07/2018 |
Apoderado | Geiger Adam G | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apoderado | Gall David Shawn | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apoderado | Gall David Shawn | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apoderado | Fernandez Conde Gema | 09/04/2014 | 10/07/2018 |
Apo.Sol. | Donohoe Pareja Irene | 10/05/2017 | 10/07/2018 |
Apoderado | Diez Vergara Maitane | 28/11/2011 | 10/07/2018 |
Apo.Sol. | Davies Alun Harry | 01/10/2010 | 10/07/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Standard & Poor'S Credit Market Services Europe LTD.
10
Jul 2018
Con fecha 10/07/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 28715 , F 186, S 8, H M 499543, I/A 26
10
May 2017
Con fecha 10/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Wise Kevin |
Apo.Sol. | Weelson Ryan |
Apo.Sol. | Thomas Gall Oliver |
Apo.Manc. | Shawn Gall David |
Apo.Sol. | Sansom Paul James |
Apo.Manc. | Lottier Cecile Angelina |
Apo.Sol. | Harry Davies Alun |
Apo.Manc. | Haran Edward Joseph |
Apo.Manc. | Garret Katz Edward |
Apo.Sol. | Forbes Mark Guthrie |
Apo.Sol. | Donohoe Pareja Irene |
Apo.Sol. | Dennis Ottley Trevor |
Apo.Manc. | Bottino Eugenio |
Apo.Manc. | Bonilla Azucena Paola Mitchelle |
Datos registrales: T 28715 , F 184, S 8, H M 499543, I/A 25
17
Feb 2017
ACTUALIZACION DE LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ.
Datos registrales: T 28715 , F 184, S 8, H M 499543, I/A 24
13
Sep 2016
ACTUALIZACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD MATRIZ.
Datos registrales: T 28715 , F 183, S 8, H M 499543, I/A 23
13
Sep 2016
Con fecha 13/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Per.M. | Plantagie Jan Willem |
Datos registrales: T 28715 , F 183, S 8, H M 499543, I/A 23
13
Sep 2016
Con fecha 13/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Per.M. | Le Pallec Yann Marc Eric |
Datos registrales: T 28715 , F 183, S 8, H M 499543, I/A 23
13
Abr 2016
ACTUALIZACION DE LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ.
Datos registrales: T 28715 , F 182, S 8, H M 499543, I/A 22
11
Nov 2015
ACTUALIZACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD MATRIZ.
Datos registrales: T 28715 , F 182, S 8, H M 499543, I/A 21
15
Jun 2015
Con fecha 15/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Pierdicchi Maria |
Datos registrales: T 28715 , F 181, S 8, H M 499543, I/A 19
15
Jun 2015
Con fecha 15/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Per.M. | Pierdicchi Maria |
Datos registrales: T 28715 , F 181, S 8, H M 499543, I/A 19
15
Jun 2015
ACTUALIZACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ.
Datos registrales: T 28715 , F 181, S 8, H M 499543, I/A 18
31
Dic 2014
MODIFICADO EL N.I.E. DE DOÑA MARIA PIERDICCHI SIENDO EL ACTUAL Y1582756W.
Datos registrales: T 28715 , F 179, S 8, H M 499543, I/A 17
31
Dic 2014
Con fecha 31/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Per.M. | Sansom Paul James |
R.L.C.Per.M. | Le Pallec Yann Marc Eric |
Datos registrales: T 28715 , F 179, S 8, H M 499543, I/A 17
31
Dic 2014
Con fecha 31/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Robert Pearce David |
Datos registrales: T 28715 , F 179, S 8, H M 499543, I/A 17
31
Dic 2014
Con fecha 31/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Per.M. | Sirou Carol Isabelle Madeleine |
R.L.C.Per.M. | Pearce David Robert |
Datos registrales: T 28715 , F 179, S 8, H M 499543, I/A 17
09
Jul 2014
Con fecha 09/07/2014, la sociedad cambia su domicilio social a PASEO DE LA CASTELLANA 7 (MADRID).
Datos registrales: T 28715 , F 179, S 8, H M 499543, I/A 16
09
Jul 2014
Con fecha 09/07/2014, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Artículo de los estatutos: Domicilio.-.
Datos registrales: T 28715 , F 179, S 8, H M 499543, I/A 16
09
Abr 2014
Con fecha 09/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Wise Kevin |
Apoderado | Thomas Gall Oliver |
Apoderado | Sansom Paul James |
Apoderado | Robert Pearce David |
Apoderado | Rinaldi Robert |
Apoderado | Paul Etha |
Apoderado | Ottley Trevor Dennis |
Apoderado | O'Melia Elizabeth |
Apoderado | Michael Benyo Nicholas |
Apoderado | Lottier Cecile Angelina |
Apoderado | Jones Ceredig Ifan |
Apoderado | Hunter David Samuel |
Apoderado | Giammarella Ellen Marie |
Apoderado | Geiger Adam G |
Apoderado | Garrido Martinez De Salazar Carlos |
Apoderado | Gall David Shawn |
Apoderado | Forbes Mark Guthrie |
Apoderado | Fevre Obarrio Jacques Louis |
Apoderado | Fernandez Conde Gema |
Apoderado | Donohoe Pareja Irene |
Apoderado | Davies Alun Harry |
Apoderado | Bottino Eugenio |
Apoderado | Baldwin Amanda Claire |
Datos registrales: T 28715 , F 175, S 8, H M 499543, I/A 15
09
Abr 2014
Con fecha 09/04/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Wise Kevin |
Apo.Manc. | Sansom Paul James |
Apo.Manc. | Ryan Kate |
Apo.Manc. | Rogers Jeremy Peter Randall |
Apo.Manc. | Paul Etha |
Apo.Manc. | O'Melia Elizabeth |
Apoderado | Mcgraw Hill Interamericana De España SL |
Apo.Manc. | Marrazzo Jr Edward |
Apo.Manc. | Lottier Cecile Angelina |
Apo.Manc. | Korakis Emmanuel N |
Apo.Manc. | Knight Christopher Phillip |
Apo.Manc. | Jones Ceredig Ifan |
Apo.Manc. | Hunter David Samuel |
Apoderado | Gutierrez Garcia Enrique |
Apo.Manc. | Giammarella Ellen Marie |
Apo.Manc. | Fevre Obarrio Jacques Louis Philippe |
Apo.Sol. | Dieguez Flick Irene Francisca |
Apo.Manc. | Bottino Eugenio |
Apo.Manc. | Benyo Nicholas Michael |
Datos registrales: T 28715 , F 175, S 8, H M 499543, I/A 15
09
Abr 2014
ACTUALIZACION E IDENTIFICACION IDE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD MATRIZ.
Datos registrales: T 28715 , F 175, S 8, H M 499543, I/A 14
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-136-28 | Madrid | 17/07/2018 | |
BORME-A-2017-93-28 | Madrid | 19/05/2017 | |
BORME-A-2017-40-28 | Madrid | 27/02/2017 | |
BORME-A-2016-181-28 | Madrid | 21/09/2016 | |
BORME-A-2016-76-28 | Madrid | 21/04/2016 | |
BORME-A-2015-220-28 | Madrid | 18/11/2015 | |
BORME-A-2015-116-28 | Madrid | 23/06/2015 | |
BORME-A-2015-5-28 | Madrid | 09/01/2015 | |
BORME-A-2014-133-28 | Madrid | 16/07/2014 | |
BORME-A-2014-75-28 | Madrid | 21/04/2014 | |
BORME-A-2013-120-28 | Madrid | 27/06/2013 | |
BORME-A-2012-190-28 | Madrid | 02/10/2012 | |
BORME-A-2012-147-28 | Madrid | 02/08/2012 | |
BORME-A-2012-83-28 | Madrid | 03/05/2012 | |
BORME-A-2011-235-28 | Madrid | 14/12/2011 | |
BORME-A-2011-232-28 | Madrid | 09/12/2011 | |
BORME-A-2011-222-28 | Madrid | 23/11/2011 | |
BORME-A-2011-175-28 | Madrid | 14/09/2011 | |
BORME-A-2010-227-28 | Madrid | 26/11/2010 | |
BORME-A-2010-198-28 | Madrid | 14/10/2010 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades