Última actualización: 1 de Septiembre de 2016
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 7 años, 7 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B64354343 |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 6.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Marin Duran Angela | 09/08/2016 | 01/09/2016 |
SECR.NO CONS | Marc Smeets | 19/07/2013 | 01/09/2016 |
APODERAD.SOL | Marc Smeets | 09/08/2016 | 01/09/2016 |
LIQUIDADOR | Lee Edward Bocker | 01/09/2016 | 01/09/2016 |
LIQUIDADOR | Lee Edward Bocker | Desconocido | 01/09/2016 |
CONSEJERO | Lee Edward Bocker | 25/04/2016 | 01/09/2016 |
APODERAD.SOL | Gandoy Fernandez Isabel | 09/08/2016 | 01/09/2016 |
CONSEJERO | Francis Scott Ferraro | 25/04/2016 | 01/09/2016 |
PRESIDENTE | Duran Marin Angela | 25/04/2016 | 01/09/2016 |
CONSEJERO | Duran Marin Angela | 25/04/2016 | 01/09/2016 |
APODERAD.SOL | Bas Espargaro Krishna | 09/08/2016 | 01/09/2016 |
CONSEJERO | Therisa Perrin George | 01/10/2014 | 25/04/2016 |
APODERADO | Roberto Guillermo Maclean Martins | Desconocido | 25/04/2016 |
APODERADO | Rafael Fernando Corzo De La Colina | Desconocido | 25/04/2016 |
CONSEJERO | Ignacio Nicolas Sanz | 01/10/2014 | 25/04/2016 |
PRESIDENTE | Danny Henry Kragt | Desconocido | 25/04/2016 |
CONSEJERO | Danny Henry Kragt | Desconocido | 25/04/2016 |
CONSEJERO | Cristian Celis Morgan | 12/03/2010 | 01/10/2014 |
CONSEJERO | Armando Borda | 12/03/2010 | 01/10/2014 |
SECR.NO CONS | Xercavins Lluch Victor | Desconocido | 19/07/2013 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Stafedouble SL.
01
Sep 2016
Con fecha 01/09/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 40860 , F 37, S 8, H B 335199, I/A 12
01
Sep 2016
Con fecha 01/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Lee Edward Bocker |
Datos registrales: T 40860 , F 37, S 8, H B 335199, I/A 12
01
Sep 2016
Con fecha 01/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Marc Smeets |
LIQUIDADOR | Lee Edward Bocker |
CONSEJERO | Francis Scott Ferraro |
PRESIDENTE | Duran Marin Angela |
Datos registrales: T 40860 , F 37, S 8, H B 335199, I/A 12
09
Ago 2016
Con fecha 09/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Marin Duran Angela |
APODERAD.SOL | Marc Smeets |
APODERAD.SOL | Gandoy Fernandez Isabel |
APODERAD.SOL | Bas Espargaro Krishna |
Datos registrales: T 40860 , F 37, S 8, H B 335199, I/A 11
12
Jul 2016
Reducción de capital
Datos registrales: T 40860 , F 37, S 8, H B 335199, I/A 10
25
Abr 2016
Con fecha 25/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Lee Edward Bocker |
CONSEJERO | Francis Scott Ferraro |
PRESIDENTE | Duran Marin Angela |
Datos registrales: T 39013 , F 217, S 8, H B 335199, I/A 9
25
Abr 2016
Con fecha 25/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Therisa Perrin George |
APODERADO | Roberto Guillermo Maclean Martins |
APODERADO | Rafael Fernando Corzo De La Colina |
CONSEJERO | Ignacio Nicolas Sanz |
CONSEJERO | Danny Henry Kragt |
Datos registrales: T 39013 , F 217, S 8, H B 335199, I/A 9
01
Oct 2014
Con fecha 01/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Therisa Perrin George |
CONSEJERO | Ignacio Nicolas Sanz |
Datos registrales: T 39013 , F 217, S 8, H B 335199, I/A 8
01
Oct 2014
Con fecha 01/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Cristian Celis Morgan |
CONSEJERO | Armando Borda |
Datos registrales: T 39013 , F 217, S 8, H B 335199, I/A 8
19
Jul 2013
Con fecha 19/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Marc Smeets |
Datos registrales: T 39013 , F 217, S 8, H B 335199, I/A 7
19
Jul 2013
Con fecha 19/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Xercavins Lluch Victor |
V-SEC NO CON | Marc Smeets |
Datos registrales: T 39013 , F 217, S 8, H B 335199, I/A 7
12
Mar 2010
Con fecha 12/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Cristian Celis Morgan |
CONSEJERO | Armando Borda |
Datos registrales: T 39013 , F 216, S 8, H B 335199, I/A 6
12
Mar 2010
Con fecha 12/03/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Juan Pablo Pallordet |
CONSEJERO | Andres Small |
Datos registrales: T 39013 , F 216, S 8, H B 335199, I/A 6
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2016-173-08 | Barcelona | 09/09/2016 |
BORME-A-2016-157-08 | Barcelona | 18/08/2016 |
BORME-A-2016-138-08 | Barcelona | 20/07/2016 |
BORME-A-2016-84-08 | Barcelona | 04/05/2016 |
BORME-A-2014-193-08 | Barcelona | 09/10/2014 |
BORME-A-2013-143-08 | Barcelona | 30/07/2013 |
BORME-A-2010-58-08 | Barcelona | 26/03/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades