Última actualización: 21 de Mayo de 2019
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 4 años, 11 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A28121127 |
Denominación anterior | Apv Iberica Ingenieria Y Servicios SA |
Provincia | Madrid |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Vela Delfa Maria Jose | 19/01/2015 | 21/05/2019 |
Apo.Manc. | Trubody Duncan | 19/01/2015 | 21/05/2019 |
Presidente | Reilly Michael Andrew | 10/10/2014 | 21/05/2019 |
Consejero | Reilly Michael Andrew | 10/10/2014 | 21/05/2019 |
Apo.Manc. | Potikoglou Stefanie Magdalena Monika | 19/01/2015 | 21/05/2019 |
Consejero | Miranda Serrano Carlos | 10/10/2014 | 21/05/2019 |
Apoderado | Mayo Torralba Luis | 30/01/2015 | 21/05/2019 |
Presidente | Manson Easley Jaime | 08/10/2015 | 21/05/2019 |
Consejero | Manson Easley Jaime | 08/10/2015 | 21/05/2019 |
Apo.Sol. | Jhonson Philip | 22/06/2012 | 21/05/2019 |
Apoderado | Gilles Ingles Jean Michel | 16/12/2014 | 21/05/2019 |
Apo.Manc. | Gilles Ingles Jean Michel | 19/01/2015 | 21/05/2019 |
Secretario | Garcia Lopez Luis Manuel | Desconocido | 21/05/2019 |
Auditor | Deloitte SL | 07/10/2013 | 21/05/2019 |
Auditor | Deloitte SL | 12/11/2015 | 21/05/2019 |
Auditor | Deloitte SL | 31/10/2012 | 21/05/2019 |
Auditor | Deloitte SL | 09/03/2012 | 21/05/2019 |
Auditor | Bdo Auditores SLP | 23/01/2017 | 21/05/2019 |
Apo.Sol. | Barbosa Saulo Ramos | 22/06/2012 | 21/05/2019 |
Consejero | Athan Tsoris Stephen | 16/04/2015 | 21/05/2019 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Spx Flow Technology Iberica SA.
21
May 2019
Con fecha 21/05/2019 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 35336 , F 161, S 8, H M 72854, I/A 90
21
May 2019
Con fecha 21/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mayo Torralba Luis |
Presidente | Manson Easley Jaime |
Secretario | Garcia Lopez Luis Manuel |
Consejero | Athan Tsoris Stephen |
Datos registrales: T 35336 , F 161, S 8, H M 72854, I/A 90
30
Nov 2018
CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ART. 231 RRM.
Datos registrales: T 35336 , F 161, S 8, H M 72854, I/A 89M
23
Oct 2018
Con fecha 23/10/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias SPX FLOW EUROPE LIMITED.
Datos registrales: T 35336 , F 161, S 8, H M 72854, I/A 89
23
Ene 2017
Con fecha 23/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 29410 , F 63, S 8, H M 72854, I/A 88
12
Nov 2015
Con fecha 12/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 29410 , F 63, S 8, H M 72854, I/A 87
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Manson Easley Jaime |
Datos registrales: T 29410 , F 63, S 8, H M 72854, I/A 86
08
Oct 2015
Con fecha 08/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Reilly Michael Andrew |
Datos registrales: T 29410 , F 63, S 8, H M 72854, I/A 86
16
Abr 2015
Con fecha 16/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Athan Tsoris Stephen |
Datos registrales: T 29410 , F 63, S 8, H M 72854, I/A 85
16
Abr 2015
Con fecha 16/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Lilly Kevin Lucius |
Datos registrales: T 29410 , F 63, S 8, H M 72854, I/A 85
30
Ene 2015
Con fecha 30/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Mayo Torralba Luis |
Datos registrales: T 29410 , F 62, S 8, H M 72854, I/A 84
30
Ene 2015
Con fecha 30/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vela Delfa Maria Jose |
Apoderado | Miranda Serrano Carlos |
Apoderado | Esteban Vega Roberto Carlos |
Datos registrales: T 29410 , F 62, S 8, H M 72854, I/A 84
30
Ene 2015
Con fecha 30/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicepresid. | Miranda Serrano Carlos |
Datos registrales: T 29410 , F 62, S 8, H M 72854, I/A 84
19
Ene 2015
Con fecha 19/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Vela Delfa Maria Jose |
Apo.Manc. | Trubody Duncan |
Apo.Manc. | Potikoglou Stefanie Magdalena Monika |
Apo.Manc. | Mayo Torralba Luis |
Apo.Manc. | Heaton Angela |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Roques Maria Del Carmen |
Apo.Manc. | Gilles Ingles Jean Michel |
Apo.Manc. | Ehler Claudia |
Datos registrales: T 29410 , F 61, S 8, H M 72854, I/A 83
16
Dic 2014
Con fecha 16/12/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gilles Ingles Jean Michel |
Datos registrales: T 29410 , F 60, S 8, H M 72854, I/A 82
25
Nov 2014
Con fecha 25/11/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 29410 , F 60, S 8, H M 72854, I/A 81
10
Oct 2014
Con fecha 10/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Reilly Michael Andrew |
Vicepresid. | Miranda Serrano Carlos |
Consejero | Lilly Kevin Lucius |
Datos registrales: T 29410 , F 60, S 8, H M 72854, I/A 80
07
Oct 2013
Con fecha 07/10/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 29410 , F 59, S 8, H M 72854, I/A 79
31
Oct 2012
Con fecha 31/10/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 29410 , F 59, S 8, H M 72854, I/A 78
22
Jun 2012
Con fecha 22/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Jhonson Philip |
Apo.Sol. | Barbosa Saulo Ramos |
Datos registrales: T 29410 , F 59, S 8, H M 72854, I/A 77
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2019-99-28 | Madrid | 28/05/2019 | |
BORME-A-2018-235-28 | Madrid | 10/12/2018 | |
BORME-A-2018-209-28 | Madrid | 30/10/2018 | |
BORME-A-2017-21-28 | Madrid | 31/01/2017 | |
BORME-A-2015-222-28 | Madrid | 20/11/2015 | |
BORME-A-2015-200-28 | Madrid | 20/10/2015 | |
BORME-A-2015-77-28 | Madrid | 24/04/2015 | |
BORME-A-2015-25-28 | Madrid | 06/02/2015 | |
BORME-A-2015-17-28 | Madrid | 27/01/2015 | |
BORME-A-2014-245-28 | Madrid | 24/12/2014 | |
BORME-A-2014-231-28 | Madrid | 03/12/2014 | |
BORME-A-2014-199-28 | Madrid | 17/10/2014 | |
BORME-A-2013-197-28 | Madrid | 15/10/2013 | |
BORME-A-2012-217-28 | Madrid | 13/11/2012 | |
BORME-A-2012-125-28 | Madrid | 03/07/2012 | |
BORME-A-2012-56-28 | Madrid | 21/03/2012 | |
BORME-A-2012-9-28 | Madrid | 13/01/2012 | |
BORME-A-2011-191-28 | Madrid | 06/10/2011 | |
BORME-A-2011-147-28 | Madrid | 03/08/2011 | |
BORME-A-2010-209-28 | Madrid | 29/10/2010 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades