Última actualización: 4 de Enero de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 6 años, 3 meses |
---|---|
NIF | G41132192 |
Provincia | Sevilla |
Capital social | 10.000.007,9 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Miem.Com.Ej. | Vela Quiroga Juan | 29/10/2012 | 04/01/2018 |
Consejero | Oleicola El Tejar Nuestra Señora De Araceli SCL | 06/08/2014 | 04/01/2018 |
Consejero | Morales Moreno Antonio | 29/10/2012 | 04/01/2018 |
Miem.Com.Ej. | Millan Marquez Pablo | 29/10/2012 | 04/01/2018 |
Consejero | Millan Marquez Pablo | 29/10/2012 | 04/01/2018 |
Consejero | Millan Marquez Pablo | 24/08/2016 | 04/01/2018 |
Vicpres C.E | Lamaignere SL | 03/02/2016 | 04/01/2018 |
Presidente | Lamaignere SL | 06/08/2014 | 04/01/2018 |
Presidente | Lamaignere SL | 29/10/2012 | 04/01/2018 |
Pres.Com.Ej. | Lamaignere SL | 29/10/2012 | 04/01/2018 |
Apoderado | Hernandez Navarro Jose Ignacio | 17/03/2016 | 04/01/2018 |
SecreNoConsj | Gonzalez Gonzalez Manuel Jesus | 22/09/2015 | 04/01/2018 |
Apo.Sol. | Garcia Molina Cesar | 10/02/2014 | 04/01/2018 |
Consejero | Confederacion De Empresarios De Cordoba | 06/08/2014 | 04/01/2018 |
Consejero | Camara Oficial De Comercio Industria Y Navegacion | 06/08/2014 | 04/01/2018 |
Consejero | Caja Rural Del Sur S Coop De Credito | 29/10/2012 | 04/01/2018 |
Consejero | Caja Rural De Almendralejo Sociedad Cooperativa De | 24/08/2016 | 04/01/2018 |
Consejero | Caja Rural De Almendralejo Sociedad Cooperativa De | 29/10/2012 | 04/01/2018 |
Consejero | Banco Mare Nostrum SA | 06/08/2014 | 04/01/2018 |
Miem.Com.Ej. | Ballester Almadana Jose Luis | 05/02/2014 | 04/01/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Sociedad De Garantia Reciproca De Andalucia Suraval .
04
Ene 2018
Con fecha 04/01/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 685 , F 162, S 8, H SE 10026, I/A 122
04
Ene 2018
Con fecha 04/01/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 685 , F 162, S 8, H SE 10026, I/A 122
15
Dic 2017
Extendida con fecha 15 de diciembre de 2017, nota de cierre provisional a que se refiere el artículo 231 del R.R.M.. por la fusion por creacion de una nueva sociedad, que implia la fusion de esta compañía y otra sociedad, domiciliada en Granada, por una socieddd de nueva creación.
Datos registrales: T 685 , F 162, S 8, H SE 10026, I/A 121 b
31
Oct 2017
Con fecha 31/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Grupo Bc De Asesoria Hipotecaria SL |
Datos registrales: T 685 , F 162, S 8, H SE 10026, I/A 121
12
Abr 2017
"CAJA RURAL DEL SUR S COOP DE CREDITO" DESIGNA COMO REPRESENTANTE PERSONA FISICA PARA EL EJERCICIO DEL CARGO DE CONSEJERO A D. JOSE CARLOS LAGARES MEDINA.-
Datos registrales: T 685 , F 161, S 8, H SE 10026, I/A 120
12
Abr 2017
Con fecha 12/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Miem.Com.Ej. | Vela Quiroga Juan |
Miem.Com.Ej. | Morales Moreno Antonio |
Miem.Com.Ej. | Millan Marquez Pablo |
Miem.Com.Ej. | Junta De Andalucia |
Miem.Com.Ej. | Caja Rural Del Sur S Coop De Credito |
Datos registrales: T 685 , F 161, S 8, H SE 10026, I/A 120
12
Abr 2017
"CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE JEREZ DE LA FRONTERA" DESIGNA COMO REPRESENTANTE PERSONA FISICA A DON JAVIER SANCHEZ ROJAS.-
Datos registrales: T 685 , F 161, S 8, H SE 10026, I/A 119
12
Abr 2017
Con fecha 12/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Camara Oficial De Comercio E Industria De Jerez De |
Datos registrales: T 685 , F 161, S 8, H SE 10026, I/A 119
11
Abr 2017
"CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE CORDOBA" C.I.F. G14024178, DESIGNA A DON ANTONIO DIAZ CORDOBA, D.N.I. 30.438.613-E, COMO REPRESENTANTE DE LA MISMA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, EN SUSTITUCION DE DON LUIS CARRETO CLAVO.-
Datos registrales: T 685 , F 161, S 8, H SE 10026, I/A 118
11
Abr 2017
Con fecha 11/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | La Electrica De Villanueva De Cordoba SA |
Datos registrales: T 685 , F 161, S 8, H SE 10026, I/A 117
11
Abr 2017
Con fecha 11/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Rodriguez Macias Juan Manuel |
Consejero | Diputacion Provincial De Cordoba |
Datos registrales: T 685 , F 160, S 8, H SE 10026, I/A 116
11
Abr 2017
Con fecha 11/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | De Pablo-Romero Y Camara Jaime |
Datos registrales: T 685 , F 160, S 8, H SE 10026, I/A 115
10
Feb 2017
SE SUSTITUYE A DON DAVID ALVA RODRIGUEZ POR DON MIGUEL RUS PALACIOS, EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA DE ANDALUCIA SURAVAL.
Datos registrales: T 685 , F 160, S 8, H SE 10026, I/A 114
22
Sep 2016
Con fecha 22/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Tornero Cereijo Javier |
Apo.Sol. | Suarez Gonzalez Manuel |
Apo.Sol. | Olmo Morales Pedro |
Apo.Sol. | Gonzalez Fernandez Jose Ramon |
Apo.Sol. | Fuentes Mora Manuel |
Apo.Sol. | Arellano Barroso Cristobal |
Datos registrales: T 685 , F 159, S 8, H SE 10026, I/A 113
24
Ago 2016
Con fecha 24/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Vela Quiroga Juan |
Consejero | Morales Moreno Antonio |
Consejero | Millan Marquez Pablo |
Consejero | Junta De Andalucia |
Consejero | Caja Rural Del Sur S Coop De Credito |
Consejero | Caja Rural De Almendralejo Sociedad Cooperativa De |
Datos registrales: T 685 , F 158, S 8, H SE 10026, I/A 112
24
Ago 2016
Con fecha 24/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Trujillo Ponce Antonio |
Datos registrales: T 685 , F 158, S 8, H SE 10026, I/A 112
24
Ago 2016
Con fecha 24/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Oleicola El Tejar Nuestra Señora De Araceli SCL |
Consejero | Grupo De Empresas Cajasur SA |
Consejero | Federacion Onubense Empresarios |
Consejero | Diputacion Provincial De Malaga |
Consejero | Diaz Cordoba Antonio |
Consejero | Candau Garcia Ignacio |
Consejero | Banco Mare Nostrum SA |
Datos registrales: T 685 , F 158, S 8, H SE 10026, I/A 112
02
Ago 2016
NOMBRAMIENTO de DOÑA CLARA LAURA CARDONE RIPORTELLA, como representante físico de la JUNTA DE ANDALUCIA, en sustitución de D. Juan Francisco Sánchez García.
Datos registrales: T 685 , F 158, S 8, H SE 10026, I/A 110
02
Ago 2016
Con fecha 02/08/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 685 , F 158, S 8, H SE 10026, I/A 111
21
Jul 2016
Con fecha 21/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gonzalez Gonzalez Manuel J |
Datos registrales: T 685 , F 157, S 8, H SE 10026, I/A 109
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-8-41 | Sevilla | 11/01/2018 | |
BORME-A-2017-242-41 | Sevilla | 22/12/2017 | |
BORME-A-2017-213-41 | Sevilla | 08/11/2017 | |
BORME-A-2017-212-41 | Sevilla | 07/11/2017 | |
BORME-A-2017-76-41 | Sevilla | 21/04/2017 | |
BORME-A-2017-75-41 | Sevilla | 20/04/2017 | |
BORME-A-2017-36-41 | Sevilla | 21/02/2017 | |
BORME-A-2016-187-41 | Sevilla | 29/09/2016 | |
BORME-A-2016-174-41 | Sevilla | 12/09/2016 | |
BORME-A-2016-153-41 | Sevilla | 11/08/2016 | |
BORME-A-2016-152-41 | Sevilla | 10/08/2016 | |
BORME-A-2016-145-41 | Sevilla | 01/08/2016 | |
BORME-A-2016-143-41 | Sevilla | 28/07/2016 | |
BORME-A-2016-137-41 | Sevilla | 19/07/2016 | |
BORME-A-2016-128-41 | Sevilla | 06/07/2016 | |
BORME-A-2016-60-41 | Sevilla | 30/03/2016 | |
BORME-A-2016-30-41 | Sevilla | 15/02/2016 | |
BORME-A-2015-199-41 | Sevilla | 19/10/2015 | |
BORME-A-2015-42-41 | Sevilla | 03/03/2015 | |
BORME-A-2014-232-41 | Sevilla | 04/12/2014 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades