Última actualización: 10 de Enero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B08111569 |
Denominación anterior | Peguform Iberica SL |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 20.213.643,35 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Calvo Gutierrez Jesus Javier | 10/01/2024 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Rodriguez Pajin Javier | 03/11/2023 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Ernst & Young SL | 20/02/2023 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Ernst & Young SL | 12/04/2022 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Ernst & Young SL | 24/02/2022 | Actualidad |
CONSEJERO | Vipin Jain | 19/01/2021 | Actualidad |
CONSEJERO | Cezary Zawadzinski | 31/10/2019 | Actualidad |
CONS. DELEG. | Andreas Heuser | 23/03/2018 | Actualidad |
PRESIDENTE | Andreas Heuser | 20/12/2017 | Actualidad |
CONSEJERO | Andreas Heuser | 20/12/2017 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Ernst & Young SL | 26/10/2017 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 23/12/2016 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 25/06/2015 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 13/06/2014 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Soto Torres Carlos | 06/05/2014 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Marin Garcia Gregorio | 06/05/2014 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Hernandez Menendez Diego | 06/05/2014 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 10/07/2012 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Pelayo Muñoz Miguel | 01/12/2010 | Actualidad |
APODERADO | Calvo Gutierrez Jesus Javier | 09/11/2009 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJERO | Peter Vollprecht | 20/12/2017 | 19/01/2021 |
CONS. DELEG. | Peter Vollprecht | 23/03/2018 | 19/01/2021 |
CONSEJERO | Bimal Dhar | 20/12/2017 | 31/10/2019 |
CONSEJERO | Peter Vollprecht | 30/01/2014 | 20/12/2017 |
CONS. DELEG. | Peter Vollprecht | 06/05/2014 | 20/12/2017 |
CONSEJERO | Bimal Dhar | 16/01/2013 | 20/12/2017 |
PRESIDENTE | Andreas Heuser | 11/05/2012 | 20/12/2017 |
CONSEJERO | Andreas Heuser | 11/05/2012 | 20/12/2017 |
CONS. DELEG. | Andreas Heuser | 28/09/2012 | 20/12/2017 |
APODERADO | Robert Buti Jose Maria | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Robert Buti Jose Maria | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Perez Solana Felix | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Perez Solana Felix | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Perez Solana Felix | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Liebsch Dieter | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Garcia Terron Pedro Angel | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Franco Suarez Francisco Fernando | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Borrull Bori Francesc | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Borrull Bori Francesc | Desconocido | 15/06/2017 |
APODERADO | Borrull Bori Francesc | Desconocido | 15/06/2017 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Smp Automotive Technology Iberica SL.
10
Ene 2024
Con fecha 10/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Calvo Gutierrez Jesus Javier |
Datos registrales: T 44167 , F 178, S 8, H B 65082, I/A 154
14
Nov 2023
CAMBIO DE SOCIO UNICO. NUEVO SOCIO UNICO: SMRC AUTOMOTIVE HOLDINGS NETHERLANDS B.V.
Datos registrales: T 44167 , F 178, S 8, H B 65082, I/A 153
03
Nov 2023
Con fecha 03/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Rodriguez Pajin Javier |
Datos registrales: T 44167 , F 177, S 8, H B 65082, I/A 152
20
Feb 2023
Con fecha 20/02/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 44167 , F 177, S 8, H B 65082, I/A 151
12
Abr 2022
Con fecha 12/04/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 44167 , F 176, S 8, H B 65082, I/A 150
24
Feb 2022
Con fecha 24/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 44167 , F 176, S 8, H B 65082, I/A 149
14
Feb 2022
Con fecha 14/02/2022, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 25.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 44167 , F 176, S 8, H B 65082, I/A 148
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Vipin Jain |
Datos registrales: T 44167 , F 176, S 8, H B 65082, I/A 147
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Peter Vollprecht |
Datos registrales: T 44167 , F 176, S 8, H B 65082, I/A 147
31
Oct 2019
Con fecha 31/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Cezary Zawadzinski |
Datos registrales: T 44167 , F 175, S 8, H B 65082, I/A 146
31
Oct 2019
Con fecha 31/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Bimal Dhar |
Datos registrales: T 44167 , F 175, S 8, H B 65082, I/A 146
23
Mar 2018
Con fecha 23/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Peter Vollprecht |
CONS. DELEG. | Andreas Heuser |
Datos registrales: T 44167 , F 175, S 8, H B 65082, I/A 145
20
Dic 2017
Con fecha 20/12/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 23 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 44167 , F 175, S 8, H B 65082, I/A 144
20
Dic 2017
Con fecha 20/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Peter Vollprecht |
CONSEJERO | Bimal Dhar |
PRESIDENTE | Andreas Heuser |
Datos registrales: T 44167 , F 175, S 8, H B 65082, I/A 144
20
Dic 2017
Con fecha 20/12/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Peter Vollprecht |
CONSEJERO | Bimal Dhar |
PRESIDENTE | Andreas Heuser |
Datos registrales: T 44167 , F 175, S 8, H B 65082, I/A 144
26
Oct 2017
Con fecha 26/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 44167 , F 174, S 8, H B 65082, I/A 143
28
Jun 2017
Con fecha 28/06/2017, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 1.999.995,78 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 10.98% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 20.213.643,35€.
Datos registrales: T 44167 , F 174, S 8, H B 65082, I/A 142
28
Jun 2017
Con fecha 28/06/2017, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 3.999.997,57 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 28.14% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 18.213.647,57€.
Datos registrales: T 44167 , F 173, S 8, H B 65082, I/A 141
15
Jun 2017
Con fecha 15/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Robert Buti Jose Maria |
APODERADO | Perez Solana Felix |
APODERADO | Liebsch Dieter |
APODERADO | Garcia Terron Pedro Angel |
APODERADO | Franco Suarez Francisco Fernando |
APODERADO | Borrull Bori Francesc |
Datos registrales: T 44167 , F 173, S 8, H B 65082, I/A 140
23
Dic 2016
Con fecha 23/12/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 44167 , F 173, S 8, H B 65082, I/A 139
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-12-08 | Barcelona | 17/01/2024 | |
BORME-A-2023-221-08 | Barcelona | 21/11/2023 | |
BORME-A-2023-216-08 | Barcelona | 14/11/2023 | |
BORME-A-2023-40-08 | Barcelona | 27/02/2023 | |
BORME-A-2022-76-08 | Barcelona | 21/04/2022 | |
BORME-A-2022-45-08 | Barcelona | 07/03/2022 | |
BORME-A-2022-35-08 | Barcelona | 21/02/2022 | |
BORME-A-2021-17-08 | Barcelona | 27/01/2021 | |
BORME-A-2019-216-08 | Barcelona | 11/11/2019 | |
BORME-A-2018-65-08 | Barcelona | 04/04/2018 | |
BORME-A-2017-246-08 | Barcelona | 29/12/2017 | |
BORME-A-2017-211-08 | Barcelona | 06/11/2017 | |
BORME-A-2017-126-08 | Barcelona | 05/07/2017 | |
BORME-A-2017-119-08 | Barcelona | 26/06/2017 | |
BORME-A-2017-3-08 | Barcelona | 04/01/2017 | |
BORME-A-2015-124-08 | Barcelona | 03/07/2015 | |
BORME-A-2014-237-08 | Barcelona | 12/12/2014 | |
BORME-A-2014-117-08 | Barcelona | 24/06/2014 | |
BORME-A-2014-89-08 | Barcelona | 13/05/2014 | |
BORME-A-2014-34-08 | Barcelona | 19/02/2014 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades