Última actualización: 31 de Agosto de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A79985974 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Quintanapalla 2 (Madrid). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Schneider Lothar | 25/08/2023 | Actualidad |
Apo.Manc. | Micheletto Giovanni | 25/08/2023 | Actualidad |
Presidente | Kummer Robert Matthias | 25/08/2023 | Actualidad |
Consejero | Kummer Robert Matthias | 25/08/2023 | Actualidad |
Cons.Del.Man | Kummer Robert Matthias | 25/08/2023 | Actualidad |
Consejero | Herzog Michael Johannes | 25/08/2023 | Actualidad |
Cons.Del.Man | Herzog Michael Johannes | 25/08/2023 | Actualidad |
Apo.Manc. | Garcia De Cuerva Rodriguez Julio | 25/08/2023 | Actualidad |
Secretario | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 25/08/2023 | Actualidad |
Consejero | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 25/08/2023 | Actualidad |
Apo.Manc. | Fernandez Menendez Francisco Javier | 25/08/2023 | Actualidad |
Apo.Manc. | Engelen Dirk | 25/08/2023 | Actualidad |
Apo.Sol. | Steingraber Claudia | 05/08/2022 | Actualidad |
Apo.Manc. | Garcia De Cuerva Julio | 05/08/2022 | Actualidad |
Apoderado | Vallejo Perez Laura | 08/03/2019 | Actualidad |
Apoderado | Garcia- Andrade Schnier Melanie | 08/03/2019 | Actualidad |
Apoderado | Diaz Paniagua Isabel | 08/03/2019 | Actualidad |
Apoderado | Bisbal Gimeno Belen | 08/03/2019 | Actualidad |
Apoderado | Benedet Perea Cristina | 08/03/2019 | Actualidad |
L. Asesor | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 09/06/2017 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Schneider Lothar | 01/03/2023 | 25/08/2023 |
Apo.Manc. | Schneider Lothar | 05/08/2022 | 25/08/2023 |
Apo.Manc. | Schneider Lothar | 22/07/2019 | 25/08/2023 |
Consejero | Herzog Michael | 18/07/2022 | 25/08/2023 |
Cons.Del.Sol | Herzog Michael | 18/07/2022 | 25/08/2023 |
Apo.Manc. | Garcia De Cuerva Rodriguez Julio | Desconocido | 25/08/2023 |
Apo.Manc. | Garcia De Cuerva Rodriguez Julio | 01/03/2023 | 25/08/2023 |
Secretario | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 18/07/2022 | 25/08/2023 |
Consejero | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 18/07/2022 | 25/08/2023 |
Apo.Manc. | Fernandez Menendez Francisco Javier | 01/03/2023 | 25/08/2023 |
Presidente | Christensen Carsten Haerup | 18/07/2022 | 25/08/2023 |
Consejero | Christensen Carsten Haerup | 18/07/2022 | 25/08/2023 |
Cons.Del.Sol | Christensen Carsten Haerup | 18/07/2022 | 25/08/2023 |
Apo.Sol. | Geissler Katja | 05/08/2022 | 01/03/2023 |
Apoderado | Schulz Nathalie Yvonne Suzanne | 21/02/2022 | 05/08/2022 |
Apoderado | Schneider Lothar | Desconocido | 05/08/2022 |
Apo.Manc. | Bayo Mendivil Helena | 22/07/2019 | 05/08/2022 |
Consejero | Fruhbeck Olmedo Guillermo | 21/07/2020 | 18/07/2022 |
Presidente | Christensen Carsten Haerup | 21/07/2020 | 18/07/2022 |
Consejero | Christensen Carsten Haerup | 21/07/2020 | 18/07/2022 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Sig Combibloc SA.
31
Ago 2023
Conversión de las acciones al portador en acciones nominativas.
Datos registrales: T 45619 , F 201, S 8, H M 22411, I/A 73
31
Ago 2023
Con fecha 31/08/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales..
Datos registrales: T 45619 , F 201, S 8, H M 22411, I/A 73
25
Ago 2023
Con fecha 25/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Schneider Lothar |
Apo.Manc. | Micheletto Giovanni |
Presidente | Kummer Robert Matthias |
Cons.Del.Man | Herzog Michael Johannes |
Apo.Manc. | Garcia De Cuerva Rodriguez Julio |
Secretario | Fruhbeck Olmedo Guillermo |
Apo.Manc. | Fernandez Menendez Francisco Javier |
Apo.Manc. | Engelen Dirk |
Datos registrales: T 33131 , F 56, S 8, H M 22411, I/A 72
25
Ago 2023
Con fecha 25/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Schneider Lothar |
Apo.Manc. | Garcia De Cuerva Rodriguez Julio |
Apo.Manc. | Fernandez Menendez Francisco Javier |
Datos registrales: T 33131 , F 56, S 8, H M 22411, I/A 72
25
Ago 2023
Con fecha 25/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Kummer Robert Matthias |
Consejero | Herzog Michael Johannes |
Consejero | Fruhbeck Olmedo Guillermo |
Datos registrales: T 33131 , F 56, S 8, H M 22411, I/A 71
25
Ago 2023
Con fecha 25/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Herzog Michael |
Consejero | Fruhbeck Olmedo Guillermo |
Consejero | Christensen Carsten Haerup |
Datos registrales: T 33131 , F 56, S 8, H M 22411, I/A 71
01
Mar 2023
Con fecha 01/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Schneider Lothar |
Apo.Manc. | Garcia De Cuerva Rodriguez Julio |
Apo.Manc. | Fernandez Menendez Francisco Javier |
Datos registrales: T 33131 , F 55, S 8, H M 22411, I/A 70
01
Mar 2023
Con fecha 01/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Geissler Katja |
Datos registrales: T 33131 , F 55, S 8, H M 22411, I/A 70
28
Feb 2023
Se subsana el error padecido en la inscripción 68ª al omitir el segundo apellido de D. JULIO GARCIA DE CUERVA RODRIGUEZ, y se indicó erróneamente el código postal de su domicilio, siendo el correcto 28260 Galapagar.
Datos registrales: T 33131 , F 55, S 8, H M 22411, I/A 69
05
Ago 2022
Con fecha 05/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Schneider Lothar |
Apo.Manc. | Garcia De Cuerva Julio |
Datos registrales: T 33131 , F 54, S 8, H M 22411, I/A 68
05
Ago 2022
Con fecha 05/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Bayo Mendivil Helena |
Datos registrales: T 33131 , F 54, S 8, H M 22411, I/A 68
05
Ago 2022
Con fecha 05/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Steingraber Claudia |
Apo.Sol. | Geissler Katja |
Datos registrales: T 33131 , F 54, S 8, H M 22411, I/A 67
05
Ago 2022
Con fecha 05/08/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Schulz Nathalie Yvonne Suzanne |
Apoderado | Schneider Lothar |
Datos registrales: T 33131 , F 54, S 8, H M 22411, I/A 67
18
Jul 2022
Con fecha 18/07/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Sol | Herzog Michael |
Secretario | Fruhbeck Olmedo Guillermo |
Cons.Del.Sol | Christensen Carsten Haerup |
Datos registrales: T 33131 , F 54, S 8, H M 22411, I/A 66
18
Jul 2022
Con fecha 18/07/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Herzog Michael |
Consejero | Fruhbeck Olmedo Guillermo |
Consejero | Christensen Carsten Haerup |
Datos registrales: T 33131 , F 53, S 8, H M 22411, I/A 65
18
Jul 2022
Con fecha 18/07/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Sol | Millinger Monika |
Cons.Del.Sol | Fruhbeck Olmedo Guillermo |
Consejero | Christensen Carsten Haerup |
Datos registrales: T 33131 , F 53, S 8, H M 22411, I/A 65
21
Feb 2022
Con fecha 21/02/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Schulz Nathalie Yvonne Suzanne |
Datos registrales: T 33131 , F 53, S 8, H M 22411, I/A 64
27
Nov 2020
Con fecha 27/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Windeln Sonja |
Apo.Manc. | Kayser Andreas Burkhard |
Datos registrales: T 33131 , F 53, S 8, H M 22411, I/A 63
21
Jul 2020
Con fecha 21/07/2020, la sociedad cambia su domicilio social a C/ QUINTANAPALLA 2 (MADRID).
Datos registrales: T 33131 , F 52, S 8, H M 22411, I/A 62
21
Jul 2020
Con fecha 21/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Sol | Millinger Monika |
Cons.Del.Sol | Fruhbeck Olmedo Guillermo |
Cons.Del.Sol | Christensen Carsten Haerup |
Datos registrales: T 33131 , F 52, S 8, H M 22411, I/A 61
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-171-28 | Madrid | 07/09/2023 | |
BORME-A-2023-167-28 | Madrid | 01/09/2023 | |
BORME-A-2023-47-28 | Madrid | 08/03/2023 | |
BORME-A-2023-46-28 | Madrid | 07/03/2023 | |
BORME-A-2022-154-28 | Madrid | 12/08/2022 | |
BORME-A-2022-141-28 | Madrid | 26/07/2022 | |
BORME-A-2022-40-28 | Madrid | 28/02/2022 | |
BORME-A-2020-234-28 | Madrid | 04/12/2020 | |
BORME-A-2020-144-28 | Madrid | 28/07/2020 | |
BORME-A-2019-143-28 | Madrid | 29/07/2019 | |
BORME-A-2019-52-28 | Madrid | 15/03/2019 | |
BORME-A-2017-115-28 | Madrid | 20/06/2017 | |
BORME-A-2017-54-28 | Madrid | 17/03/2017 | |
BORME-A-2016-186-28 | Madrid | 28/09/2016 | |
BORME-A-2016-152-28 | Madrid | 10/08/2016 | |
BORME-A-2016-47-28 | Madrid | 09/03/2016 | |
BORME-A-2016-44-28 | Madrid | 04/03/2016 | |
BORME-A-2015-33-28 | Madrid | 18/02/2015 | |
BORME-A-2014-30-28 | Madrid | 13/02/2014 | |
BORME-A-2013-226-28 | Madrid | 26/11/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades