Última actualización: 26 de Febrero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B85293421 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Av Diagonal Num.467 P.6 Pta.2 (Barcelona). |
Objeto social | La adquisicion,enajenacion,tenencia,explotacion y promocion de bienes inmuebles de naturaleza urbana,incluyendose en dicho concepto las naves industriales y logisticas,para su arrendamiento. |
Capital social | 7.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 26/02/2024 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Johansson Moreno Miriam | 19/05/2020 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Avq Legal SLP | 19/05/2020 | Actualidad |
Apo.Manc. | Simonetti Marco | 18/04/2016 | Actualidad |
Apo.Manc. | Derkenne Cyril | 18/04/2016 | Actualidad |
Apo.Manc. | Bougrain Jeremie | 18/04/2016 | Actualidad |
SecreNoConsj | Baboulene Brigitte | 18/04/2016 | Actualidad |
Consejero | Alcazar Pascual David | 18/04/2016 | Actualidad |
Co.De.Ma.So | Alcazar Pascual David | 18/04/2016 | Actualidad |
Apoderado | Simonetti Marco | 22/03/2016 | Actualidad |
Apoderado | Derkenne Cyril Bruno | 22/03/2016 | Actualidad |
Apoderado | Alcazar Pascual David | 22/03/2016 | Actualidad |
Presidente | Simonetti Marco | 11/03/2010 | Actualidad |
Consejero | Simonetti Marco | 21/09/2009 | Actualidad |
Consejero | Peters Ann Octavia | 21/07/2009 | Actualidad |
SecreNoConsj | Konig Elisabeth | 21/07/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECR.NO CONS | Curto Marti Carlos | 27/06/2018 | 19/05/2020 |
APODERAD.SOL | Stephane Pierre Marie Deruy | Desconocido | 26/04/2019 |
SECR.NO CONS | Brigitte Baboulene | Desconocido | 27/06/2018 |
Apo.Man.Soli | Simonetti Marco | 28/10/2009 | 18/04/2016 |
SecreNoConsj | Serrano Alonso Carolina | 22/11/2012 | 18/04/2016 |
Apo.Sol. | Sanchez Weickgennant Cristina | 21/07/2009 | 18/04/2016 |
Apo.Sol. | Puente Orench Jose | 21/07/2009 | 18/04/2016 |
Consejero | Pilsworth Andrew | 11/08/2015 | 18/04/2016 |
Apo.Manc. | Peters Ann Octavia | 28/10/2009 | 18/04/2016 |
Apoderado | Miroglio My Lan | 13/01/2010 | 18/04/2016 |
Apoderado | Mant Trevor | Desconocido | 18/04/2016 |
Apo.Sol. | Konig Elisabeth | 21/07/2009 | 18/04/2016 |
Apo.Sol. | Hermida Santos Francisco | 21/07/2009 | 18/04/2016 |
Apo.Manc. | Giard Laurence | 28/10/2009 | 18/04/2016 |
Apo.Sol. | Beneyto Perez Cerda Jose Maria | 21/07/2009 | 18/04/2016 |
Consejero | Giard Laurence | 21/07/2009 | 11/08/2015 |
Secretario | Konig Elisabeth | Desconocido | 22/11/2012 |
Apoderado | Reinmann Ines | Desconocido | 11/03/2010 |
Presidente | Reinmann Archer Ines | 21/07/2009 | 11/03/2010 |
Con.Delegado | Reinmann Archer Ines | 21/07/2009 | 11/03/2010 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Segro Properties Spain SL.
26
Feb 2024
Con fecha 26/02/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45576 , F 102, S 8, H B 492386, I/A 24
10
Ene 2023
Con fecha 10/01/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ADICION DEL ART.16 BIS.-REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE MANERA TELEMATICA.
Datos registrales: T 45576 , F 102, S 8, H B 492386, I/A 23
10
Ene 2023
Con fecha 10/01/2023, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 1.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 16.67% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 7.000,0€.
Datos registrales: T 45576 , F 102, S 8, H B 492386, I/A 23
19
May 2020
Con fecha 19/05/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Johansson Moreno Miriam |
SECR.NO CONS | Avq Legal SLP |
Datos registrales: T 45576 , F 101, S 8, H B 492386, I/A 22
19
May 2020
Con fecha 19/05/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Curto Marti Carlos |
Datos registrales: T 45576 , F 101, S 8, H B 492386, I/A 22
26
Abr 2019
Con fecha 26/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Stephane Pierre Marie Deruy |
Datos registrales: T 45576 , F 101, S 8, H B 492386, I/A 21
27
Jun 2018
Con fecha 27/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Curto Marti Carlos |
Datos registrales: T 45576 , F 101, S 8, H B 492386, I/A 20
27
Jun 2018
Con fecha 27/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Brigitte Baboulene |
Datos registrales: T 45576 , F 101, S 8, H B 492386, I/A 20
27
Dic 2017
SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: SEGRO PLC.
Datos registrales: T 45576 , F 101, S 8, H B 492386, I/A 19
10
Nov 2017
Con fecha 10/11/2017, la sociedad cambia su actividad a:
LA ADQUISICION,ENAJENACION,TENENCIA,EXPLOTACION Y PROMOCION DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA,INCLUYENDOSE EN DICHO CONCEPTO LAS NAVES INDUSTRIALES Y LOGISTICAS,PARA SU ARRENDAMIENTO.
Datos registrales: T 45576 , F 100, S 8, H B 492386, I/A 18
10
Nov 2017
ACOGIMIENTO DE LA SOCIEDAD AL REGIMEN FISCAL PREVISTO EN LA LEY 11/2009 DE 26 DE OCTUBRE,POR LA QUE SE REGULAN LAS SOCIEDADES ANONIMAS COTIZADAS DE INVERSION EN EL MERCADO INMOBILIARIO (SOCIMI'S).
Datos registrales: T 45576 , F 100, S 8, H B 492386, I/A 18
10
Nov 2017
Con fecha 10/11/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ADICION DEL ARTICULO 25 A LOS ESTATUTOS SOCIALES. DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS.
Datos registrales: T 45576 , F 100, S 8, H B 492386, I/A 18
04
Oct 2016
Con fecha 04/10/2016, la sociedad cambia su actividad a:
REALIZACION DE OPERACIONES INMOBILIARIAS, COMPRA, VENTA, ADQUISICION, TENENCIA, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y EN PARTICULAR DE OFICINAS, PARCELAS Y NAVES INDUSTRIALES Y LOGISTICAS,ETC.
Datos registrales: T 45576 , F 99, S 8, H B 492386, I/A 17
04
Oct 2016
Con fecha 04/10/2016, la sociedad cambia su domicilio social a AV DIAGONAL Num.467 P.6 PTA.2 (BARCELONA).
Datos registrales: T 45576 , F 99, S 8, H B 492386, I/A 17
18
Abr 2016
Con fecha 18/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Simonetti Marco |
Apo.Manc. | Derkenne Cyril |
Apo.Manc. | Bougrain Jeremie |
SecreNoConsj | Baboulene Brigitte |
Consejero | Alcazar Pascual David |
Datos registrales: T 27321 , F 102, S 8, H M 452066, I/A 16
18
Abr 2016
Con fecha 18/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Simonetti Marco |
Apo.Sol. | Sanchez Weickgennant Cristina |
Apo.Sol. | Puente Orench Jose |
Apo.Manc. | Peters Ann Octavia |
Apoderado | Miroglio My Lan |
Apoderado | Mant Trevor |
Apo.Sol. | Konig Elisabeth |
Apo.Sol. | Hermida Santos Francisco |
Apo.Manc. | Giard Laurence |
Apo.Sol. | Beneyto Perez Cerda Jose Maria |
Datos registrales: T 27321 , F 102, S 8, H M 452066, I/A 16
18
Abr 2016
Con fecha 18/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Serrano Alonso Carolina |
Consejero | Pilsworth Andrew |
Datos registrales: T 27321 , F 102, S 8, H M 452066, I/A 16
22
Mar 2016
Con fecha 22/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Simonetti Marco |
Apoderado | Derkenne Cyril Bruno |
Apoderado | Alcazar Pascual David |
Datos registrales: T 27321 , F 101, S 8, H M 452066, I/A 15
11
Ago 2015
Con fecha 11/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Pilsworth Andrew |
Datos registrales: T 27321 , F 101, S 8, H M 452066, I/A 14
11
Ago 2015
Con fecha 11/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Giard Laurence |
Datos registrales: T 27321 , F 101, S 8, H M 452066, I/A 14
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2024-47-08 | Barcelona | 06/03/2024 |
BORME-A-2023-11-08 | Barcelona | 17/01/2023 |
BORME-A-2020-102-08 | Barcelona | 29/05/2020 |
BORME-A-2019-86-08 | Barcelona | 08/05/2019 |
BORME-A-2018-128-08 | Barcelona | 05/07/2018 |
BORME-A-2018-3-08 | Barcelona | 04/01/2018 |
BORME-A-2017-219-08 | Barcelona | 17/11/2017 |
BORME-A-2016-198-08 | Barcelona | 17/10/2016 |
BORME-A-2016-78-28 | Madrid | 25/04/2016 |
BORME-A-2016-64-28 | Madrid | 05/04/2016 |
BORME-A-2015-160-28 | Madrid | 24/08/2015 |
BORME-A-2012-232-28 | Madrid | 04/12/2012 |
BORME-A-2010-57-28 | Madrid | 25/03/2010 |
BORME-A-2010-15-28 | Madrid | 25/01/2010 |
BORME-A-2009-214-28 | Madrid | 10/11/2009 |
BORME-A-2009-188-28 | Madrid | 01/10/2009 |
BORME-A-2009-143-28 | Madrid | 30/07/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades