Última actualización: 13 de Junio de 2017
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 6 años, 9 meses |
---|---|
Forma jurídica | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
NIF | W0042937C |
Denominación anterior | Seb Investment GMBH |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Alfonso Xii, 30, 1º (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Wandel Tom | 14/06/2013 | 13/06/2017 |
Apo.Manc. | Wandel Tom | 04/08/2011 | 13/06/2017 |
Apoderado | Von Groddeck Carolina Isa Katharina | 14/06/2013 | 13/06/2017 |
Apo.Manc. | Von Groddeck Carolina Isa Katharina | 04/08/2011 | 13/06/2017 |
Apoderado | Schlenkrich Christin Pia | 14/06/2013 | 13/06/2017 |
Apo.Manc. | Reinmuth Michael | 04/08/2011 | 13/06/2017 |
Apoderado | Pfundstein Rita Maria | 14/06/2013 | 13/06/2017 |
Apoderado | Ostrovska Anna | 14/06/2013 | 13/06/2017 |
Apoderado | Monereo Velasco Andres | 26/05/2015 | 13/06/2017 |
Apoderado | Monereo Meyer & Marinel-Lo Abogados SL | 27/11/2009 | 13/06/2017 |
Apoderado | Monereo Meyer & Marinel-Lo Abogados SL | 26/05/2015 | 13/06/2017 |
Liquidador | Meyer Stefan | 13/06/2017 | 13/06/2017 |
Apoderado | Meyer Stefan | 26/05/2015 | 13/06/2017 |
Apoderado | Menzel Matthias Max | 14/06/2013 | 13/06/2017 |
Apoderado | Lopez Ramos Maria Jose | 26/05/2015 | 13/06/2017 |
Apoderado | Kraus Axel | 14/06/2013 | 13/06/2017 |
Apo.Manc. | Kraus Axel | 04/08/2011 | 13/06/2017 |
Apo.Manc. | Gies Axel | 04/08/2011 | 13/06/2017 |
Apoderado | Fernandez Valenciano Ana Isabel | 26/05/2015 | 13/06/2017 |
Apo.Manc. | Illgen Reindl Robert Martin | 05/09/2013 | 13/10/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Savills Fund Management GMBH.
13
Jun 2017
Con fecha 13/06/2017 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 28756 , F 214, S 8, H M 309108, I/A 24
13
Jun 2017
Con fecha 13/06/2017 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 28756 , F 214, S 8, H M 309108, I/A 24
13
Jun 2017
Con fecha 13/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Meyer Stefan |
Datos registrales: T 28756 , F 214, S 8, H M 309108, I/A 24
13
Jun 2017
Con fecha 13/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Wandel Tom |
Apoderado | Von Groddeck Carolina Isa Katharina |
Apoderado | Schlenkrich Christin Pia |
Apo.Manc. | Reinmuth Michael |
Apoderado | Pfundstein Rita Maria |
Apoderado | Ostrovska Anna |
Apoderado | Monereo Velasco Andres |
Apoderado | Monereo Meyer & Marinel-Lo Abogados SL |
Apoderado | Meyer Stefan |
Apoderado | Menzel Matthias Max |
Apoderado | Lopez Ramos Maria Jose |
Apo.Manc. | Kraus Axel |
Apo.Manc. | Gies Axel |
Apoderado | Fernandez Valenciano Ana Isabel |
Datos registrales: T 28756 , F 214, S 8, H M 309108, I/A 24
13
Oct 2016
Con fecha 13/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Illgen Reindl Robert Martin |
Datos registrales: T 28756 , F 214, S 8, H M 309108, I/A 23
08
Jul 2016
Con fecha 08/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Lienhard Daniel |
Datos registrales: T 28756 , F 214, S 8, H M 309108, I/A 22
15
Ene 2016
Con fecha 15/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Chua Choy Soon |
Apoderado | Cbre Real Estate SA |
Datos registrales: T 28756 , F 213, S 8, H M 309108, I/A 21
13
Nov 2015
Con fecha 13/11/2015, la sociedad cambia su denominación social a SAVILLS FUND MANAGEMENT GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Datos registrales: T 28756 , F 213, S 8, H M 309108, I/A 20
13
Nov 2015
CONSTANCIA DE QUE EL NIF DE LA SOCIEDAD MATRIZ SAVILLS FUND MANAGEMENT GMBH ES N0048722C.
Datos registrales: T 28756 , F 213, S 8, H M 309108, I/A 20
27
Jul 2015
Con fecha 27/07/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Knoflach Barbara Antonia |
Apoderado | Hanke Rudiger Carl Gerhard |
Datos registrales: T 28756 , F 213, S 8, H M 309108, I/A 19
26
May 2015
Con fecha 26/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Monereo Velasco Andres |
Apoderado | Monereo Meyer & Marinel-Lo Abogados SL |
Apoderado | Meyer Stefan |
Apoderado | Lopez Ramos Maria Jose |
Apoderado | Fernandez Valenciano Ana Isabel |
Datos registrales: T 28756 , F 212, S 8, H M 309108, I/A 18
05
Sep 2013
Con fecha 05/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Lienhard Daniel |
Apo.Manc. | Illgen Reindl Robert Martin |
Datos registrales: T 28756 , F 211, S 8, H M 309108, I/A 17
05
Sep 2013
Con fecha 05/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Brezina Martina |
Datos registrales: T 28756 , F 211, S 8, H M 309108, I/A 17
14
Jun 2013
Con fecha 14/06/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Wandel Tom |
Apoderado | Von Groddeck Carolina Isa Katharina |
Apoderado | Schlenkrich Christin Pia |
Apoderado | Pfundstein Rita Maria |
Apoderado | Ostrovska Anna |
Apoderado | Menzel Matthias Max |
Apoderado | Kraus Axel |
Apoderado | Knoflach Barbara Antonia |
Apoderado | Hanke Rudiger Carl Gerhard |
Datos registrales: T 28756 , F 209, S 8, H M 309108, I/A 16
14
Jun 2013
Con fecha 14/06/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Trageser Jennifer |
Apoderado | Pfundstein Rita |
Apoderado | Meyer Horst |
Apoderado | Lohrey Sabine |
Datos registrales: T 28756 , F 209, S 8, H M 309108, I/A 16
17
Ene 2013
Con fecha 17/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Cbre Real Estate SA |
Datos registrales: T 28756 , F 208, S 8, H M 309108, I/A 15
17
Ene 2013
Con fecha 17/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Cb Richard Ellis SA |
Datos registrales: T 28756 , F 208, S 8, H M 309108, I/A 15
01
Jun 2012
Con fecha 01/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Cb Richard Ellis SA |
Datos registrales: T 28756 , F 208, S 8, H M 309108, I/A 14
11
Oct 2011
Con fecha 11/10/2011, la sociedad cambia su domicilio social a C/ ALFONSO XII, 30, 1º (MADRID).
Datos registrales: T 28756 , F 207, S 8, H M 309108, I/A 13
04
Ago 2011
Con fecha 04/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Wandel Tom |
Apo.Manc. | Von Groddeck Carolina Isa Katharina |
Apo.Manc. | Reinmuth Michael |
Apo.Manc. | Kraus Axel |
Apo.Manc. | Knoflach Barbara Antonia |
Apo.Manc. | Gies Axel |
Apo.Manc. | Chua Choy Soon |
Apo.Manc. | Brezina Martina |
Datos registrales: T 28756 , F 205, S 8, H M 309108, I/A 12
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2017-118-28 | Madrid | 23/06/2017 |
BORME-A-2016-202-28 | Madrid | 21/10/2016 |
BORME-A-2016-136-28 | Madrid | 18/07/2016 |
BORME-A-2016-15-28 | Madrid | 25/01/2016 |
BORME-A-2015-223-28 | Madrid | 23/11/2015 |
BORME-A-2015-145-28 | Madrid | 03/08/2015 |
BORME-A-2015-103-28 | Madrid | 03/06/2015 |
BORME-A-2013-174-28 | Madrid | 12/09/2013 |
BORME-A-2013-117-28 | Madrid | 24/06/2013 |
BORME-A-2013-17-28 | Madrid | 25/01/2013 |
BORME-A-2012-111-28 | Madrid | 13/06/2012 |
BORME-A-2011-201-28 | Madrid | 21/10/2011 |
BORME-A-2011-157-28 | Madrid | 18/08/2011 |
BORME-A-2010-21-28 | Madrid | 02/02/2010 |
BORME-A-2009-235-28 | Madrid | 10/12/2009 |
BORME-A-2009-104-28 | Madrid | 04/06/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades