info Información

La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.

Información de la compañía
Situación Mercantil Extinguida desde hace 3 años, 3 meses
Provincia Madrid
Cargos directivos
La sociedad está inactiva.
Mostrar cargos directivos no vigentes
Cargos directivos no vigentes
Cargo Persona física/jurídica Desde Hasta
Apo.Sol. Waring Danielle 25/06/2020 19/01/2021
Apo.Sol. Villanueva Cristobal Raul 20/08/2015 19/01/2021
Apo.Sol. Shaw Sharron 25/06/2020 19/01/2021
Apo.Sol. Scott Elaine 25/06/2020 19/01/2021
Apoderado Sanchez Lopez Silvia Maria 20/09/2016 19/01/2021
Apo.Sol. Sanchez Carnicero Jose-Luis 20/08/2015 19/01/2021
Apoderado Ruiz Sanchez David 17/07/2015 19/01/2021
Apoderado Ruiberriz De Torres Loreto 20/09/2016 19/01/2021
Apo.Sol. Morris Thea 25/06/2020 19/01/2021
Apo.Sol. Mahoney Kevin 25/06/2020 19/01/2021
Apo.Sol. Escudero Mendez Juan Francisco 20/08/2015 19/01/2021
Apoderado Del Rio Diaz De Espada Cristina 22/02/2013 19/01/2021
R.L.C.Perma. Coletta Christian-Michele 23/09/2019 19/01/2021
Apo.Sol. Byrne Lyndsey 25/06/2020 19/01/2021
Apo.Sol. Barrio Fuente Fernando 20/08/2015 19/01/2021
Apo.Sol. Austin Jessica 25/06/2020 19/01/2021
Apoderado Arruabarrena De Paz Diana 06/02/2014 19/01/2021
Representan Almazan Gomez Ignacio 16/02/2016 19/01/2021
Apoderado Almazan Gomez Ignacio 25/03/2014 19/01/2021
R.L.C.Perma. Almazan Gomez Ignacio 07/02/2018 23/09/2019
Ver más
Anuncios Anuncios Mercantiles

Relación de inscripciones

Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Royal & Sun Alliance Insurance Plc, .

19

Ene 2021

Extinción

Con fecha 19/01/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.


PDF Anuncio nº 35801 de 2021

Datos registrales: T 26176 , F 219, S 8, H M 471795, I/A 31

19

Ene 2021

Ceses/Dimisiones

Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
R.L.C.Perma. Coletta Christian-Michele

PDF Anuncio nº 35801 de 2021

Datos registrales: T 26176 , F 219, S 8, H M 471795, I/A 31

25

Jun 2020

Nombramientos

Con fecha 25/06/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Waring Danielle
Apo.Sol. Shaw Sharron
Apo.Sol. Scott Elaine
Apo.Sol. Morris Thea
Apo.Sol. Mahoney Kevin
Apo.Sol. Byrne Lyndsey
Apo.Sol. Austin Jessica

PDF Anuncio nº 202698 de 2020

Datos registrales: T 26176 , F 218, S 8, H M 471795, I/A 30

23

Sep 2019

Nombramientos

Con fecha 23/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
R.L.C.Perma. Coletta Christian-Michele

PDF Anuncio nº 405961 de 2019

Datos registrales: T 26176 , F 217, S 8, H M 471795, I/A 29

23

Sep 2019

Ceses/Dimisiones

Con fecha 23/09/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
R.L.C.Perma. Almazan Gomez Ignacio

PDF Anuncio nº 405961 de 2019

Datos registrales: T 26176 , F 217, S 8, H M 471795, I/A 29

20

Nov 2018

Otros conceptos

Los miembros actuales del Organo de Administración de la Sociedad matriz de esta Sucursal, son los siguientes: ANTHONY BUCKLE, SCOTT EGAN, STEPHEN LEWIS, WILLIAM RUFUS BENJAMIN MCDONNELL Y NATHAN PHILIP WILIAMS son los CONSEJEROS de la Sociedad y ROYSUN LIMITED es el Secretario de la Sociedad.


PDF Anuncio nº 473668 de 2018

Datos registrales: T 26176 , F 216, S 8, H M 471795, I/A 28

06

Jun 2018

Otros conceptos

Los administradores de la sociedad ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, según certificado expedido el 25 de Abril de 2018, son los siguientes: SCOTT EGAN, STEPHEN LEWIS, WILLIAM RUFUS BENJAMIN MCDONNELL, NATHAN PHILIP WILLIAMS; y ROYSON LIMITED, es el Secretario de la sociedad.


PDF Anuncio nº 251411 de 2018

Datos registrales: T 26176 , F 216, S 8, H M 471795, I/A 27

07

Feb 2018

Nombramientos

Con fecha 07/02/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
R.L.C.Perma. Almazan Gomez Ignacio

PDF Anuncio nº 73229 de 2018

Datos registrales: T 26176 , F 215, S 8, H M 471795, I/A 26

08

Sep 2017

Otros conceptos

COMPOSICION DEL ACTUAL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA SUCURSAL "ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA".


PDF Anuncio nº 371847 de 2017

Datos registrales: T 26176 , F 215, S 8, H M 471795, I/A 25

05

May 2017

Otros conceptos

COMPOSICION DEL ACTUAL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA SUCURSAL "ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA".


PDF Anuncio nº 201843 de 2017

Datos registrales: T 26176 , F 214, S 8, H M 471795, I/A 24

16

Nov 2016

Otros conceptos

COMPOSICION DEL ACTUAL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA SUCURSAL "ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, SUCURSAL EN ESPAÑA".


PDF Anuncio nº 474244 de 2016

Datos registrales: T 26176 , F 214, S 8, H M 471795, I/A 23

20

Sep 2016

Nombramientos

Con fecha 20/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Ruiberriz De Torres Loreto

PDF Anuncio nº 390079 de 2016

Datos registrales: T 26176 , F 214, S 8, H M 471795, I/A 22

20

Sep 2016

Nombramientos

Con fecha 20/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Sanchez Lopez Silvia Maria

PDF Anuncio nº 390078 de 2016

Datos registrales: T 26176 , F 213, S 8, H M 471795, I/A 21

16

Feb 2016

Nombramientos

Con fecha 16/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Representan Almazan Gomez Ignacio

PDF Anuncio nº 83133 de 2016

Datos registrales: T 26176 , F 212, S 8, H M 471795, I/A 20

05

Oct 2015

Revocaciones

Con fecha 05/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Jarvis Anna Marie

PDF Anuncio nº 411599 de 2015

Datos registrales: T 26176 , F 212, S 8, H M 471795, I/A 19

20

Ago 2015

Nombramientos

Con fecha 20/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Sol. Villanueva Cristobal Raul
Apo.Sol. Sanchez Carnicero Jose-Luis
Apo.Sol. Escudero Mendez Juan Francisco
Apo.Sol. Barrio Fuente Fernando

PDF Anuncio nº 357511 de 2015

Datos registrales: T 26176 , F 211, S 8, H M 471795, I/A 18

17

Jul 2015

Nombramientos

Con fecha 17/07/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Ruiz Sanchez David

PDF Anuncio nº 314528 de 2015

Datos registrales: T 26176 , F 211, S 8, H M 471795, I/A 17

21

Ago 2014

Revocaciones

Con fecha 21/08/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apo.Manc. Lauzan Gonzalez Fernando
Apo.Manc. Basagoiti Olano Eduardo

PDF Anuncio nº 348499 de 2014

Datos registrales: T 26176 , F 211, S 8, H M 471795, I/A 16

04

Jun 2014

Nombramientos

Con fecha 04/06/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Jarvis Anna Marie

PDF Anuncio nº 245461 de 2014

Datos registrales: T 26176 , F 210, S 8, H M 471795, I/A 15

25

Mar 2014

Nombramientos

Con fecha 25/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:


Cargo Persona física/jurídica
Apoderado Almazan Gomez Ignacio

PDF Anuncio nº 145224 de 2014

Datos registrales: T 26176 , F 210, S 8, H M 471795, I/A 14

person Boletines Oficiales
CVE Provincia Fecha
PDF BORME-A-2021-16-28 Madrid 26/01/2021
PDF BORME-A-2020-126-28 Madrid 02/07/2020
PDF BORME-A-2019-187-28 Madrid 30/09/2019
PDF BORME-A-2018-227-28 Madrid 27/11/2018
PDF BORME-A-2018-113-28 Madrid 14/06/2018
PDF BORME-A-2018-32-28 Madrid 14/02/2018
PDF BORME-A-2017-177-28 Madrid 15/09/2017
PDF BORME-A-2017-90-28 Madrid 16/05/2017
PDF BORME-A-2016-223-28 Madrid 23/11/2016
PDF BORME-A-2016-185-28 Madrid 27/09/2016
PDF BORME-A-2016-37-28 Madrid 24/02/2016
PDF BORME-A-2015-196-28 Madrid 14/10/2015
PDF BORME-A-2015-166-28 Madrid 01/09/2015
PDF BORME-A-2015-142-28 Madrid 29/07/2015
PDF BORME-A-2014-163-28 Madrid 28/08/2014
PDF BORME-A-2014-109-28 Madrid 11/06/2014
PDF BORME-A-2014-63-28 Madrid 01/04/2014
PDF BORME-A-2014-31-28 Madrid 14/02/2014
PDF BORME-A-2013-86-28 Madrid 09/05/2013
PDF BORME-A-2013-43-28 Madrid 04/03/2013
Ver más

Suscríbete a nuestro boletín

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades


Caret