Última actualización: 13 de Noviembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | A60672623 |
Denominación anterior | Rotor Print SA |
Provincia | Barcelona |
Objeto social | Fabricacion y comercializacion de embalajes flexibles para la industria farmaceutica y de alimentacion. |
Capital social | 2.041.539,28 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT. | J M Gay Y Sanfeliu Auditores SL | 13/11/2023 | Actualidad |
CONSEJERO | Neti Inversiones 2017 SL | 13/01/2023 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Negra Batlle Alberto | 13/01/2023 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Leiva Garcia Antonio | 13/01/2023 | Actualidad |
SECRETARIO | Elegetres Maresme SL | 13/01/2023 | Actualidad |
CONSEJERO | Elegetres Maresme SL | 13/01/2023 | Actualidad |
PRESIDENTE | Costa Schilt Jaume | 13/01/2023 | Actualidad |
CONSEJERO | Costa Schilt Jaume | 13/01/2023 | Actualidad |
CONS.DEL.SOL | Costa Schilt Jaume | 13/01/2023 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Sala Molas Josep | 14/04/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Negra Batlle Alberto | 22/03/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Leiva Garcia Antonio | 22/03/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Costa Carbonell Albert | 22/03/2021 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | J M Gay Y Sanfeliu Auditores SL | 22/12/2020 | Actualidad |
PRESIDENTE | Costa Schilt Jaume | 05/03/2019 | Actualidad |
CONSEJERO | Costa Schilt Jaume | 05/03/2019 | Actualidad |
CONS. DELEG. | Costa Schilt Jaume | 05/03/2019 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | J M Gay Y Sanfeliu Auditores SL | 09/01/2018 | Actualidad |
SECRETARIO | Elegetres Maresme SL | 19/01/2017 | Actualidad |
CONSEJERO | Elegetres Maresme SL | 19/01/2017 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERADO | Pla Anglada Ramon | Desconocido | 24/07/2020 |
APODERADO | Costa Bonet Jose Maria | Desconocido | 24/07/2020 |
PRESIDENTE | Saintlouis-Alsace SL | 19/01/2017 | 05/03/2019 |
CONSEJERO | Saintlouis-Alsace SL | 19/01/2017 | 05/03/2019 |
CONS. DELEG. | Saintlouis-Alsace SL | 19/01/2017 | 05/03/2019 |
REPR.143 RRM | Costa Schilt Jaume | 19/01/2017 | 05/03/2019 |
CONSEJERO | Telese Compte Maria Josefa | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
CONSEJERO | Tatu 2002 SL | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
SECR.NO CONS | Leiva Garcia Antonio | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
CONSEJERO | Inverwunder SL | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
REPR.143 RRM | Guma Hernandez Javier | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
REPR.143 RRM | Ferrer Molgo Eladi | 07/08/2014 | 19/01/2017 |
CONSEJERO | Ferrer Corporate SL | 07/08/2014 | 19/01/2017 |
PRESIDENTE | Costa Schilt Jaume | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
CONSEJERO | Costa Schilt Jaume | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
CONS. DELEG. | Costa Schilt Jaume | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
REPR.143 RRM | Cosin Borras Carlos | 18/03/2013 | 19/01/2017 |
PRESIDENTE | Costa Schilt Jaume | 21/05/2012 | 18/03/2013 |
CONSEJERO | Costa Schilt Jaume | 21/05/2012 | 18/03/2013 |
CONSEJERO | Carroggio Guerin Pablo | 21/05/2012 | 18/03/2013 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Rotor Print SL.
13
Nov 2023
Con fecha 13/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | J M Gay Y Sanfeliu Auditores SL |
Datos registrales: T 47678 , F 72, S 8, H B 120635, I/A 31
24
Jul 2023
Con fecha 24/07/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 47678 , F 72, S 8, H B 120635, I/A 30
13
Ene 2023
Con fecha 13/01/2023, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 7.- ORGANO DE ADMINISTRACION.
Datos registrales: T 47678 , F 71, S 8, H B 120635, I/A 29
13
Ene 2023
Con fecha 13/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Neti Inversiones 2017 SL |
REPR.143 RRM | Negra Batlle Alberto |
REPR.143 RRM | Leiva Garcia Antonio |
CONSEJERO | Elegetres Maresme SL |
CONSEJERO | Costa Schilt Jaume |
Datos registrales: T 47678 , F 71, S 8, H B 120635, I/A 29
14
Abr 2021
Con fecha 14/04/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Sala Molas Josep |
Datos registrales: T 47678 , F 71, S 8, H B 120635, I/A 28
22
Mar 2021
Con fecha 22/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Negra Batlle Alberto |
APODERAD.SOL | Leiva Garcia Antonio |
APODERAD.SOL | Costa Carbonell Albert |
Datos registrales: T 43543 , F 150, S 8, H B 120635, I/A 27
22
Dic 2020
Con fecha 22/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | J M Gay Y Sanfeliu Auditores SL |
Datos registrales: T 43543 , F 150, S 8, H B 120635, I/A 26
24
Jul 2020
Con fecha 24/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Pla Anglada Ramon |
APODERADO | Costa Bonet Jose Maria |
Datos registrales: T 43543 , F 150, S 8, H B 120635, I/A 25
05
Mar 2019
Con fecha 05/03/2019, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. PLAZO DE DURACION Y SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 43543 , F 150, S 8, H B 120635, I/A 24
05
Mar 2019
Con fecha 05/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Costa Schilt Jaume |
Datos registrales: T 43543 , F 150, S 8, H B 120635, I/A 24
05
Mar 2019
Con fecha 05/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Saintlouis-Alsace SL |
REPR.143 RRM | Costa Schilt Jaume |
Datos registrales: T 43543 , F 150, S 8, H B 120635, I/A 24
09
Ene 2018
Con fecha 09/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | J M Gay Y Sanfeliu Auditores SL |
Datos registrales: T 43543 , F 149, S 8, H B 120635, I/A 23
13
Mar 2017
Con fecha 13/03/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6,7 Y 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. TRANSMISION DE PARTIPACIONES. ORGANO DE ADMINISTRACION. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA.
Datos registrales: T 43543 , F 148, S 8, H B 120635, I/A 22
19
Ene 2017
Con fecha 19/01/2017, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 7.- ESTRUCTURA,PLAZO DE DURACION Y SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 43543 , F 147, S 8, H B 120635, I/A 21
19
Ene 2017
Con fecha 19/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Saintlouis-Alsace SL |
CONSEJERO | Neti Inversiones 2017 SL |
REPR.143 RRM | Negra Batlle Alberto |
REPR.143 RRM | Leiva Garcia Antonio |
SECRETARIO | Elegetres Maresme SL |
REPR.143 RRM | Costa Schilt Jaume |
Datos registrales: T 43543 , F 147, S 8, H B 120635, I/A 21
19
Ene 2017
Con fecha 19/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Telese Compte Maria Josefa |
CONSEJERO | Tatu 2002 SL |
SECR.NO CONS | Leiva Garcia Antonio |
CONSEJERO | Inverwunder SL |
REPR.143 RRM | Guma Hernandez Javier |
REPR.143 RRM | Ferrer Molgo Eladi |
CONSEJERO | Ferrer Corporate SL |
CONS. DELEG. | Costa Schilt Jaume |
REPR.143 RRM | Cosin Borras Carlos |
Datos registrales: T 43543 , F 147, S 8, H B 120635, I/A 21
07
Ago 2014
Con fecha 07/08/2014, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART.7.- SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 43543 , F 147, S 8, H B 120635, I/A 20
07
Ago 2014
Con fecha 07/08/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Ferrer Molgo Eladi |
CONSEJERO | Ferrer Corporate SL |
Datos registrales: T 43543 , F 147, S 8, H B 120635, I/A 20
18
Mar 2013
Con fecha 18/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Telese Compte Maria Josefa |
CONSEJERO | Tatu 2002 SL |
SECR.NO CONS | Leiva Garcia Antonio |
CONSEJERO | Inverwunder SL |
REPR.143 RRM | Guma Hernandez Javier |
PRESIDENTE | Costa Schilt Jaume |
REPR.143 RRM | Cosin Borras Carlos |
Datos registrales: T 42168 , F 129, S 8, H B 120635, I/A 18
18
Mar 2013
Con fecha 18/03/2013, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 600.045,12 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 41.63% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 2.041.539,28€.
Datos registrales: T 43543 , F 146, S 8, H B 120635, I/A 19
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2023-221-08 | Barcelona | 21/11/2023 |
BORME-A-2023-145-08 | Barcelona | 01/08/2023 |
BORME-A-2023-15-08 | Barcelona | 23/01/2023 |
BORME-A-2021-75-08 | Barcelona | 22/04/2021 |
BORME-A-2021-60-08 | Barcelona | 30/03/2021 |
BORME-A-2020-250-08 | Barcelona | 31/12/2020 |
BORME-A-2020-148-08 | Barcelona | 03/08/2020 |
BORME-A-2019-50-08 | Barcelona | 13/03/2019 |
BORME-A-2018-13-08 | Barcelona | 18/01/2018 |
BORME-A-2017-56-08 | Barcelona | 22/03/2017 |
BORME-A-2017-19-08 | Barcelona | 27/01/2017 |
BORME-A-2014-155-08 | Barcelona | 18/08/2014 |
BORME-A-2013-58-08 | Barcelona | 26/03/2013 |
BORME-A-2012-217-08 | Barcelona | 13/11/2012 |
BORME-A-2012-118-08 | Barcelona | 22/06/2012 |
BORME-A-2012-101-08 | Barcelona | 30/05/2012 |
BORME-A-2010-209-08 | Barcelona | 29/10/2010 |
BORME-A-2010-189-08 | Barcelona | 30/09/2010 |
BORME-A-2010-133-08 | Barcelona | 14/07/2010 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades