Última actualización: 27 de Octubre de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 5 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad de Inversión de Capital Variable |
NIF | A62998760 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Paseo De La Castellana 29 (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Liquidador | Trueba Alonso Alberto | 27/10/2022 | 27/10/2022 |
Consejero | Trueba Alonso Alberto | 18/05/2021 | 27/10/2022 |
Ent.Reg.Cont | Servicio De Compensacion Y Liquidacion De Valores | Desconocido | 27/10/2022 |
Auditor | Quorum Auditores SLP | 09/08/2010 | 27/10/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 22/12/2020 | 27/10/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 23/09/2016 | 27/10/2022 |
Secretario | Llamas Gonzalez Maria Dolores | 22/12/2020 | 27/10/2022 |
Consejero | Llamas Gonzalez Maria Dolores | 22/12/2020 | 27/10/2022 |
Consejero | Herrero Mendoza Ignacio | 26/08/2011 | 27/10/2022 |
VsecrNoConsj | Fernandez Miranda Vidal Alfonso | 11/02/2016 | 27/10/2022 |
Secretario | Diez Rodriguez Santiago | 18/05/2021 | 27/10/2022 |
Consejero | Diez Rodriguez Santiago | 18/05/2021 | 27/10/2022 |
Presidente | Da Silva Roberto Carlos | 22/12/2020 | 27/10/2022 |
Presidente | Da Silva Roberto Carlos | 24/07/2013 | 27/10/2022 |
Consejero | Da Silva Roberto Carlos | 24/07/2013 | 27/10/2022 |
Consejero | Da Silva Roberto Carlos | 22/12/2020 | 27/10/2022 |
EntidDeposit | Bankinter SA | 11/02/2016 | 27/10/2022 |
Ent. Gestora | Bankinter Gestion De Activos Sa Sociedad Gestora D | 11/02/2016 | 27/10/2022 |
Apoderado | Bankinter Gestion De Activos Sa Sociedad Gestora D | 11/02/2016 | 27/10/2022 |
Secretario | Llamas Gonzalez Maria Dolores | 24/07/2013 | 18/05/2021 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Rodasil Inversiones 2002 SICAV.
27
Oct 2022
Con fecha 27/10/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 25
27
Oct 2022
Con fecha 27/10/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 25
27
Oct 2022
Con fecha 27/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Trueba Alonso Alberto |
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 25
27
Oct 2022
Con fecha 27/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 25
27
Oct 2022
Con fecha 27/10/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Trueba Alonso Alberto |
Ent.Reg.Cont | Servicio De Compensacion Y Liquidacion De Valores |
VsecrNoConsj | Fernandez Miranda Vidal Alfonso |
Secretario | Diez Rodriguez Santiago |
Presidente | Da Silva Roberto Carlos |
EntidDeposit | Bankinter SA |
Ent. Gestora | Bankinter Gestion De Activos Sa Sociedad Gestora D |
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 25
18
May 2021
Con fecha 18/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Trueba Alonso Alberto |
Secretario | Diez Rodriguez Santiago |
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 24
18
May 2021
Con fecha 18/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Llamas Gonzalez Maria Dolores |
Consejero | Gonzalez Villajos Angel Jesus |
Datos registrales: T 22444 , F 207, S 8, H M 400992, I/A 24
22
Dic 2020
Con fecha 22/12/2020, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
SE MODIFICA EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. .
Datos registrales: T 22444 , F 206, S 8, H M 400992, I/A 23
22
Dic 2020
Con fecha 22/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Consejero | Llamas Gonzalez Maria Dolores |
Consejero | Da Silva Roberto Carlos |
Datos registrales: T 22444 , F 206, S 8, H M 400992, I/A 23
23
Sep 2016
Con fecha 23/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 22444 , F 206, S 8, H M 400992, I/A 22
23
Sep 2016
Con fecha 23/09/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 22444 , F 206, S 8, H M 400992, I/A 22
05
Abr 2016
Con fecha 05/04/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
SUPRESION DEL ARTICULO 3 BIS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..
Datos registrales: T 22444 , F 205, S 8, H M 400992, I/A 21
11
Feb 2016
Con fecha 11/02/2016, la sociedad cambia su domicilio social a PASEO DE LA CASTELLANA 29 (MADRID).
Datos registrales: T 22444 , F 203, S 8, H M 400992, I/A 20
11
Feb 2016
Con fecha 11/02/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 7 Y 13 DE LOS ESTATUTOS, RELATIVOS A POLITICA DE INVERSIONES Y REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL.
Datos registrales: T 22444 , F 203, S 8, H M 400992, I/A 20
11
Feb 2016
Con fecha 11/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Fernandez Miranda Vidal Alfonso |
EntidDeposit | Bankinter SA |
Apoderado | Bankinter Gestion De Activos Sa Sociedad Gestora D |
Datos registrales: T 22444 , F 203, S 8, H M 400992, I/A 20
11
Feb 2016
Con fecha 11/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Banco Madrid Gestion De Activos Sgiic SA |
Datos registrales: T 22444 , F 203, S 8, H M 400992, I/A 20
11
Feb 2016
Con fecha 11/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Ent. Gestora | Renta 4 Gestora Sgiic SA |
VsecrNoConsj | Perez Diaz Rosa Maria |
EntidDeposit | Cecabank SA |
Datos registrales: T 22444 , F 203, S 8, H M 400992, I/A 20
12
Ago 2015
Con fecha 12/08/2015, la sociedad cambia su domicilio social a PASEO DE LA HABANA 74 (MADRID).
Datos registrales: T 22444 , F 202, S 8, H M 400992, I/A 19
12
Ago 2015
Con fecha 12/08/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificación el artículo 1& de los estatutos sociales..
Datos registrales: T 22444 , F 202, S 8, H M 400992, I/A 19
12
Ago 2015
Con fecha 12/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Ent. Gestora | Renta 4 Gestora Sgiic SA |
VsecrNoConsj | Perez Diaz Rosa Maria |
Consejero | Gonzalez Villajos Angel Jesus |
EntidDeposit | Cecabank SA |
Datos registrales: T 22444 , F 202, S 8, H M 400992, I/A 19
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2022-211-28 | Madrid | 04/11/2022 |
BORME-A-2021-97-28 | Madrid | 25/05/2021 |
BORME-A-2020-249-28 | Madrid | 30/12/2020 |
BORME-A-2016-188-28 | Madrid | 30/09/2016 |
BORME-A-2016-71-28 | Madrid | 14/04/2016 |
BORME-A-2016-34-28 | Madrid | 19/02/2016 |
BORME-A-2015-157-28 | Madrid | 19/08/2015 |
BORME-A-2014-185-28 | Madrid | 29/09/2014 |
BORME-A-2013-154-28 | Madrid | 14/08/2013 |
BORME-A-2013-146-28 | Madrid | 02/08/2013 |
BORME-A-2013-145-28 | Madrid | 01/08/2013 |
BORME-A-2013-82-28 | Madrid | 03/05/2013 |
BORME-A-2012-112-28 | Madrid | 14/06/2012 |
BORME-A-2012-110-28 | Madrid | 12/06/2012 |
BORME-A-2012-108-28 | Madrid | 08/06/2012 |
BORME-A-2011-179-28 | Madrid | 20/09/2011 |
BORME-A-2010-163-28 | Madrid | 25/08/2010 |
BORME-A-2009-146-28 | Madrid | 04/08/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades