Última actualización: 13 de Noviembre de 2013
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 10 años, 5 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B63038178 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Av Diagonal Num.640 Esc.3 P.3 Pta.F (Barcelona). |
Capital social | 4.275.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJERO | Saticem Immobiliaria SL | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
APODERADO | Rodriguez Rios Catalina | 02/02/2011 | 13/11/2013 |
APODERADO | Riera Canchal Joaquin | 02/02/2011 | 13/11/2013 |
CONSEJERO | Promotora Catalunya Mediterranea SA | 12/01/2011 | 13/11/2013 |
APODERADO | Plana Farin Alejandro | 02/02/2011 | 13/11/2013 |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
APODERADO | Perez Rovira Jorge | 02/02/2011 | 13/11/2013 |
SECR.NO CONS | Lopez Gallego Antonio | 12/01/2011 | 13/11/2013 |
APODERADO | Larramona Mora Daniel | 02/02/2011 | 13/11/2013 |
CONSEJERO | Immofergui SL | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
APODERADO | Fenoy Palomas Ramon | 02/02/2011 | 13/11/2013 |
REPR.143 RRM | De Paladella Vidaller Ignacio | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
REPR.143 RRM | De Paladella Vidaller Ignacio | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
APODERADO | De Paladella Vidaller Ignacio | 02/02/2011 | 13/11/2013 |
CONSEJERO | Catalunyacaixa Immobiliaria SA | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
PRESIDENTE | Castell Fergui SL | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
CONSEJERO | Castell Fergui SL | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger | 21/05/2013 | 13/11/2013 |
REPR.143 RRM | Ignacio De Paladella Vidaller | 18/12/2009 | 21/05/2013 |
REPR.143 RRM | De Paladella Vidaller Ignacio | 19/11/2009 | 21/05/2013 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Rimau Promocentre SL.
13
Nov 2013
Con fecha 13/11/2013 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 41214 , F 110, S 8, H B 257260, I/A 23
13
Nov 2013
JUZGADO MERCANTIL 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 534/2013, AUTO FIRME DE FECHA 26/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 41214 , F 110, S 8, H B 257260, I/A 23
21
May 2013
Con fecha 21/05/2013, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTS.15,16,17,19:ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.REGULACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. ART.22:DISOLUCION DELA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 41214 , F 108, S 8, H B 257260, I/A 22
21
May 2013
Con fecha 21/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Saticem Immobiliaria SL |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
CONSEJERO | Immofergui SL |
REPR.143 RRM | De Paladella Vidaller Ignacio |
CONSEJERO | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
CONSEJERO | Castell Fergui SL |
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger |
Datos registrales: T 41214 , F 108, S 8, H B 257260, I/A 22
21
May 2013
Con fecha 21/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Saticem Immobiliaria SL |
V-SEC NO CON | Rovira Espinel Gemma |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
CONSEJERO | Immofergui SL |
REPR.143 RRM | Ignacio De Paladella Vidaller |
REPR.143 RRM | De Paladella Vidaller Ignacio |
CONSEJERO | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
CONSEJERO | Castell Fergui SL |
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger |
Datos registrales: T 41214 , F 108, S 8, H B 257260, I/A 22
28
Mar 2013
Con fecha 28/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Cartagena Vime Roger |
Datos registrales: T 41214 , F 108, S 8, H B 257260, I/A 21
28
Mar 2013
Con fecha 28/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Plana Farin Alejandro |
Datos registrales: T 41214 , F 108, S 8, H B 257260, I/A 21
22
Mar 2011
Con fecha 22/03/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Casas Baques Placid |
Datos registrales: T 41214 , F 108, S 8, H B 257260, I/A 20
02
Feb 2011
Con fecha 02/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Rodriguez Rios Catalina |
APODERADO | Riera Canchal Joaquin |
APODERADO | Plana Farin Alejandro |
APODERADO | Perez Rovira Jorge |
APODERADO | Larramona Mora Daniel |
APODERADO | Fenoy Palomas Ramon |
APODERADO | De Paladella Vidaller Ignacio |
Datos registrales: T 41214 , F 106, S 8, H B 257260, I/A 19
02
Feb 2011
Con fecha 02/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Plana Farin Alejandro |
APODERADO | Fernandez Joval Francesc |
APODERADO | De Paladella Vidaller Ignacio |
APODERADO | Casas Baques Placid |
Datos registrales: T 41214 , F 106, S 8, H B 257260, I/A 19
25
Ene 2011
Con fecha 25/01/2011, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 100.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 2.40% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 4.275.000,0€.
Datos registrales: T 41214 , F 105, S 8, H B 257260, I/A 18
12
Ene 2011
Con fecha 12/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Saticem Immobiliaria SL |
CONSEJERO | Promotora Catalunya Mediterranea SA |
REPR.143 RRM | Plana Farin Alejandro |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
SECR.NO CONS | Lopez Gallego Antonio |
Datos registrales: T 41214 , F 104, S 8, H B 257260, I/A 17
12
Ene 2011
Con fecha 12/01/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Viladomat Carreras Fernando |
SECR.NO CONS | Ribera Sellares Pere |
CONSEJERO | Perez Rovira Jorge |
Datos registrales: T 41214 , F 104, S 8, H B 257260, I/A 17
14
Jun 2010
Con fecha 14/06/2010, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 200.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 5.03% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 4.175.000,0€.
Datos registrales: T 41214 , F 102, S 8, H B 257260, I/A 16
14
Jun 2010
Con fecha 14/06/2010, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 850.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 27.20% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 3.975.000,0€.
Datos registrales: T 41214 , F 102, S 8, H B 257260, I/A 16
15
Abr 2010
Con fecha 15/04/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Plana Farin Alejandro |
APODERADO | De Paladella Vidaller Ignacio |
Datos registrales: T 41214 , F 102, S 8, H B 257260, I/A 15
15
Abr 2010
Con fecha 15/04/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Plana Farin Alejandro |
APODERADO | Llorens Vidal Ricard |
Datos registrales: T 41214 , F 102, S 8, H B 257260, I/A 15
18
Dic 2009
Con fecha 18/12/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Ignacio De Paladella Vidaller |
Datos registrales: T 41214 , F 101, S 8, H B 257260, I/A 14
18
Dic 2009
Con fecha 18/12/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Ricard Llorens Vidal |
Datos registrales: T 41214 , F 101, S 8, H B 257260, I/A 14
19
Nov 2009
Con fecha 19/11/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | De Paladella Vidaller Ignacio |
Datos registrales: T 41214 , F 101, S 8, H B 257260, I/A 13
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2013-222-08 | Barcelona | 20/11/2013 |
BORME-A-2013-98-08 | Barcelona | 28/05/2013 |
BORME-A-2013-65-08 | Barcelona | 08/04/2013 |
BORME-A-2011-63-08 | Barcelona | 31/03/2011 |
BORME-A-2011-30-08 | Barcelona | 14/02/2011 |
BORME-A-2011-23-08 | Barcelona | 03/02/2011 |
BORME-A-2011-15-08 | Barcelona | 24/01/2011 |
BORME-A-2010-120-08 | Barcelona | 25/06/2010 |
BORME-A-2010-79-08 | Barcelona | 28/04/2010 |
BORME-A-2009-249-08 | Barcelona | 31/12/2009 |
BORME-A-2009-229-08 | Barcelona | 01/12/2009 |
BORME-A-2009-101-08 | Barcelona | 01/06/2009 |
BORME-A-2009-96-08 | Barcelona | 25/05/2009 |
BORME-A-2009-88-08 | Barcelona | 12/05/2009 |
BORME-A-2009-84-08 | Barcelona | 06/05/2009 |
BORME-A-2009-46-08 | Barcelona | 09/03/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades