Última actualización: 16 de Octubre de 2013
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 10 años, 6 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A60980646 |
Provincia | Madrid |
Capital social | 4.691.227,0 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Vivas Carmen Josep | 14/03/2013 | 16/10/2013 |
Apo.Man.Soli | Trias Arraut Ana | 14/03/2013 | 16/10/2013 |
Consejero | Trabal Ogazon Pilar | 22/06/2009 | 16/10/2013 |
Apo.Sol. | Sule Salvado Marta | 15/03/2013 | 16/10/2013 |
Apoderado | Sanz De Oliveda Alvaro | 06/03/2012 | 16/10/2013 |
Apoderado | Sanz De Oliveda Alvaro | 12/01/2012 | 16/10/2013 |
Apoderado | Romero Miguel Gemma | 06/04/2010 | 16/10/2013 |
Apoderado | Raubert Vives Jaime | 12/01/2012 | 16/10/2013 |
Apo.Manc. | Gonzalez Ayesta Pablo | 14/03/2013 | 16/10/2013 |
Apo.Man.Soli | Gallardo Huerta Luis Manuel | 14/03/2013 | 16/10/2013 |
Apo.Manc. | Gallardo Cosialls Carmen | 14/03/2013 | 16/10/2013 |
Auditor | Ernst & Young SL | 07/07/2011 | 16/10/2013 |
Auditor | Ernst & Young SL | 03/09/2012 | 16/10/2013 |
Auditor | Ernst & Young SL | 22/06/2009 | 16/10/2013 |
Apoderado | Castillo Turnes Guillermo | 12/01/2012 | 16/10/2013 |
Apoderado | Bach Kutschruetter Javier | 15/03/2013 | 16/10/2013 |
Consejero | Alfonso Botello Eulalia | 06/07/2010 | 16/10/2013 |
Presidente | Albiol Ramis Juan | 06/07/2010 | 16/10/2013 |
Presidente | Albiol Ramis Juan | 22/06/2009 | 16/10/2013 |
Consejero | Albiol Ramis Juan | 06/07/2010 | 16/10/2013 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Perfumeria Gal SA.
16
Oct 2013
Con fecha 16/10/2013 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 24654 , F 91, S 8, H M 297442, I/A 70
16
Oct 2013
Con fecha 16/10/2013 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 24654 , F 91, S 8, H M 297442, I/A 70
16
Oct 2013
CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DENOMINADA "ANTONIO PUIG SA", INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA.
Datos registrales: T 24654 , F 91, S 8, H M 297442, I/A 70
06
Jul 2013
NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL, POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO ENEL ARTICULO 231 DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL.
Datos registrales: T 24654 , F 91, S 8, H M 297442, I/A 69 M
15
Mar 2013
Con fecha 15/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Sule Salvado Marta |
Apo.Sol. | Pallares Casado Ana |
Apo.Sol. | Argiles Malonda Eva |
Datos registrales: T 24654 , F 89, S 8, H M 297442, I/A 69
15
Mar 2013
Con fecha 15/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Bach Kutschruetter Javier |
Datos registrales: T 24654 , F 88, S 8, H M 297442, I/A 68
15
Mar 2013
Con fecha 15/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Farre Torras Maria Emilia |
Datos registrales: T 24654 , F 88, S 8, H M 297442, I/A 67
14
Mar 2013
Con fecha 14/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Vivas Carmen Josep |
Datos registrales: T 24654 , F 87, S 8, H M 297442, I/A 66
14
Mar 2013
Con fecha 14/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Puig La Calle Garcia Munte Olga |
Apo.Manc. | Gonzalez Ayesta Pablo |
Apo.Manc. | Gallardo Cosialls Carmen |
Datos registrales: T 24654 , F 86, S 8, H M 297442, I/A 65
14
Mar 2013
Con fecha 14/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Trias Arraut Ana |
Apo.Manc. | Gonzalez Ayesta Pablo |
Apo.Manc. | Gallardo Cosialls Carmen |
Datos registrales: T 24654 , F 86, S 8, H M 297442, I/A 64
14
Mar 2013
Con fecha 14/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Gonzalez Ayesta Pablo |
Apo.Man.Soli | Gallardo Huerta Luis Manuel |
Apo.Man.Soli | Gallardo Cosialls Carmen |
Datos registrales: T 24654 , F 83, S 8, H M 297442, I/A 63
13
Mar 2013
Con fecha 13/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sule Salvado Marta |
Apoderado | Pallares Casado Ana |
Apoderado | Gonzalez Ayesta Pablo |
Apoderado | Gallardo Huerta Luis Manuel |
Apoderado | Gallardo Cosialls Carmen |
Datos registrales: T 24654 , F 83, S 8, H M 297442, I/A 62
13
Mar 2013
Con fecha 13/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Garcia Acebron Miguel |
Datos registrales: T 24654 , F 82, S 8, H M 297442, I/A 61
03
Sep 2012
Con fecha 03/09/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 24654 , F 82, S 8, H M 297442, I/A 60
06
Mar 2012
Con fecha 06/03/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanz De Oliveda Alvaro |
Datos registrales: T 24654 , F 82, S 8, H M 297442, I/A 59
12
Ene 2012
Con fecha 12/01/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanz De Oliveda Alvaro |
Apoderado | Raubert Vives Jaime |
Apoderado | Garcia Acebron Miguel |
Apoderado | Castillo Turnes Guillermo |
Datos registrales: T 24654 , F 81, S 8, H M 297442, I/A 58
12
Ene 2012
Con fecha 12/01/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sanz De Oliveda Alvaro |
Apoderado | Raubert Vives Jaime |
Apoderado | Garcia Acebron Miguel |
Apoderado | Castillo Turne Guillermo |
Datos registrales: T 24654 , F 80, S 8, H M 297442, I/A 57
06
Sep 2011
Reducción de capital
Datos registrales: T 24654 , F 80, S 8, H M 297442, I/A 56
07
Jul 2011
Con fecha 07/07/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 24654 , F 79, S 8, H M 297442, I/A 55
07
Jul 2010
Con fecha 07/07/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 24654 , F 79, S 8, H M 297442, I/A 54
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2013-204-28 | Madrid | 24/10/2013 |
BORME-A-2013-132-28 | Madrid | 15/07/2013 |
BORME-A-2013-58-28 | Madrid | 26/03/2013 |
BORME-A-2013-57-28 | Madrid | 25/03/2013 |
BORME-A-2013-56-28 | Madrid | 22/03/2013 |
BORME-A-2012-176-28 | Madrid | 12/09/2012 |
BORME-A-2012-53-28 | Madrid | 15/03/2012 |
BORME-A-2012-17-28 | Madrid | 25/01/2012 |
BORME-A-2011-178-28 | Madrid | 19/09/2011 |
BORME-A-2011-137-28 | Madrid | 19/07/2011 |
BORME-A-2010-136-28 | Madrid | 19/07/2010 |
BORME-A-2010-135-28 | Madrid | 16/07/2010 |
BORME-A-2010-72-28 | Madrid | 19/04/2010 |
BORME-A-2009-123-28 | Madrid | 02/07/2009 |
BORME-A-2009-94-28 | Madrid | 21/05/2009 |
BORME-A-2009-42-28 | Madrid | 03/03/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades