Última actualización: 12 de Diciembre de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A84968437 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Paseo De La Castellana 28 (Madrid). |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Manc. | Szmyd Nina | 07/08/2018 | 12/12/2018 |
Apoderado | Stagg Kelvin John | 23/11/2016 | 12/12/2018 |
Apo.Manc. | Santacroce Marchena Daniele | 07/08/2018 | 12/12/2018 |
Apo.Sol. | Sanchez Martin Pablo Vicente | 13/11/2012 | 12/12/2018 |
Apo.Sol. | Rodriguez Martin Ana Maria | 11/06/2018 | 12/12/2018 |
Apoderado | Rehmstedt Henning | 23/11/2016 | 12/12/2018 |
Adm. Unico | Michael Page Holding España SL | 24/11/2017 | 12/12/2018 |
Apoderado | Martin Castaño Fatima | 23/11/2016 | 12/12/2018 |
Apo.Manc. | Jaszcz Aleksandra | 07/08/2018 | 12/12/2018 |
Apoderado | Ivanescu Diana Andreaa | 19/09/2017 | 12/12/2018 |
Apo.Manc. | Halvey Karyn | 07/08/2018 | 12/12/2018 |
Apo.Manc. | Gunaydin Ismael | 07/08/2018 | 12/12/2018 |
Apoderado | Gonzalez Alonso Jaime Asnai | 14/08/2015 | 12/12/2018 |
Apo.Sol. | Fernandez Alonso Iñigo | 03/09/2013 | 12/12/2018 |
Apo.Manc. | Farres Costafreda Magdalena | 07/08/2018 | 12/12/2018 |
Apo.Sol. | Escobar Robina Eduardo | 03/09/2013 | 12/12/2018 |
Auditor | Ernst & Young SL | 16/11/2016 | 12/12/2018 |
Apo.Manc. | Ehrhardt Verena | 07/08/2018 | 12/12/2018 |
Apoderado | Castellanos De La Puente Jose | 14/08/2015 | 12/12/2018 |
Apoderado | Badin Nicolas Patrick Serge Buisson | 15/06/2010 | 12/12/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Page Personnel Seleccion España SA.
12
Dic 2018
Con fecha 12/12/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 36667 , F 36, S 8, H M 433011, I/A 42
12
Dic 2018
Con fecha 12/12/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 36667 , F 36, S 8, H M 433011, I/A 42
12
Dic 2018
Con fecha 12/12/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Michael Page Holding España SL |
Representan | Badin Nicolas Patrick Serge Buisson |
Datos registrales: T 36667 , F 36, S 8, H M 433011, I/A 42
26
Sep 2018
Con fecha 26/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Chinu Michele |
Datos registrales: T 36667 , F 36, S 8, H M 433011, I/A 41
07
Ago 2018
Con fecha 07/08/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Tatham Jeremy Paul |
Apo.Manc. | Szmyd Nina |
Apo.Manc. | Stagg Kelvin John |
Apo.Manc. | Senturk Polat |
Apo.Manc. | Santacroce Marchena Daniele |
Apo.Manc. | Rial Estevez Hector Diego |
Apo.Manc. | Reyes Julio |
Apo.Manc. | Rehmstedt Henning |
Apo.Manc. | Kunesova Lucie |
Apo.Manc. | Jaszcz Aleksandra |
Apo.Manc. | Ivanescu Diana Andreaa |
Apo.Manc. | Halvey Karyn |
Apo.Manc. | Gunaydin Ismael |
Apo.Manc. | Farres Costafreda Magdalena |
Apo.Manc. | Ehrhardt Verena |
Apo.Manc. | De Beaucorps Geffroy Marie Humbert |
Apo.Manc. | Davide Roberto |
Apo.Manc. | Clark Matthew James |
Apo.Manc. | Bonnet Joanna Louise |
Datos registrales: T 36667 , F 34, S 8, H M 433011, I/A 40
11
Jun 2018
Con fecha 11/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Rodriguez Martin Ana Maria |
Datos registrales: T 36667 , F 34, S 8, H M 433011, I/A 39
11
Jun 2018
Con fecha 11/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Sibille Daniela |
Apo.Sol. | Pulido Arce Ignacio |
Apoderado | Badia Salanova Andrea |
Datos registrales: T 36667 , F 34, S 8, H M 433011, I/A 38
14
May 2018
Con fecha 14/05/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Zayas Calvo Jose Luis |
Datos registrales: T 36667 , F 33, S 8, H M 433011, I/A 37
11
Abr 2018
Con fecha 11/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Portillo De Antonio Miguel |
Apo.Sol. | Fernandez Alonso Alvaro |
Datos registrales: T 36667 , F 33, S 8, H M 433011, I/A 36
24
Nov 2017
Con fecha 24/11/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Michael Page Holding España SL |
Representan | Badin Nicolas Patrick Serge Buisson |
Datos registrales: T 24099 , F 216, S 8, H M 433011, I/A 35
14
Nov 2017
Con fecha 14/11/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tereschenko Julia |
Apoderado | Fort Ros Jessica |
Datos registrales: T 24099 , F 216, S 8, H M 433011, I/A 34
19
Sep 2017
Con fecha 19/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Ivanescu Diana Andreaa |
Datos registrales: T 24099 , F 216, S 8, H M 433011, I/A 33
19
Sep 2017
Con fecha 19/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | D'Incognito Rocco |
Datos registrales: T 24099 , F 216, S 8, H M 433011, I/A 33
23
Nov 2016
Con fecha 23/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Thomas Mark |
Apoderado | Tatham Jeremy Paul |
Apoderado | Stagg Kelvin John |
Apoderado | Sibille Daniela |
Apoderado | Sanchez Martin Pablo Vicente |
Apoderado | Rial Estevez Hector Diego |
Apoderado | Rehmstedt Henning |
Apoderado | Mulders Dieter Van |
Apoderado | Martin Castaño Fatima |
Apoderado | Kieffer Daphnis |
Apoderado | Hierro Joshua |
Apoderado | Farres Costafreda Magdalena |
Apoderado | De Beaucorps Geoffroy Marie Humbert |
Apoderado | D'Incognito Rocco |
Apoderado | Chinu Michele |
Apoderado | Badin Nicolas Patrick Serge Buisson |
Apoderado | Badia Salanova Andrea |
Datos registrales: T 24099 , F 214, S 8, H M 433011, I/A 32
23
Nov 2016
Con fecha 23/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Vega Frances Cristina |
Apo.Manc. | Thomas Mark |
Apo.Manc. | Tatham Jeremy Paul |
Apo.Manc. | Stagg Kelvin John |
Apo.Manc. | Sibille Daniela |
Apo.Manc. | Sanchez Martin Pablo Vicente |
Apo.Manc. | Lemaitre Olivier Francois Jacques |
Apo.Manc. | Hierro Joshua |
Apo.Manc. | De Beaucorps Geoffroy Marie Humbert |
Apo.Manc. | Chinu Michele |
Apo.Manc. | Badin Nicolas Patrick Serge Buisson |
Datos registrales: T 24099 , F 214, S 8, H M 433011, I/A 32
16
Nov 2016
Con fecha 16/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Ernst & Young SL |
Datos registrales: T 24099 , F 214, S 8, H M 433011, I/A 31
01
Jul 2016
Con fecha 01/07/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Martin Martinez Maria Gema |
Datos registrales: T 24099 , F 213, S 8, H M 433011, I/A 30
14
Ago 2015
Con fecha 14/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gonzalez Alonso Jaime Asnai |
Datos registrales: T 24099 , F 212, S 8, H M 433011, I/A 28
14
Ago 2015
Con fecha 14/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gilabert Cambra Domenec |
Datos registrales: T 24099 , F 211, S 8, H M 433011, I/A 27
14
Ago 2015
Con fecha 14/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gonzalez Alonso Jaime |
Apoderado | Gilabert Cambra Domenec |
Apoderado | Castellanos De La Puente Jose |
Datos registrales: T 24099 , F 210, S 8, H M 433011, I/A 26
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-242-28 | Madrid | 19/12/2018 | |
BORME-A-2018-192-28 | Madrid | 04/10/2018 | |
BORME-A-2018-157-28 | Madrid | 16/08/2018 | |
BORME-A-2018-116-28 | Madrid | 19/06/2018 | |
BORME-A-2018-97-28 | Madrid | 23/05/2018 | |
BORME-A-2018-76-28 | Madrid | 19/04/2018 | |
BORME-A-2017-230-28 | Madrid | 04/12/2017 | |
BORME-A-2017-221-28 | Madrid | 21/11/2017 | |
BORME-A-2017-185-28 | Madrid | 27/09/2017 | |
BORME-A-2016-231-28 | Madrid | 05/12/2016 | |
BORME-A-2016-223-28 | Madrid | 23/11/2016 | |
BORME-A-2016-130-28 | Madrid | 08/07/2016 | |
BORME-A-2015-160-28 | Madrid | 24/08/2015 | |
BORME-A-2015-98-28 | Madrid | 27/05/2015 | |
BORME-A-2015-24-28 | Madrid | 05/02/2015 | |
BORME-A-2013-234-28 | Madrid | 09/12/2013 | |
BORME-A-2013-174-28 | Madrid | 12/09/2013 | |
BORME-A-2013-91-28 | Madrid | 17/05/2013 | |
BORME-A-2013-71-28 | Madrid | 16/04/2013 | |
BORME-A-2012-247-28 | Madrid | 27/12/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades