Última actualización: 5 de Septiembre de 2017
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 6 años, 7 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B12575544 |
Provincia | Castellón |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Presidente | Participacion E Impulso SL | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Liquidador | Participacion E Impulso SL | 05/09/2017 | 05/09/2017 |
Consejero | Participacion E Impulso SL | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Vicepresid. | Keraben Grupo SA | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Consejero | Keraben Grupo SA | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Vicesecret. | Horkios Gestion SA | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Consejero | Horkios Gestion SA | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Cons.Del.Sol | Horkios Gestion SA | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Auditor | Euro Accountings SL | 30/01/2010 | 05/09/2017 |
Secretario | Ceracasa SA | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Consejero | Ceracasa SA | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Cons.Del.Sol | Ceracasa SA | 11/08/2015 | 05/09/2017 |
Auditor | Audicas SL | 14/01/2016 | 05/09/2017 |
Auditor | Audicas SL | 06/11/2014 | 05/09/2017 |
Auditor | Audicas SL | 23/01/2014 | 05/09/2017 |
Auditor | Audicas SL | 16/01/2013 | 05/09/2017 |
Consejero | Nomdedeu Lluesma Vicente Manuel | 12/09/2014 | 11/08/2015 |
Cons.Del.Sol | Nomdedeu Lluesma Vicente Manuel | 12/09/2014 | 11/08/2015 |
Secretario | Cabrera Ahis Carlos | 12/09/2014 | 11/08/2015 |
Vicepresid. | Benavent Adrian Rafael | 12/09/2014 | 11/08/2015 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Nuclear Ceramics SL.
05
Sep 2017
Con fecha 05/09/2017 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 1105, L 669, F 26, S 8, H CS 18742, I/A 16
05
Sep 2017
Con fecha 05/09/2017 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 1105, L 669, F 26, S 8, H CS 18742, I/A 16
05
Sep 2017
Con fecha 05/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Participacion E Impulso SL |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 26, S 8, H CS 18742, I/A 16
05
Sep 2017
Con fecha 05/09/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Participacion E Impulso SL |
Consejero | Keraben Grupo SA |
Vicesecret. | Horkios Gestion SA |
Cons.Del.Sol | Ceracasa SA |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 26, S 8, H CS 18742, I/A 16
14
Ene 2016
Con fecha 14/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Audicas SL |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 26, S 8, H CS 18742, I/A 14
11
Ago 2015
Con fecha 11/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Participacion E Impulso SL |
Consejero | Keraben Grupo SA |
Vicesecret. | Horkios Gestion SA |
Consejero | Ceracasa SA |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 13
11
Ago 2015
Con fecha 11/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Nomdedeu Lluesma Vicente Manuel |
Consejero | Hernandez Sanchis Luis |
Consejero | Cabrera Ahis Carlos |
Consejero | Benavent Adrian Rafael |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 13
06
Nov 2014
Con fecha 06/11/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Audicas SL |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 12
12
Sep 2014
Con fecha 12/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Sol | Nomdedeu Lluesma Vicente Manuel |
Presidente | Hernandez Sanchis Luis |
Cons.Del.Sol | Cabrera Ahis Carlos |
Vicepresid. | Benavent Adrian Rafael |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 11
12
Sep 2014
Con fecha 12/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicepresid. | Nomdedeu Lluesma Vicente Manuel |
Consejero | Hernandez Sanchis Luis |
Consejero | Cabrera Ahis Carlos |
Vicesecret. | Benavent Adrian Rafael |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 11
23
Ene 2014
Con fecha 23/01/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Audicas SL |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 10
16
Ene 2013
Con fecha 16/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Audicas SL |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 9
16
Ene 2013
Con fecha 16/01/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Auren Auditores Castellon SLP |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 9
28
Feb 2011
Con fecha 28/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Benavent Adrian Rafael |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 8
28
Feb 2011
Con fecha 28/02/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Benavent Estrems Rafael |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 25, S 8, H CS 18742, I/A 8
30
Ene 2010
Con fecha 30/01/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Euro Accountings SL |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 24, S 8, H CS 18742, I/A 7
14
Sep 2009
Con fecha 14/09/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Nomdedeu Lluesma Vicente Manuel |
Consejero | Hernandez Sanchis Luis |
Consejero | Cabrera Ahis Carlos |
Cons.Del.Sol | Benavent Estrems Rafael |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 24, S 8, H CS 18742, I/A 6
14
Sep 2009
Con fecha 14/09/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Nondedeu Lluesma Vicente |
Consejero | Hernandez Sanchis Luis |
Con.Delegado | Cabrera Ahis Carlos |
Consejero | Benavent Estrems Rafael |
Datos registrales: T 1105, L 669, F 24, S 8, H CS 18742, I/A 6
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2017-179-12 | Castellón | 19/09/2017 |
BORME-A-2016-15-12 | Castellón | 25/01/2016 |
BORME-A-2015-158-12 | Castellón | 20/08/2015 |
BORME-A-2014-220-12 | Castellón | 18/11/2014 |
BORME-A-2014-178-12 | Castellón | 18/09/2014 |
BORME-A-2014-20-12 | Castellón | 30/01/2014 |
BORME-A-2013-15-12 | Castellón | 23/01/2013 |
BORME-A-2011-48-12 | Castellón | 10/03/2011 |
BORME-A-2010-26-12 | Castellón | 09/02/2010 |
BORME-A-2009-182-12 | Castellón | 23/09/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades