Última actualización: 7 de Agosto de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 7 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B61725669 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Ps De Les Lletres Num.13 P.7 Pta.2 (Terrassa). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIQUIDADOR | Torredemer Galles Juan Ignacio | Desconocido | 07/08/2020 |
LIQUIDADOR | Torredemer Galles Juan Ignacio | 07/08/2020 | 07/08/2020 |
ADM.CONJUNTO | Torredemer Galles Juan Ignacio | 19/04/2018 | 07/08/2020 |
ADM.CONJUNTO | Torredemer Galles Jose | 19/04/2018 | 07/08/2020 |
APODERADO | Riera Canchal Joaquin | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
APODERADO | Plana Farin Alejandro | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
APODERADO | Perez Rovira Jorge | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
APODERADO | Parera Gusi Antonio | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
APODERADO | Larramona Mora Daniel | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
APODERADO | Fenoy Palomas Ramon | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
CONS. DELEG. | Corporinsa SL | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
CONS. DELEG. | Catalunyacaixa Immobiliaria SA | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
CONS. DELEG. | Catalonia Comercial SL | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
CONS. DELEG. | Activos Macorp SL | 29/06/2011 | 07/08/2020 |
PRESIDENTE | Torredemer Galles Juan Ignacio | 18/01/2018 | 19/04/2018 |
CONSEJERO | Torredemer Galles Juan Ignacio | 18/01/2018 | 19/04/2018 |
CONSEJERO | Torredemer Galles Jose | 18/01/2018 | 19/04/2018 |
CONSEJERO | Rey Baltar Oramas Cesario | 18/01/2018 | 19/04/2018 |
SECR.NO CONS | Andrea Perello Schumann | 18/01/2018 | 19/04/2018 |
CONSEJERO | Aguado Rodriguez Esteban | 18/01/2018 | 19/04/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Nova Terrassa 30 SL.
07
Ago 2020
Con fecha 07/08/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 38240 , F 88, S 8, H B 181360, I/A 17
07
Ago 2020
Con fecha 07/08/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Torredemer Galles Juan Ignacio |
Datos registrales: T 38240 , F 88, S 8, H B 181360, I/A 17
07
Ago 2020
Con fecha 07/08/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Torredemer Galles Juan Ignacio |
ADM.CONJUNTO | Torredemer Galles Jose |
Datos registrales: T 38240 , F 88, S 8, H B 181360, I/A 17
19
Abr 2018
Con fecha 19/04/2018, la sociedad cambia su domicilio social a PS DE LES LLETRES Num.13 P.7 PTA.2 (TERRASSA).
Datos registrales: T 38240 , F 87, S 8, H B 181360, I/A 16
19
Abr 2018
DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: NOVA EGARA 30 S.L.
Datos registrales: T 38240 , F 87, S 8, H B 181360, I/A 16
19
Abr 2018
Con fecha 19/04/2018, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 11,15,16,18,20 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.
Datos registrales: T 38240 , F 87, S 8, H B 181360, I/A 16
19
Abr 2018
Con fecha 19/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Torredemer Galles Juan Ignacio |
ADM.CONJUNTO | Torredemer Galles Jose |
Datos registrales: T 38240 , F 87, S 8, H B 181360, I/A 16
19
Abr 2018
Con fecha 19/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Torredemer Galles Juan Ignacio |
CONSEJERO | Torredemer Galles Jose |
CONSEJERO | Rey Baltar Oramas Cesario |
SECR.NO CONS | Andrea Perello Schumann |
CONSEJERO | Aguado Rodriguez Esteban |
Datos registrales: T 38240 , F 87, S 8, H B 181360, I/A 16
18
Ene 2018
Con fecha 18/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Torredemer Galles Juan Ignacio |
CONSEJERO | Torredemer Galles Jose |
CONSEJERO | Rey Baltar Oramas Cesario |
SECR.NO CONS | Andrea Perello Schumann |
CONSEJERO | Aguado Rodriguez Esteban |
Datos registrales: T 38240 , F 87, S 8, H B 181360, I/A 15
18
Ene 2018
Con fecha 18/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Torredemer Galles Jose |
REPR.143 RRM | Perich Parcerisas Josep |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
SECR.NO CONS | Lopez Gallego Antonio |
VICEPRESIDEN | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
CONSEJERO | Catalonia Comercial SL |
CONS.DEL.MAN | Activos Macorp SL |
Datos registrales: T 38240 , F 87, S 8, H B 181360, I/A 15
11
Oct 2016
Con fecha 11/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Torredemer Galles Juan Ignacio |
CONS.DEL.MAN | Corporinsa SL |
Datos registrales: T 38240 , F 87, S 8, H B 181360, I/A 14
29
Jun 2011
En el BORME no.132/2011 y con referencia 291682 SE CONSIGNO EL NOMBRAMIENTO DE CATALUNYACAIXA INMOBILIARIA SA,ACTIVOS MACORP SL,CORPORINSA SL Y CATALONIA COMERCIAL SL COMO CONSEJEROS DELEGADOS SOLIDARIOS Y MANCOMUNADOS,SIENDO EN REALIDAD SU ACTUACION UNICAMENTE MANCOMUNADA.
Datos registrales: T 38240 , F 83, S 8, H B 181360, I/A 13
29
Jun 2011
Con fecha 29/06/2011, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART.20.- MODIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 38240 , F 83, S 8, H B 181360, I/A 13
29
Jun 2011
Con fecha 29/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Torredemer Galles Juan Ignacio |
REPR.143 RRM | Torredemer Galles Jose |
APODERADO | Riera Canchal Joaquin |
APODERADO | Plana Farin Alejandro |
REPR.143 RRM | Perich Parcerisas Josep |
REPR.143 RRM | Perez Rovira Jorge |
APODERADO | Parera Gusi Antonio |
SECR.NO CONS | Lopez Gallego Antonio |
APODERADO | Larramona Mora Daniel |
APODERADO | Fenoy Palomas Ramon |
CONS.DEL.MAN | Corporinsa SL |
VICEPRESIDEN | Catalunyacaixa Immobiliaria SA |
CONS.DEL.MAN | Catalonia Comercial SL |
CONSEJERO | Activos Macorp SL |
Datos registrales: T 38240 , F 83, S 8, H B 181360, I/A 13
29
Jun 2011
Con fecha 29/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Vilar Ventura Albert |
APODERADO | Valls Porcel Joan |
CONSEJERO | Torredemer Galles Juan Ignacio |
SECR.NO CONS | Puig Carrasco Cristina |
APODERADO | Parera Gusi Antonio |
CONSEJERO | Nova Egara 30 SL |
CONS. DELEG. | Domingo Prats Antonio |
APODERADO | De La Torre Sanchez Alejandro |
CONS. DELEG. | Aznar Berruezo Eduardo |
Datos registrales: T 38240 , F 83, S 8, H B 181360, I/A 13
23
Dic 2010
Con fecha 23/12/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Torredemer Galles Juan Ignacio |
Datos registrales: T 38240 , F 83, S 8, H B 181360, I/A 12
23
Dic 2010
Con fecha 23/12/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Torredemer Riu Juan |
Datos registrales: T 38240 , F 83, S 8, H B 181360, I/A 12
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2020-157-08 | Barcelona | 14/08/2020 |
BORME-A-2018-81-08 | Barcelona | 26/04/2018 |
BORME-A-2018-19-08 | Barcelona | 26/01/2018 |
BORME-A-2016-201-08 | Barcelona | 20/10/2016 |
BORME-A-2012-68-08 | Barcelona | 10/04/2012 |
BORME-A-2011-132-08 | Barcelona | 12/07/2011 |
BORME-A-2011-3-08 | Barcelona | 05/01/2011 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades