Última actualización: 13 de Noviembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A08974222 |
Denominación anterior | Npi Sanitary Components SA |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Cl Cami Ral Num. 6, Pol. Ind. Congost (Montornes Del Valles). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERAD.SOL | Jordan Pastor Jose Carlos | 13/11/2023 | Actualidad |
CONSEJERO | Jordan Pastor Jose Carlos | 06/11/2023 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Bdo Auditores SLP | 05/01/2022 | Actualidad |
PRESIDENTE | Oliver Walter Meyer | 29/07/2020 | Actualidad |
CONS.DEL.SOL | Oliver Walter Meyer | 29/07/2020 | Actualidad |
SECRETARIO | Asensio Santiago Antonio Blas | 29/07/2020 | Actualidad |
CONSEJERO | Oliver Walter Meyer | 23/07/2019 | Actualidad |
CONSEJERO | Mateu Zanier Albert | 23/07/2019 | Actualidad |
CONSEJERO | Jaime Alberto Tapia | 23/07/2019 | Actualidad |
CONSEJERO | Christian Friedrich Wotzka | 23/07/2019 | Actualidad |
CONSEJERO | Asensio Santiago Antonio Blas | 23/07/2019 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Bdo Auditores SLP | 03/04/2019 | Actualidad |
CONSEJERO | Jaime Alberto Tapia | 14/11/2018 | Actualidad |
AUDT.CTS.CON | Bdo Auditores SLP | 18/08/2015 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Bdo Auditores SLP | 18/08/2015 | Actualidad |
PRESIDENTE | Oliver Walter Meyer | 20/06/2014 | Actualidad |
CONSEJERO | Oliver Walter Meyer | 20/06/2014 | Actualidad |
SECRETARIO | Asensio Santiago Antonio Blas | 20/06/2014 | Actualidad |
CONSEJERO | Asensio Santiago Antonio Blas | 20/06/2014 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Asensio Santiago Antonio Blas | 20/06/2014 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSEJERO | Christian Friedrich Wotzka | 20/06/2014 | 06/11/2023 |
CONSEJERO | Mateu Zanier Albert | 06/09/2013 | 27/03/2023 |
CONS.DEL.SOL | Mateu Zanier Albert | 29/07/2020 | 27/03/2023 |
CONS. DELEG. | Oliver Walter Meyer | 20/06/2014 | 23/07/2019 |
CONS. DELEG. | Mateu Zanier Albert | 06/09/2013 | 23/07/2019 |
CONSEJERO | Belinda Kay Wise | 20/06/2014 | 05/03/2018 |
PRESIDENTE | Zanier Poli Fosca | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
CONSEJERO | Zanier Poli Fosca | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
CONSEJERO | Veselin Nikolov Velev | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
CONSEJERO | Mateu Zanier Albert | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
CONS. DELEG. | Mateu Zanier Albert | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
CONSEJERO | Mateu Pujols Jose Maria | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
SECRETARIO | Asensio Santiago Antonio Blas | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
CONSEJERO | Asensio Santiago Antonio Blas | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
CONS. DELEG. | Asensio Santiago Antonio Blas | 28/04/2009 | 20/06/2014 |
APODERADO | Asensio Santiago Antonio Blas | Desconocido | 20/06/2014 |
CONSEJERO | Arbiol Bertran Manuel | 06/09/2013 | 20/06/2014 |
CONSEJERO | Jarque Araez Gonzalo | 28/04/2009 | 29/08/2012 |
SECRETARIO | Colas Ricart Miguel | Desconocido | 28/04/2009 |
CONSEJERO | Colas Piquer Miguel | Desconocido | 28/04/2009 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Neoperl Iberica SA.
13
Nov 2023
Con fecha 13/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Jordan Pastor Jose Carlos |
Datos registrales: T 40815 , F 119, S 8, H B 101987, I/A 55
06
Nov 2023
Con fecha 06/11/2023, la sociedad cambia su domicilio social a CL CAMI RAL NUM. 6, POL. IND. CONGOST (MONTORNES DEL VALLES).
Datos registrales: T 40815 , F 119, S 8, H B 101987, I/A 54
06
Nov 2023
Con fecha 06/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Jordan Pastor Jose Carlos |
Datos registrales: T 40815 , F 119, S 8, H B 101987, I/A 54
06
Nov 2023
Con fecha 06/11/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Christian Friedrich Wotzka |
Datos registrales: T 40815 , F 119, S 8, H B 101987, I/A 54
27
Mar 2023
Con fecha 27/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Mateu Zanier Albert |
Datos registrales: T 40815 , F 119, S 8, H B 101987, I/A 53
27
Mar 2023
En el BORME no.65/2023 y con referencia 161898 se publico cesar al Don Albert Mateu Zanier como consejero y consejero delegado, quedando cesado a tales efectos.
Datos registrales: T 40815 , F 119, S 8, H B 101987, I/A 53
27
Mar 2023
CESAR CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO DE 2023 A DON ALBERT MATEU ZANIER EN SU CARGO DE CONSEJERO Y CONSEJERO DELEGADO.
Datos registrales: T 40815 , F 119, S 8, H B 101987, I/A 53
05
Ene 2022
Con fecha 05/01/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 40815 , F 119, S 8, H B 101987, I/A 52
29
Jul 2020
Con fecha 29/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS.DEL.SOL | Oliver Walter Meyer |
CONS.DEL.SOL | Mateu Zanier Albert |
SECRETARIO | Asensio Santiago Antonio Blas |
Datos registrales: T 40815 , F 118, S 8, H B 101987, I/A 51
23
Jul 2019
Con fecha 23/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Oliver Walter Meyer |
CONSEJERO | Mateu Zanier Albert |
CONSEJERO | Jaime Alberto Tapia |
CONSEJERO | Christian Friedrich Wotzka |
CONSEJERO | Asensio Santiago Antonio Blas |
Datos registrales: T 40815 , F 118, S 8, H B 101987, I/A 50
23
Jul 2019
Con fecha 23/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONS. DELEG. | Oliver Walter Meyer |
CONS. DELEG. | Mateu Zanier Albert |
Datos registrales: T 40815 , F 118, S 8, H B 101987, I/A 50
03
Abr 2019
Con fecha 03/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 40815 , F 118, S 8, H B 101987, I/A 49
14
Nov 2018
Con fecha 14/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Jaime Alberto Tapia |
Datos registrales: T 40815 , F 117, S 8, H B 101987, I/A 48
27
Jun 2018
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 225/2005, AUTO FIRME DE FECHA 01/06/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO.
Datos registrales: T 40815 , F 117, S 8, H B 101987, I/A 47
05
Mar 2018
Con fecha 05/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Belinda Kay Wise |
Datos registrales: T 40815 , F 117, S 8, H B 101987, I/A 46
22
Feb 2017
Con fecha 22/02/2017, la sociedad cambia su denominación social a NEOPERL IBERICA SA
Datos registrales: T 40815 , F 117, S 8, H B 101987, I/A 45
18
Ago 2015
Con fecha 18/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Bdo Auditores SLP |
Datos registrales: T 40815 , F 116, S 8, H B 101987, I/A 44
04
May 2015
Con fecha 04/05/2015, la sociedad cambia su denominación social a NPI SANITARY COMPONENTS SA
Datos registrales: T 40815 , F 116, S 8, H B 101987, I/A 43
04
May 2015
Con fecha 04/05/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 20 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Datos registrales: T 40815 , F 116, S 8, H B 101987, I/A 43
20
Jun 2014
Con fecha 20/06/2014, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART.10:REGIMEN DE TRANSMISION VOLUNTARIA DE ACCIONES POR ACTOS INTER VIVOS.- ART.20:ADOPCION ACUERDOS EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
Datos registrales: T 40815 , F 114, S 8, H B 101987, I/A 41
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-221-08 | Barcelona | 21/11/2023 | |
BORME-A-2023-217-08 | Barcelona | 15/11/2023 | |
BORME-A-2023-68-08 | Barcelona | 11/04/2023 | |
BORME-A-2023-65-08 | Barcelona | 04/04/2023 | |
BORME-A-2022-8-08 | Barcelona | 13/01/2022 | |
BORME-A-2020-153-08 | Barcelona | 10/08/2020 | |
BORME-A-2019-145-08 | Barcelona | 31/07/2019 | |
BORME-A-2019-72-08 | Barcelona | 12/04/2019 | |
BORME-A-2018-224-08 | Barcelona | 22/11/2018 | |
BORME-A-2018-127-08 | Barcelona | 04/07/2018 | |
BORME-A-2018-52-08 | Barcelona | 14/03/2018 | |
BORME-A-2017-42-08 | Barcelona | 01/03/2017 | |
BORME-A-2015-162-08 | Barcelona | 26/08/2015 | |
BORME-A-2015-88-08 | Barcelona | 12/05/2015 | |
BORME-A-2014-119-08 | Barcelona | 26/06/2014 | |
BORME-A-2013-176-08 | Barcelona | 16/09/2013 | |
BORME-A-2013-171-08 | Barcelona | 09/09/2013 | |
BORME-A-2012-228-08 | Barcelona | 28/11/2012 | |
BORME-A-2012-172-08 | Barcelona | 07/09/2012 | |
BORME-A-2012-89-08 | Barcelona | 11/05/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades