Última actualización: 29 de Marzo de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B66590340 |
Provincia | Barcelona |
Fecha de constitución | 24 de Agosto de 2015 (hace 8 años, 7 meses) |
Domicilio | Pz Pau Vila 1 P.1 Sector A Ed.Palau De Mar (Barcelona). |
Objeto social | Comercializacion e intermediacion de productos y servicios para macotas domesticas a traves de medios electronicos, fundamentalmente internet.comercio mayor y menor de articulos para mascostas,productos fitosanitarios,etc. |
Capital social | 804.749,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADM.CONCURS. | Pardo Ibañez Borja | 29/03/2023 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Galdeano Godoy Adria | 21/10/2021 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Olive Fernandez Gerard | 04/10/2021 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Nuche Sanz Javier | 04/10/2021 | Actualidad |
SECR.NO CONS | Navaja Ferrer Josep | 04/10/2021 | Actualidad |
CONSEJERO | Marplan Blau SL | 04/10/2021 | Actualidad |
V-SEC NO CON | Mancia Manzon Pablo | 04/10/2021 | Actualidad |
CONSEJERO | Frey Miquel Alexander | 04/10/2021 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Esteve Arcos Rafael | 04/10/2021 | Actualidad |
CONSEJERO | Atres Hub Factory SL | 04/10/2021 | Actualidad |
PRESIDENTE | Antai Venture Builder SL | 04/10/2021 | Actualidad |
CONSEJERO | Antai Venture Builder SL | 04/10/2021 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Sanchez Milan Eduard | 07/07/2020 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Galvao Torreira Leonardo | 24/08/2015 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SECR.NO CONS | Villa Sanchez David | 29/08/2016 | 04/10/2021 |
APODERAD.SOL | Rafael Mastroianni | 07/07/2020 | 04/10/2021 |
REPR.143 RRM | Olive Fernandez Gerard | 17/06/2020 | 04/10/2021 |
PRESIDENTE | Nuche Sanz Javier | 19/04/2016 | 04/10/2021 |
CONSEJERO | Nuche Sanz Javier | 19/04/2016 | 04/10/2021 |
CONSEJERO | Maso Mas David | 29/08/2016 | 04/10/2021 |
CONSEJERO | Atres Hub Factory SL | 17/06/2020 | 04/10/2021 |
APODERAD.SOL | Torres Baro Demis | 02/01/2017 | 07/07/2020 |
CONSEJERO | Rebuelta Melgarejo Joaquin | 06/03/2019 | 25/06/2020 |
CONSEJERO | Olle Bufi Joan | 29/08/2016 | 25/06/2020 |
CONSEJERO | Cortada Sola Hugo | 04/04/2019 | 09/01/2020 |
CONSEJERO | Jordana Soldevila Marc | 19/04/2016 | 04/04/2019 |
REPR.143 RRM | Rebuelta Melgarejo Joaquin | 29/08/2016 | 18/01/2019 |
CONSEJERO | Kibo Ventures SL | 29/08/2016 | 18/01/2019 |
CONSEJERO | De Cristobal Miras Ivan | 29/08/2016 | 01/08/2018 |
CONSEJERO | Rodriguez Rodriguez Carlos Jose | 19/04/2016 | 29/08/2016 |
V-SEC NO CON | Florence Legeay | 19/04/2016 | 29/08/2016 |
SECR.NO CONS | Farres Pineda Jordi | 19/04/2016 | 29/08/2016 |
REPR.143 RRM | Torreira Galvao Leonardo | Desconocido | 19/04/2016 |
ADM.UNICO | Atres Hub Factory SL | 24/08/2015 | 19/04/2016 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Mascoteros Digital Factory SL.
29
Mar 2023
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 11 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1412/2022, AUTO FIRME DE FECHA 25/11/2022, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 48022 , F 81, S 8, H B 472747, I/A 23
29
Mar 2023
Con fecha 29/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONCURS. | Pardo Ibañez Borja |
Datos registrales: T 48022 , F 81, S 8, H B 472747, I/A 23
21
Oct 2021
Con fecha 21/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Galdeano Godoy Adria |
Datos registrales: T 47522 , F 213, S 8, H B 472747, I/A 22
04
Oct 2021
Con fecha 04/10/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART. 9.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES;ART. 12.-JUNTA GENERAL:ARTICULO 19.-RETRIBUCION DE LOS ADMINISTRADORES;ART.20.-CONSEJO DE ADMINISTRACION.
Datos registrales: T 47522 , F 210, S 8, H B 472747, I/A 21
04
Oct 2021
Con fecha 04/10/2021, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 750.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 1369.89% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 804.749,0€.
Datos registrales: T 47522 , F 210, S 8, H B 472747, I/A 21
04
Oct 2021
Con fecha 04/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Olive Fernandez Gerard |
REPR.143 RRM | Nuche Sanz Javier |
SECR.NO CONS | Navaja Ferrer Josep |
CONSEJERO | Marplan Blau SL |
V-SEC NO CON | Mancia Manzon Pablo |
CONSEJERO | Frey Miquel Alexander |
REPR.143 RRM | Esteve Arcos Rafael |
CONSEJERO | Atres Hub Factory SL |
CONSEJERO | Antai Venture Builder SL |
Datos registrales: T 47522 , F 210, S 8, H B 472747, I/A 21
04
Oct 2021
Con fecha 04/10/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Villa Sanchez David |
APODERAD.SOL | Rafael Mastroianni |
REPR.143 RRM | Olive Fernandez Gerard |
PRESIDENTE | Nuche Sanz Javier |
CONSEJERO | Maso Mas David |
CONSEJERO | Atres Hub Factory SL |
Datos registrales: T 47522 , F 210, S 8, H B 472747, I/A 21
30
Dic 2020
Con fecha 30/12/2020, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ARTICULO 12: JUNTA GENERAL.
Datos registrales: T 46461 , F 160, S 8, H B 472747, I/A 20
30
Dic 2020
Con fecha 30/12/2020, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 3.328,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 6.47% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 54.749,0€.
Datos registrales: T 46461 , F 160, S 8, H B 472747, I/A 20
07
Jul 2020
Con fecha 07/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Rafael Mastroianni |
Datos registrales: T 46461 , F 158, S 8, H B 472747, I/A 19
07
Jul 2020
Con fecha 07/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Sanchez Milan Eduard |
Datos registrales: T 46461 , F 156, S 8, H B 472747, I/A 18
07
Jul 2020
Con fecha 07/07/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Torres Baro Demis |
Datos registrales: T 46461 , F 156, S 8, H B 472747, I/A 17
25
Jun 2020
Con fecha 25/06/2020, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART.12: ADOPCION DE ACUERDOS. ART.13: CONVOCATORIA.
Datos registrales: T 46461 , F 153, S 8, H B 472747, I/A 16
25
Jun 2020
Con fecha 25/06/2020, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 12.783,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 33.08% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 51.421,0€.
Datos registrales: T 46461 , F 153, S 8, H B 472747, I/A 16
25
Jun 2020
Con fecha 25/06/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Rebuelta Melgarejo Joaquin |
CONSEJERO | Olle Bufi Joan |
Datos registrales: T 46461 , F 153, S 8, H B 472747, I/A 16
17
Jun 2020
Con fecha 17/06/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Olive Fernandez Gerard |
CONSEJERO | Atres Hub Factory SL |
Datos registrales: T 46461 , F 153, S 8, H B 472747, I/A 15
09
Ene 2020
Con fecha 09/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Cortada Sola Hugo |
Datos registrales: T 46461 , F 153, S 8, H B 472747, I/A 14
04
Abr 2019
Con fecha 04/04/2019, la sociedad cambia su domicilio social a PZ PAU VILA 1 P.1 SECTOR A ED.PALAU DE MAR (BARCELONA).
Datos registrales: T 46461 , F 152, S 8, H B 472747, I/A 13
04
Abr 2019
Con fecha 04/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Cortada Sola Hugo |
Datos registrales: T 46461 , F 152, S 8, H B 472747, I/A 13
04
Abr 2019
Con fecha 04/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Jordana Soldevila Marc |
Datos registrales: T 46461 , F 152, S 8, H B 472747, I/A 13
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-68-08 | Barcelona | 11/04/2023 | |
BORME-A-2021-210-08 | Barcelona | 02/11/2021 | |
BORME-A-2021-199-08 | Barcelona | 15/10/2021 | |
BORME-A-2021-4-08 | Barcelona | 08/01/2021 | |
BORME-A-2020-135-08 | Barcelona | 15/07/2020 | |
BORME-A-2020-127-08 | Barcelona | 03/07/2020 | |
BORME-A-2020-121-08 | Barcelona | 25/06/2020 | |
BORME-A-2020-11-08 | Barcelona | 17/01/2020 | |
BORME-A-2019-72-08 | Barcelona | 12/04/2019 | |
BORME-A-2019-55-08 | Barcelona | 20/03/2019 | |
BORME-A-2019-50-08 | Barcelona | 13/03/2019 | |
BORME-A-2019-21-08 | Barcelona | 31/01/2019 | |
BORME-A-2018-154-08 | Barcelona | 10/08/2018 | |
BORME-A-2018-132-08 | Barcelona | 11/07/2018 | |
BORME-A-2017-243-08 | Barcelona | 26/12/2017 | |
BORME-A-2017-153-08 | Barcelona | 11/08/2017 | |
BORME-A-2017-8-08 | Barcelona | 12/01/2017 | |
BORME-A-2016-240-08 | Barcelona | 20/12/2016 | |
BORME-A-2016-170-08 | Barcelona | 06/09/2016 | |
BORME-A-2016-90-08 | Barcelona | 12/05/2016 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades