Última actualización: 1 de Junio de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 11 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A83254136 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Avda De La Constitucion 3 (Coslada). |
Capital social | 500.000,0 euros |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Rubias Carreras Jose Manuel | 20/01/2011 | 01/06/2018 |
Apoderado | Puentes Hernandez Elsa | 02/01/2015 | 01/06/2018 |
Secretario | Henon Stephane | 20/01/2012 | 01/06/2018 |
Secretario | Henon Stephane | 08/04/2016 | 01/06/2018 |
Consejero | Henon Stephane | 20/01/2012 | 01/06/2018 |
Consejero | Henon Stephane | 08/04/2016 | 01/06/2018 |
Apoderado | Henon Stephane | 02/07/2014 | 01/06/2018 |
Presidente | Deprez Gerard | 17/10/2017 | 01/06/2018 |
Presidente | Deprez Gerard | 23/05/2013 | 01/06/2018 |
Consejero | Deprez Gerard | 17/10/2017 | 01/06/2018 |
Consejero | Deprez Gerard | 23/05/2013 | 01/06/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 01/10/2009 | 01/06/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 27/04/2015 | 01/06/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 17/10/2017 | 01/06/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 02/07/2014 | 01/06/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 03/01/2014 | 01/06/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 22/11/2016 | 01/06/2018 |
Auditor | Deloitte SL | 20/01/2016 | 01/06/2018 |
Consejero | Bourmaud Patrick | 17/10/2017 | 01/06/2018 |
Consejero | Bourmaud Patrick | 23/05/2013 | 01/06/2018 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Loxam Alquiler SA.
01
Jun 2018
Con fecha 01/06/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 39
01
Jun 2018
Con fecha 01/06/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 39
01
Jun 2018
Con fecha 01/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Henon Stephane |
Presidente | Deprez Gerard |
Consejero | Bourmaud Patrick |
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 39
27
Mar 2018
Con fecha 27/03/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias HUNE RENTAL SL.
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 38
17
Oct 2017
Con fecha 17/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Deprez Gerard |
Auditor | Deloitte SL |
Consejero | Bourmaud Patrick |
Datos registrales: T 17572 , F 222, S 8, H M 302134, I/A 37
22
Nov 2016
Con fecha 22/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 17572 , F 221, S 8, H M 302134, I/A 36
20
Abr 2016
Sociedades absorbidas: HERTZ ALQUILER DE MAQUINARIA SL.
Datos registrales: T 17572 , F 219, S 8, H M 302134, I/A 35
08
Abr 2016
Con fecha 08/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Henon Stephane |
Datos registrales: T 17572 , F 219, S 8, H M 302134, I/A 34
20
Ene 2016
Con fecha 20/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 17572 , F 219, S 8, H M 302134, I/A 33
27
Abr 2015
Con fecha 27/04/2015, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 400.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 80.00% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 500.000,0€.
Datos registrales: T 17572 , F 218, S 8, H M 302134, I/A 32
27
Abr 2015
Con fecha 27/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 17572 , F 218, S 8, H M 302134, I/A 31
02
Ene 2015
Con fecha 02/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Puentes Hernandez Elsa |
Datos registrales: T 17572 , F 218, S 8, H M 302134, I/A 30
02
Ene 2015
Con fecha 02/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Echarri Ardanaz Alberto |
Datos registrales: T 17572 , F 218, S 8, H M 302134, I/A 30
02
Jul 2014
Con fecha 02/07/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 17572 , F 217, S 8, H M 302134, I/A 29
02
Jul 2014
Con fecha 02/07/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Henon Stephane |
Datos registrales: T 17572 , F 215, S 8, H M 302134, I/A 28
02
Jul 2014
Con fecha 02/07/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Sanchez Sanchez Francisco Javier |
Apo.Man.Soli | Sanchez Chiner Juan-Vicente |
Apo.Man.Soli | Fournier Bernard |
Datos registrales: T 17572 , F 215, S 8, H M 302134, I/A 28
03
Ene 2014
Con fecha 03/01/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 17572 , F 215, S 8, H M 302134, I/A 27
23
May 2013
Con fecha 23/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Deprez Gerard |
Datos registrales: T 17572 , F 215, S 8, H M 302134, I/A 26
23
May 2013
Con fecha 23/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Deprez Gerard |
Consejero | Bourmaud Patrick |
Datos registrales: T 17572 , F 215, S 8, H M 302134, I/A 26
23
May 2013
Con fecha 23/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Coquinot Yves |
Datos registrales: T 17572 , F 215, S 8, H M 302134, I/A 26
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2018-111-28 | Madrid | 12/06/2018 |
BORME-A-2018-68-28 | Madrid | 09/04/2018 |
BORME-A-2017-204-28 | Madrid | 25/10/2017 |
BORME-A-2016-230-28 | Madrid | 02/12/2016 |
BORME-A-2016-80-28 | Madrid | 27/04/2016 |
BORME-A-2016-72-28 | Madrid | 15/04/2016 |
BORME-A-2016-18-28 | Madrid | 28/01/2016 |
BORME-A-2015-84-28 | Madrid | 06/05/2015 |
BORME-A-2015-83-28 | Madrid | 05/05/2015 |
BORME-A-2015-7-28 | Madrid | 13/01/2015 |
BORME-A-2014-128-28 | Madrid | 09/07/2014 |
BORME-A-2014-7-28 | Madrid | 13/01/2014 |
BORME-A-2013-101-28 | Madrid | 31/05/2013 |
BORME-A-2012-21-28 | Madrid | 31/01/2012 |
BORME-A-2011-21-28 | Madrid | 01/02/2011 |
BORME-A-2010-226-28 | Madrid | 25/11/2010 |
BORME-A-2010-169-28 | Madrid | 02/09/2010 |
BORME-A-2010-157-28 | Madrid | 17/08/2010 |
BORME-A-2009-197-28 | Madrid | 15/10/2009 |
BORME-A-2009-79-28 | Madrid | 28/04/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades