Última actualización: 7 de Abril de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 11 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B84933779 |
Provincia | Madrid |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apo.Man.Soli | Rubio Rodriguez Ana Isabel | 30/04/2019 | 07/04/2022 |
Apoderado | Ramos Rodriguez Beatriz | 27/06/2018 | 07/04/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/10/2016 | 07/04/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 09/10/2014 | 07/04/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 04/11/2013 | 07/04/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 25/01/2013 | 07/04/2022 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 25/01/2013 | 07/04/2022 |
Cons.Del.Man | Muñoz Gomez Francisco Vicente | 24/06/2013 | 07/04/2022 |
Cons.Del.Man | Martirena Fernandez Oscar | 09/01/2020 | 07/04/2022 |
Apo.Man.Soli | Gorjux Philippe Jean Claude | 30/04/2019 | 07/04/2022 |
Apoderado | Gomez Garcia Enrique | 05/03/2013 | 07/04/2022 |
Apo.Man.Soli | Gil Arias Francisca | 30/04/2019 | 07/04/2022 |
Secretario | Garrido Gancedo Cesar | Desconocido | 07/04/2022 |
Liquidador | Garrido Gancedo Cesar | 07/04/2022 | 07/04/2022 |
Apo.Man.Soli | De Miguel Ramon Sergio | 30/04/2019 | 07/04/2022 |
Apo.Sol. | Capita Escobar Jose | 30/04/2019 | 07/04/2022 |
Consejero | Bottinelli Francois Laurent | 27/06/2018 | 07/04/2022 |
Cons.Del.Man | Bottinelli Francois Laurent | 09/01/2020 | 07/04/2022 |
Consejero | Baeyens Joachim-Eric | 09/01/2020 | 07/04/2022 |
Cons.Del.Man | Baeyens Joachim-Eric | 09/01/2020 | 07/04/2022 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Laudate Alquiler España SL.
07
Abr 2022
Con fecha 07/04/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 30856 , F 214, S 8, H M 425895, I/A 32
07
Abr 2022
Con fecha 07/04/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 30856 , F 214, S 8, H M 425895, I/A 32
07
Abr 2022
Con fecha 07/04/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Garrido Gancedo Cesar |
Datos registrales: T 30856 , F 214, S 8, H M 425895, I/A 32
07
Abr 2022
Con fecha 07/04/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Man | Martirena Fernandez Oscar |
Secretario | Garrido Gancedo Cesar |
Consejero | Bottinelli Francois Laurent |
Consejero | Baeyens Joachim-Eric |
Datos registrales: T 30856 , F 214, S 8, H M 425895, I/A 32
09
Ene 2020
Con fecha 09/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Man | Martirena Fernandez Oscar |
Cons.Del.Man | Bottinelli Francois Laurent |
Cons.Del.Man | Baeyens Joachim-Eric |
Datos registrales: T 30856 , F 213, S 8, H M 425895, I/A 31
09
Ene 2020
Con fecha 09/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Man | Martirena Fernandez Oscar |
Cons.Del.Man | Gorjux Philippe Jean Claude |
Cons.Del.Man | Bottinelli Francois Laurent |
Datos registrales: T 30856 , F 213, S 8, H M 425895, I/A 31
22
May 2019
Con fecha 22/05/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Martirena Fernandez Oscar |
Apo.Man.Soli | Karlsson Johan Olof |
Apo.Man.Soli | Gil Arias Francisca |
Apo.Man.Soli | Garrido Gancedo Cesar |
Apo.Man.Soli | Capita Escobar Jose |
Datos registrales: T 30856 , F 213, S 8, H M 425895, I/A 30
30
Abr 2019
Con fecha 30/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Rubio Rodriguez Ana Isabel |
Apo.Man.Soli | Gorjux Philippe Jean Claude |
Apo.Man.Soli | Gil Arias Francisca |
Apo.Man.Soli | Garrido Gancedo Cesar |
Apo.Man.Soli | De Miguel Ramon Sergio |
Apo.Sol. | Capita Escobar Jose |
Datos registrales: T 30856 , F 212, S 8, H M 425895, I/A 29
09
Abr 2019
Con fecha 09/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Gonzalez Miguelez Candido |
Datos registrales: T 30856 , F 212, S 8, H M 425895, I/A 28
04
Mar 2019
Con fecha 04/03/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Gonzalez Miguelez Candido |
Datos registrales: T 30856 , F 212, S 8, H M 425895, I/A 27
16
Nov 2018
Con fecha 16/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 30856 , F 211, S 8, H M 425895, I/A 26
27
Jun 2018
Con fecha 27/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Ramos Rodriguez Beatriz |
Datos registrales: T 30856 , F 211, S 8, H M 425895, I/A 25
27
Jun 2018
Con fecha 27/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Man | Martirena Fernandez Oscar |
Consejero | Gorjux Philippe Jean Claude |
Presidente | Bottinelli Francois Laurent |
Datos registrales: T 30856 , F 210, S 8, H M 425895, I/A 24
27
Jun 2018
Con fecha 27/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Karlsson Johan Olof |
Consejero | Gonzalez Miguelez Candido |
Datos registrales: T 30856 , F 210, S 8, H M 425895, I/A 24
17
Oct 2017
Con fecha 17/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30856 , F 210, S 8, H M 425895, I/A 23
24
Oct 2016
Con fecha 24/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 30856 , F 210, S 8, H M 425895, I/A 22
24
May 2016
Con fecha 24/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Tora Rodamilans Miquel |
Apoderado | Santos Fuerte Maria Dolores |
Apoderado | Sanjuan De Coca Jose Maria |
Apoderado | Gil Arias Francisca |
Apoderado | Garrido Gancedo Cesar |
Apoderado | De Andres Riofrio Francisco Jose |
Apoderado | Capita Escobar Jose |
Apoderado | Baeyens Joachim-Eric |
Datos registrales: T 30856 , F 210, S 8, H M 425895, I/A 21
24
May 2016
Con fecha 24/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Martirena Fernandez Oscar |
Apo.Man.Soli | Karlsson Johan Olof |
Apo.Man.Soli | Gonzalez Miguelez Candido |
Apo.Man.Soli | Gil Arias Francisca |
Apo.Man.Soli | Garrido Gancedo Cesar |
Apo.Man.Soli | Capita Escobar Jose |
Datos registrales: T 30856 , F 208, S 8, H M 425895, I/A 20
19
Abr 2016
Con fecha 19/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Martirena Fernandez Oscar |
Presidente | Karlsson Johan Olof |
Consejero | Gonzalez Miguelez Candido |
Datos registrales: T 30856 , F 208, S 8, H M 425895, I/A 19
19
Abr 2016
Con fecha 19/04/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Cons.Del.Man | Muñoz Gomez Francisco Vicente |
Presidente | Gorjux Philippe Jean Claude |
Cons.Del.Man | Baeyens Joachim-Eric |
Datos registrales: T 30856 , F 208, S 8, H M 425895, I/A 19
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2022-73-28 | Madrid | 18/04/2022 |
BORME-A-2020-10-28 | Madrid | 16/01/2020 |
BORME-A-2019-100-28 | Madrid | 29/05/2019 |
BORME-A-2019-88-28 | Madrid | 10/05/2019 |
BORME-A-2019-74-28 | Madrid | 16/04/2019 |
BORME-A-2019-48-28 | Madrid | 11/03/2019 |
BORME-A-2018-225-28 | Madrid | 23/11/2018 |
BORME-A-2018-128-28 | Madrid | 05/07/2018 |
BORME-A-2017-204-28 | Madrid | 25/10/2017 |
BORME-A-2016-208-28 | Madrid | 31/10/2016 |
BORME-A-2016-102-28 | Madrid | 31/05/2016 |
BORME-A-2016-80-28 | Madrid | 27/04/2016 |
BORME-A-2015-184-28 | Madrid | 25/09/2015 |
BORME-A-2014-199-28 | Madrid | 17/10/2014 |
BORME-A-2013-216-28 | Madrid | 12/11/2013 |
BORME-A-2013-122-28 | Madrid | 01/07/2013 |
BORME-A-2013-64-28 | Madrid | 05/04/2013 |
BORME-A-2013-51-28 | Madrid | 14/03/2013 |
BORME-A-2013-49-28 | Madrid | 12/03/2013 |
BORME-A-2013-24-28 | Madrid | 05/02/2013 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades