Última actualización: 7 de Febrero de 2022
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 2 años, 2 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | W0069849H |
Denominación anterior | J.P. Morgan International Bank LTD |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Paseo De La Castellana 31 (Madrid). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Apoderado | Vicente Perez Ana | 12/04/2012 | 07/02/2022 |
Apo.Manc. | Vicente Perez Ana | 27/07/2017 | 07/02/2022 |
Apoderado | Soler Ortiz Maria | 22/01/2019 | 07/02/2022 |
Apo.Sol. | Soler Ortiz Maria | 06/11/2019 | 07/02/2022 |
Apoderado | Sara Ruiz Perez | 30/06/2021 | 07/02/2022 |
Apoderado | Ruano Jimenez Jeronimo | 09/06/2015 | 07/02/2022 |
Apo.Sol. | Ruano Jimenez Jeronimo | 27/07/2017 | 07/02/2022 |
Apoderado | Rengifo Abbad Paola | 09/06/2015 | 07/02/2022 |
Apo.Manc. | Rengifo Abbad Paola | 27/07/2017 | 07/02/2022 |
Apo.Manc. | Lopez Martinez Fabiola | 19/07/2018 | 07/02/2022 |
Apo.Manc. | Hergueta Gonzalez Marta | 02/04/2019 | 07/02/2022 |
Apo.Manc. | Hergueta Gonzalez Marta | 02/04/2019 | 07/02/2022 |
Apoderado | Ferrero Perez Jorge | 09/06/2015 | 07/02/2022 |
Apo.Sol. | Ferrero Perez Jorge | 27/07/2017 | 07/02/2022 |
Apo.Sol. | Diez Gil Ana | 27/07/2017 | 07/02/2022 |
Apo.Manc. | Bañuelos Herrera Sonia | 19/07/2018 | 07/02/2022 |
R.L.C.Perma. | Astarloa Echevarrieta Francisco De Borja | 22/01/2019 | 07/02/2022 |
R.L.C.Perma. | Astarloa Echevarrieta Francisco De Borja | 20/09/2017 | 07/02/2022 |
Apoderado | Andres Herman Cristina | 09/06/2015 | 07/02/2022 |
Apo.Man.Soli | Alvarez Gonzalez Irene | 29/03/2021 | 07/02/2022 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por J. P. Morgan Bank Luxembourg SA.
07
Feb 2022
Con fecha 07/02/2022 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 39677 , F 65, S 8, H M 444149, I/A 51
13
Jul 2021
REVOCACION DE LOS SIGUIENTES PODERES: A FAVOR DE DOÑA ANA VICENTE PEREZ EN LA INSCRIPCION 32ª Y DE DOÑA IRENE ALVAREZ GONZALEZ EN LA INSCRIPCION 47ª, SOLO EN CUANTO A LOS ASUNTOS LABORALES.
Datos registrales: T 39677 , F 64, S 8, H M 444149, I/A 50
13
Jul 2021
Con fecha 13/07/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Vicente Perez Ana |
Apo.Sol. | Marshall Anne Madeleine |
Apo.Sol. | Alvarez Gonzalez Irene |
Datos registrales: T 39677 , F 64, S 8, H M 444149, I/A 50
30
Jun 2021
Intermediación en la compraventa de bienes inmuebles de uso comercial ubicados en España para la base de clientes española de banca privada ya existente de la firma.
Datos registrales: T 39677 , F 63, S 8, H M 444149, I/A 49
30
Jun 2021
Con fecha 30/06/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Soler Ortiz Maria |
Apoderado | Sara Ruiz Perez |
Apoderado | Astarloa Echevarrieta Francisco De Borja |
Datos registrales: T 39677 , F 63, S 8, H M 444149, I/A 49
24
May 2021
ACTUALIZACION DE LOS DATOS GENERALES Y DE LA COMPOSICION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ.
Datos registrales: T 39677 , F 60, S 8, H M 444149, I/A 48
29
Mar 2021
Con fecha 29/03/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Alvarez Gonzalez Irene |
Datos registrales: T 39677 , F 60, S 8, H M 444149, I/A 47
30
Sep 2020
Con fecha 30/09/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Laurinaitis Tracie Olesia |
Datos registrales: T 39677 , F 60, S 8, H M 444149, I/A 46
14
Sep 2020
ACTUALIZACION DE LA COMPOSICION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 302.1 R.R.M.
Datos registrales: T 39677 , F 57, S 8, H M 444149, I/A 45
06
Nov 2019
INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUCURSAL.
Datos registrales: T 36108 , F 225, S 8, H M 444149, I/A 44
06
Nov 2019
Con fecha 06/11/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Soler Ortiz Maria |
Apo.Sol. | Ruiz Perez Sara Maria |
Apo.Sol. | Astarloa Echevarrieta Francisco De Borja |
Datos registrales: T 36108 , F 225, S 8, H M 444149, I/A 44
24
Oct 2019
Con fecha 24/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gonzalez Adalid Guerreiro Beatriz |
Datos registrales: T 36108 , F 225, S 8, H M 444149, I/A 43
29
Jul 2019
TOMA DE RAZON DE LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD MATRIZ CONFORME AL ART. 302.1 RRM.
Datos registrales: T 36108 , F 222, S 8, H M 444149, I/A 42
15
Jul 2019
Con fecha 15/07/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | De La Cruz Plaza Beatriz |
Datos registrales: T 36108 , F 222, S 8, H M 444149, I/A 41
18
Jun 2019
Con fecha 18/06/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Iso De Castro Leyre |
Datos registrales: T 36108 , F 222, S 8, H M 444149, I/A 40
02
Abr 2019
Con fecha 02/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Laurinaitis Tracie Olesia |
Apo.Manc. | Hergueta Gonzalez Marta |
Apo.Manc. | De La Cruz Plaza Beatriz |
Datos registrales: T 36108 , F 220, S 8, H M 444149, I/A 39
02
Abr 2019
Con fecha 02/04/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Valiente Guimaraes Maria |
Datos registrales: T 36108 , F 220, S 8, H M 444149, I/A 39
19
Mar 2019
Cambiada la composición del órgano de administración de la entidad matriz. Modificaciones en los estatutos sociales de la entidad matriz.
Datos registrales: T 36108 , F 220, S 8, H M 444149, I/A 38
22
Ene 2019
Con fecha 22/01/2019, la sociedad cambia su denominación social a J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG SA SUCURSAL EN ESPAÑA
Datos registrales: T 36108 , F 211, S 8, H M 444149, I/A 37
22
Ene 2019
Las entidades J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED y J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG SA , se han fusionado con fecha 25 de enero 2019, la sucursal en España de J.P. MORGAN INTERNATIONAL BANK LIMITED pasa a ser sucursal de J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG SA, con los mismos activos, pasivos y empleados.
Datos registrales: T 36108 , F 211, S 8, H M 444149, I/A 37
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2022-30-28 | Madrid | 14/02/2022 | |
BORME-A-2021-137-28 | Madrid | 20/07/2021 | |
BORME-A-2021-128-28 | Madrid | 07/07/2021 | |
BORME-A-2021-101-28 | Madrid | 31/05/2021 | |
BORME-A-2021-64-28 | Madrid | 07/04/2021 | |
BORME-A-2020-195-28 | Madrid | 07/10/2020 | |
BORME-A-2020-183-28 | Madrid | 21/09/2020 | |
BORME-A-2019-218-28 | Madrid | 13/11/2019 | |
BORME-A-2019-210-28 | Madrid | 31/10/2019 | |
BORME-A-2019-148-28 | Madrid | 05/08/2019 | |
BORME-A-2019-138-28 | Madrid | 22/07/2019 | |
BORME-A-2019-119-28 | Madrid | 25/06/2019 | |
BORME-A-2019-69-28 | Madrid | 09/04/2019 | |
BORME-A-2019-59-28 | Madrid | 26/03/2019 | |
BORME-A-2019-19-28 | Madrid | 29/01/2019 | |
BORME-A-2018-143-28 | Madrid | 26/07/2018 | |
BORME-A-2018-90-28 | Madrid | 11/05/2018 | |
BORME-A-2018-73-28 | Madrid | 16/04/2018 | |
BORME-A-2017-186-28 | Madrid | 28/09/2017 | |
BORME-A-2017-148-28 | Madrid | 04/08/2017 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades