Última actualización: 28 de Junio de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 5 años, 9 meses |
---|---|
Forma jurídica | Limited company |
Denominación anterior | Catapult Communications LTD |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ General Pardiñas 114 - 1º A (Madrid). |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R.L.C.Perma. | Sordo Miralles Arturo Tomas | 27/06/2017 | 28/06/2018 |
Apo.Sol. | Romboli Maria Teresa | 24/04/2018 | 28/06/2018 |
Apoderado | Perez Mansilla Delgado Patricia | Desconocido | 28/06/2018 |
Apoderado | Mendez Zori Jose Maria | Desconocido | 28/06/2018 |
Apo.Sol. | Medina De Toro Carlos | 24/04/2018 | 28/06/2018 |
Apoderado | Mafuz Gumiel Rosa Maria | Desconocido | 28/06/2018 |
Apo.Sol. | Diaz Crespo Rosalia | Desconocido | 28/06/2018 |
R.L.C.Per.M. | Sordo Miralles Arturo Tomas | Desconocido | 27/06/2017 |
R.L.C.Per.M. | Denton David John | Desconocido | 27/06/2017 |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Ixia Technologies Europe LTD.
28
Jun 2018
Con fecha 28/06/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 27201 , F 53, S 8, H M 490085, I/A 12
28
Jun 2018
Con fecha 28/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Romboli Maria Teresa |
Apoderado | Perez Mansilla Delgado Patricia |
Apoderado | Mendez Zori Jose Maria |
Apo.Sol. | Medina De Toro Carlos |
Apoderado | Mafuz Gumiel Rosa Maria |
Apo.Sol. | Diaz Crespo Rosalia |
Datos registrales: T 27201 , F 53, S 8, H M 490085, I/A 12
28
Jun 2018
Con fecha 28/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Sordo Miralles Arturo Tomas |
Datos registrales: T 27201 , F 53, S 8, H M 490085, I/A 12
24
Abr 2018
Con fecha 24/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Romboli Maria Teresa |
Apo.Sol. | Medina De Toro Carlos |
Datos registrales: T 27201 , F 51, S 8, H M 490085, I/A 11
03
Jul 2017
QUE EN LA ACTUALIDAD EL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ, ESTA COMPUESTO POR D. MATTHEW ALEXANDER; D. TIMOTHY BRENT NOVAK.-
Datos registrales: T 27201 , F 29, S 8, H M 490085, I/A 10
27
Jun 2017
Con fecha 27/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Perma. | Sordo Miralles Arturo Tomas |
Datos registrales: T 27201 , F 28, S 8, H M 490085, I/A 9
27
Jun 2017
Con fecha 27/06/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Per.M. | Sordo Miralles Arturo Tomas |
R.L.C.Per.M. | Denton David John |
Datos registrales: T 27201 , F 28, S 8, H M 490085, I/A 9
10
Mar 2017
Con fecha 10/03/2017, la sociedad cambia su domicilio social a C/ GENERAL PARDIÑAS 114 - 1º A (MADRID).
Datos registrales: T 27201 , F 27, S 8, H M 490085, I/A 8
17
Feb 2017
QUE EL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ, ESTA INTEGRADO POR: DON RONALD WILLIAM BUCKLY (estadounidense); DON MARK DUNCAN CHAPLAIN (britanico), DON DAVID JOHN DENTON (britanico), DON BRENT TIMOTHY NOVAK (estadounidense).
Datos registrales: T 27201 , F 27, S 8, H M 490085, I/A 7
04
Sep 2014
DECLARACION DE LOS MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD MATRIZ EN RELACION CON LA SUCURSAL EN ESPAÑA; DON RONALD WILLIAM BUCKLY, PASAPORTE 442681047; DON MARK DUNCAN CHAPLAIN, PASAPORTE 800286248; DON DAVID JOHN DENTON, PASAPORTE 202439564.
Datos registrales: T 27201 , F 27, S 8, H M 490085, I/A 6
06
Jul 2012
Cambiado el domicilio de "IXIA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED"sociedad matriz de la sucursal a MAIN BUILDING HARTHAM PARK, CORSHAM, WILTSHIRE SN13 ORP.
Datos registrales: T 27201 , F 26, S 8, H M 490085, I/A 5
29
May 2012
Modificada con fecha 1 de febrero de 2010 la denominación de la sociedad matriz de la sucursal a "IXIA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED".
Datos registrales: T 27201 , F 26, S 8, H M 490085, I/A 4
29
May 2012
Con fecha 29/05/2012, la sociedad cambia su domicilio social a C/ LA BOTANICA 4 - P2 (MADRID).
Datos registrales: T 27201 , F 26, S 8, H M 490085, I/A 3
12
Mar 2010
Con fecha 12/03/2010, la sociedad cambia su denominación social a EN ESPAÑA
Datos registrales: T 27201 , F 26, S 8, H M 490085, I/A 2
12
Mar 2010
Con fecha 12/03/2010, la sociedad cambia su denominación social a IXIA TECHNOLOGIES EUROPE LIMITED
Datos registrales: T 27201 , F 26, S 8, H M 490085, I/A 2
23
Nov 2009
Con fecha 23/11/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
R.L.C.Per.M. | Sordo Miralles Arturo Tomas |
Apoderado | Perez Mansilla Delgado Patricia |
Apoderado | Mendez Zori Jose Maria |
Apoderado | Mafuz Gumiel Rosa Maria |
Apo.Sol. | Diaz Crespo Rosalia |
R.L.C.Per.M. | Denton David John |
Datos registrales: T 27201 , F 22, S 8, H M 490085, I/A 1
23
Nov 2009
Comienzo de operaciones: 3.11.09. Objeto social: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE VENTAS, LA COMERCIALIZACION Y LA PRESTACION DE CUALQUIER OTRO TIPO DE ASISTENCIA Y DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA, TODO ELLO RELACIONADO CON SISTEMAS AVANZADOS DE PRUEBAS Y CONJUNTOS "SUITES" INTEGRADOS DE APLICACIONES DE PRUEBA PRA LA INDUSTRIA DE TELECOMU. Domicilio: C/ NICASIO GALLEGO NUMERO 17, 5º C (MADRID). Capital: 0 Ptas.
Datos registrales: T 27201 , F 22, S 8, H M 490085, I/A 1
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2018-129-28 | Madrid | 06/07/2018 |
BORME-A-2018-85-28 | Madrid | 04/05/2018 |
BORME-A-2017-130-28 | Madrid | 11/07/2017 |
BORME-A-2017-126-28 | Madrid | 05/07/2017 |
BORME-A-2017-55-28 | Madrid | 21/03/2017 |
BORME-A-2017-39-28 | Madrid | 24/02/2017 |
BORME-A-2014-175-28 | Madrid | 15/09/2014 |
BORME-A-2012-136-28 | Madrid | 18/07/2012 |
BORME-A-2012-108-28 | Madrid | 08/06/2012 |
BORME-A-2010-57-28 | Madrid | 25/03/2010 |
BORME-A-2009-231-28 | Madrid | 03/12/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades