Última actualización: 1 de Agosto de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B63710883 |
Provincia | Barcelona |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.INDIV. | Kpmg Auditores SL | 02/03/2022 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Relat Vidal Pau | 26/04/2021 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Crespi Juanola Jordi | 26/04/2021 | Actualidad |
AUDIT.INDIV. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 01/12/2020 | Actualidad |
AUDIT.INDIV. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 10/10/2019 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/10/2018 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 12/01/2018 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/11/2016 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Serra De Arvizau Pablo | 14/08/2015 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Relat Vidal Pau | 14/08/2015 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Companys Gazquez Carlos | 14/08/2015 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Clavell Balda Jordi | 14/08/2015 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Catarineu Barenys Miguel Angel | 14/08/2015 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 30/09/2013 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 22/02/2013 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 11/08/2011 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 28/01/2011 | Actualidad |
APODERADO | Guinot Lozano Alfonso | 28/01/2011 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 10/12/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Torrents Munt Joana Helena | 29/03/2023 | 01/08/2023 |
APOD.SOL/MAN | Serra De Arvizu Pablo | Desconocido | 01/12/2022 |
REPR.143 RRM | Matosas Hoste Eduardo | 21/12/2015 | 26/04/2021 |
ADM.UNICO | Industrias Quimicas Del Valles SA | 21/12/2015 | 26/04/2021 |
CONSEJERO | Serra Caila Fernando | 15/11/2012 | 21/12/2015 |
CONSEJERO | Relat Vidal Pau | Desconocido | 21/12/2015 |
CONS. DELEG. | Relat Vidal Pau | Desconocido | 21/12/2015 |
SECRETARIO | Matosas Hoste Juan | Desconocido | 21/12/2015 |
CONSEJERO | Matosas Hoste Juan | Desconocido | 21/12/2015 |
PRESIDENTE | Matosas Hoste Eduardo | Desconocido | 21/12/2015 |
CONSEJERO | Matosas Hoste Eduardo | Desconocido | 21/12/2015 |
APODERADO | Relat Vidal Pau | Desconocido | 14/08/2015 |
APODERADO | Relat Vidal Pau | 15/10/2009 | 14/08/2015 |
APODERADO | Moreto Matosas Maria Dolores | Desconocido | 14/08/2015 |
APODERADO | Crespi Juanola Jordi | 01/03/2010 | 14/08/2015 |
APOD.SOL/MAN | Clavell Balda Jordi | 13/03/2015 | 14/08/2015 |
APODERADO | Catarineu Barenys Miguel Angel | Desconocido | 14/08/2015 |
APODERADO | Catalan Perez Xavier | 17/07/2012 | 14/08/2015 |
CONSEJERO | Takashi Tanaka | 29/03/2011 | 15/11/2012 |
APODERADO | Soldevila Elias Ferran | 15/10/2009 | 13/01/2012 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Iqv Agro España SL.
01
Ago 2023
Con fecha 01/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Torrents Munt Joana Helena |
Datos registrales: T 48893 , F 166, S 8, H B 296585, I/A 39
29
Mar 2023
Con fecha 29/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Torrents Munt Joana Helena |
Datos registrales: T 45096 , F 199, S 8, H B 296585, I/A 38
01
Dic 2022
Con fecha 01/12/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Serra De Arvizu Pablo |
Datos registrales: T 45096 , F 199, S 8, H B 296585, I/A 37
14
Ago 2015
En el BORME no.161/2015 y con referencia 349795 ERROR EN EL SEGUNDO APELLIDO DEL APODERADO SIENDO EL CORRECTO PABLO SERRA DE ARVIZU.
Datos registrales: T 43475 , F 209, S 8, H B 296585, I/A 27
02
Mar 2022
Con fecha 02/03/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.INDIV. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 45093 , F 199, S 8, H B 296585, I/A 36
26
Abr 2021
Con fecha 26/04/2021, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ADICION DEL ARTICULO 15 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. INTERVENCION DE LA JUNTA GENERAL EN ASUNTOS DE GESTION.
Datos registrales: T 45096 , F 198, S 8, H B 296585, I/A 35
26
Abr 2021
Con fecha 26/04/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Relat Vidal Pau |
ADM.CONJUNTO | Crespi Juanola Jordi |
Datos registrales: T 45096 , F 198, S 8, H B 296585, I/A 35
26
Abr 2021
Con fecha 26/04/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Matosas Hoste Eduardo |
ADM.UNICO | Industrias Quimicas Del Valles SA |
Datos registrales: T 45096 , F 198, S 8, H B 296585, I/A 35
01
Dic 2020
Con fecha 01/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.INDIV. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45096 , F 197, S 8, H B 296585, I/A 34
10
Oct 2019
Con fecha 10/10/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.INDIV. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45096 , F 197, S 8, H B 296585, I/A 33
24
Oct 2018
Con fecha 24/10/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45096 , F 197, S 8, H B 296585, I/A 32
12
Ene 2018
Con fecha 12/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45096 , F 197, S 8, H B 296585, I/A 31
24
Nov 2016
Con fecha 24/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 45096 , F 196, S 8, H B 296585, I/A 30
21
Dic 2015
Con fecha 21/12/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO.
Datos registrales: T 45096 , F 196, S 8, H B 296585, I/A 29
21
Dic 2015
Con fecha 21/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Matosas Hoste Eduardo |
ADM.UNICO | Industrias Quimicas Del Valles SA |
Datos registrales: T 45096 , F 196, S 8, H B 296585, I/A 29
21
Dic 2015
Con fecha 21/12/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Serra Caila Fernando |
CONSEJERO | Relat Vidal Pau |
SECRETARIO | Matosas Hoste Juan |
PRESIDENTE | Matosas Hoste Eduardo |
Datos registrales: T 45096 , F 196, S 8, H B 296585, I/A 29
14
Ago 2015
Con fecha 14/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Companys Gazquez Carlos |
Datos registrales: T 43475 , F 210, S 8, H B 296585, I/A 28
14
Ago 2015
Con fecha 14/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Catarineu Barenys Miguel Angel |
Datos registrales: T 43475 , F 208, S 8, H B 296585, I/A 26
14
Ago 2015
Con fecha 14/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Clavell Balda Jordi |
Datos registrales: T 43475 , F 206, S 8, H B 296585, I/A 25
14
Ago 2015
Con fecha 14/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Relat Vidal Pau |
APODERADO | Moreto Matosas Maria Dolores |
APODERADO | Crespi Juanola Jordi |
APOD.SOL/MAN | Clavell Balda Jordi |
APODERADO | Catarineu Barenys Miguel Angel |
APODERADO | Catalan Perez Xavier |
Datos registrales: T 43475 , F 203, S 8, H B 296585, I/A 23
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-151-08 | Barcelona | 09/08/2023 | |
BORME-A-2023-67-08 | Barcelona | 10/04/2023 | |
BORME-A-2022-235-08 | Barcelona | 13/12/2022 | |
BORME-A-2022-231-08 | Barcelona | 05/12/2022 | |
BORME-A-2022-48-08 | Barcelona | 10/03/2022 | |
BORME-A-2021-82-08 | Barcelona | 04/05/2021 | |
BORME-A-2020-237-08 | Barcelona | 11/12/2020 | |
BORME-A-2019-201-08 | Barcelona | 18/10/2019 | |
BORME-A-2018-211-08 | Barcelona | 02/11/2018 | |
BORME-A-2018-16-08 | Barcelona | 23/01/2018 | |
BORME-A-2016-230-08 | Barcelona | 02/12/2016 | |
BORME-A-2015-248-08 | Barcelona | 30/12/2015 | |
BORME-A-2015-161-08 | Barcelona | 25/08/2015 | |
BORME-A-2015-56-08 | Barcelona | 24/03/2015 | |
BORME-A-2013-192-08 | Barcelona | 08/10/2013 | |
BORME-A-2013-44-08 | Barcelona | 05/03/2013 | |
BORME-A-2012-234-08 | Barcelona | 07/12/2012 | |
BORME-A-2012-226-08 | Barcelona | 26/11/2012 | |
BORME-A-2012-143-08 | Barcelona | 27/07/2012 | |
BORME-A-2012-18-08 | Barcelona | 26/01/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades