Última actualización: 19 de Enero de 2021
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B61631149 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Av Diagonal 662-664 (Barcelona). |
Capital social | 1.343.230,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APODERADO | Mas Sumalla Ramon | 05/08/2011 | 19/01/2021 |
APODERADO | Mas Sumalla Ramon | 02/03/2011 | 19/01/2021 |
APODERADO | Martinez Martin Arturo | 05/08/2011 | 19/01/2021 |
APODERADO | Marquez Rodriguez Eva | 05/08/2011 | 19/01/2021 |
APODERADO | Lora Garcia Marta | 05/08/2011 | 19/01/2021 |
AUDT.CTS.CON | Kpmg Auditores SL | 18/05/2017 | 19/01/2021 |
AUDIT.INDIV. | Kpmg Auditores SL | 07/01/2021 | 19/01/2021 |
AUDT.CTS.CON | Deloitte SL | 17/12/2012 | 19/01/2021 |
AUDT.CTS.CON | Deloitte SL | 23/10/2014 | 19/01/2021 |
AUDT.CTS.CON | Deloitte SL | 24/12/2010 | 19/01/2021 |
AUDIT.CUENT. | Deloitte SL | 17/12/2012 | 19/01/2021 |
AUDIT.CUENT. | Deloitte SL | 05/07/2010 | 19/01/2021 |
AUDIT.CUENT. | Deloitte SL | 22/10/2013 | 19/01/2021 |
AUDIT.CUENT. | Deloitte SL | 05/07/2010 | 19/01/2021 |
AUDIT.CUENT. | Deloitte SL | 11/10/2011 | 19/01/2021 |
CONSEJERO | Centeno Villamor David | 20/08/2012 | 19/01/2021 |
APODERADO | Centeno Villamor David | 05/08/2011 | 19/01/2021 |
APOD.SOL/MAN | Centeno Villamor David | 31/08/2015 | 19/01/2021 |
APODERADO | Alfonso Silvela Laia | 29/05/2012 | 19/01/2021 |
APODERADO | Aguilar Quesada Susana | 05/08/2011 | 19/01/2021 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Inversiones Hemisferio SL.
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 42897 , F 210, S 8, H B 176847, I/A 112
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
LIQUIDADOR | Centeno Villamor David |
Datos registrales: T 42897 , F 210, S 8, H B 176847, I/A 112
19
Ene 2021
Con fecha 19/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Mas Sumalla Ramon |
CONSEJERO | Elias Viñeta Luis |
LIQUIDADOR | Centeno Villamor David |
Datos registrales: T 42897 , F 210, S 8, H B 176847, I/A 112
07
Ene 2021
Con fecha 07/01/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.INDIV. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 42897 , F 210, S 8, H B 176847, I/A 111
28
Mar 2018
Con fecha 28/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Sellares Monros Francesc Xavier |
APODERADO | Sanz Suarez Luis Daniel |
APODERADO | Pina Lara Jose Fernando |
APODERADO | Lara Garcia Jose Manuel |
APODERADO | Jimenez Calavia Javier |
APODERADO | Garay Vigon Rafael |
APODERADO | Faine De Garriga Jordi |
Datos registrales: T 42897 , F 210, S 8, H B 176847, I/A 110
16
Mar 2018
Con fecha 16/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Tous Godia Rafael |
REPR.143 RRM | Suñer Humet Torrellas Jose |
REPR.143 RRM | Oller Bube Nestor |
CONSEJERO | Invest Fontanilles SL |
CONSEJERO | Inversiones Hemisferio SL |
CONSEJERO | Industrial Comenec SL |
CONSEJERO | G3T SL |
REPR.143 RRM | Ferrero Jordi Javier |
REPR.143 RRM | Ferrellad Vallbona Ferran |
SECRETARIO | Eseo 21 SL |
REPR.143 RRM | Creuheras Margenat Jose |
PRESIDENTE | Corporacion Empresarial Emesa SL |
Datos registrales: T 41282 , F 75, S 8, H B 209941, I/A 21
18
May 2017
Con fecha 18/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.INDIV. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 42897 , F 210, S 8, H B 176847, I/A 109
18
May 2017
Con fecha 18/05/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDT.CTS.CON | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42897 , F 210, S 8, H B 176847, I/A 109
15
Feb 2017
Reducción de capital
Datos registrales: T 42897 , F 209, S 8, H B 176847, I/A 108
25
May 2016
Con fecha 25/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Sellares Monros Francesc Xavier |
Datos registrales: T 42897 , F 209, S 8, H B 176847, I/A 107
12
May 2016
Con fecha 12/05/2016, la sociedad cambia su domicilio social a AV DIAGONAL 662-664 (BARCELONA).
Datos registrales: T 42897 , F 209, S 8, H B 176847, I/A 106
29
Ene 2016
Con fecha 29/01/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDT.CTS.CON | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42897 , F 208, S 8, H B 176847, I/A 105
31
Ago 2015
Con fecha 31/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Centeno Villamor David |
Datos registrales: T 42897 , F 206, S 8, H B 176847, I/A 104
31
Ago 2015
Con fecha 31/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Crehueras Margenat Jose |
Datos registrales: T 42897 , F 206, S 8, H B 176847, I/A 104
10
Ago 2015
Con fecha 10/08/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DEL ARTICULO 12 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 42897 , F 206, S 8, H B 176847, I/A 103
10
Ago 2015
Con fecha 10/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
PRESIDENTE | Mas Sumalla Ramon |
SECRETARIO | Elias Viñeta Luis |
Datos registrales: T 42897 , F 206, S 8, H B 176847, I/A 103
10
Ago 2015
Con fecha 10/08/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Elias Viñeta Luis |
CONS. DELEG. | Creuheras Margenat Jose |
Datos registrales: T 42897 , F 206, S 8, H B 176847, I/A 103
03
Nov 2014
Sociedades absorbidas: CAPITAL HEMISFERIO SOCIEDAD ANONIMA S C R DE REGIM.
Datos registrales: T 42780 , F 19, S 8, H B 176847, I/A 102
23
Oct 2014
Con fecha 23/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Deloitte SL |
Datos registrales: T 42780 , F 19, S 8, H B 176847, I/A 101
22
Ene 2014
Con fecha 22/01/2014, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
ART.12: SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 42780 , F 18, S 8, H B 176847, I/A 100
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2021-17-08 | Barcelona | 27/01/2021 | |
BORME-A-2021-9-08 | Barcelona | 15/01/2021 | |
BORME-A-2018-67-08 | Barcelona | 06/04/2018 | |
BORME-A-2018-60-08 | Barcelona | 26/03/2018 | |
BORME-A-2017-98-08 | Barcelona | 26/05/2017 | |
BORME-A-2017-38-08 | Barcelona | 23/02/2017 | |
BORME-A-2016-103-08 | Barcelona | 01/06/2016 | |
BORME-A-2016-95-08 | Barcelona | 20/05/2016 | |
BORME-A-2016-24-08 | Barcelona | 05/02/2016 | |
BORME-A-2015-170-08 | Barcelona | 07/09/2015 | |
BORME-A-2015-155-08 | Barcelona | 17/08/2015 | |
BORME-A-2014-215-08 | Barcelona | 11/11/2014 | |
BORME-A-2014-209-08 | Barcelona | 31/10/2014 | |
BORME-A-2014-20-08 | Barcelona | 30/01/2014 | |
BORME-A-2013-208-08 | Barcelona | 30/10/2013 | |
BORME-A-2013-69-28 | Madrid | 12/04/2013 | |
BORME-A-2012-246-08 | Barcelona | 26/12/2012 | |
BORME-A-2012-166-08 | Barcelona | 30/08/2012 | |
BORME-A-2012-108-08 | Barcelona | 08/06/2012 | |
BORME-A-2011-201-08 | Barcelona | 21/10/2011 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades