Última actualización: 2 de Marzo de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 1 mes |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad de Inversión de Capital Variable |
NIF | A81028706 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | C/ Juan Ignacio Luca De Tena 11 (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ent.Reg.Cont | Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | 22/05/2015 | 02/03/2023 |
SecreNoConsj | Santiago Vargas Maria Del Mar | 20/10/2020 | 02/03/2023 |
Ent. Gestora | Santander Private Banking Gestion SA | Desconocido | 02/03/2023 |
VsecrNoConsj | Rojo Rivera Maria Elena | 02/11/2021 | 02/03/2023 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 25/02/2021 | 02/03/2023 |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 29/08/2017 | 02/03/2023 |
Consejero | Polo Flores Elena | 02/12/2016 | 02/03/2023 |
Consejero | Nuñez-Lagos Moreno Luis | 02/12/2016 | 02/03/2023 |
Presidente | Navarro Vigil Luis Javier | 29/02/2020 | 02/03/2023 |
Liquidador | Navarro Vigil Luis Javier | 02/03/2023 | 02/03/2023 |
Consejero | Navarro Vigil Luis Javier | 11/11/2013 | 02/03/2023 |
Consejero | Muñoz Alamillos Angel | 17/10/2011 | 02/03/2023 |
Consejero | Muñoz Alamillos Angel | 30/11/2021 | 02/03/2023 |
Consejero | Fernandez Villamandos Miguel Angel | 02/12/2016 | 02/03/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 27/08/2010 | 02/03/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 14/09/2012 | 02/03/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 29/07/2015 | 02/03/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 11/11/2013 | 02/03/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 17/10/2011 | 02/03/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 02/12/2016 | 02/03/2023 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Inoinversora Sociedad Anonima SICAV.
02
Mar 2023
Con fecha 02/03/2023 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 8713 , F 185, S 8, H M 140231, I/A 53
02
Mar 2023
Con fecha 02/03/2023 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 8713 , F 185, S 8, H M 140231, I/A 53
02
Mar 2023
Con fecha 02/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Navarro Vigil Luis Javier |
Datos registrales: T 8713 , F 185, S 8, H M 140231, I/A 53
02
Mar 2023
Con fecha 02/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Ent.Reg.Cont | Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co |
SecreNoConsj | Santiago Vargas Maria Del Mar |
Ent. Gestora | Santander Private Banking Gestion SA |
VsecrNoConsj | Rojo Rivera Maria Elena |
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Consejero | Polo Flores Elena |
Presidente | Navarro Vigil Luis Javier |
Consejero | Muñoz Alamillos Angel |
Consejero | Fernandez Villamandos Miguel Angel |
EntidDeposit | Caceis Bank Spain SA |
Datos registrales: T 8713 , F 185, S 8, H M 140231, I/A 53
18
Nov 2022
Con fecha 18/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Fernandez-Miranda Vidal Alfonso |
Datos registrales: T 8713 , F 184, S 8, H M 140231, I/A 52
30
Nov 2021
Con fecha 30/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Consejero | Polo Flores Elena |
Consejero | Muñoz Alamillos Angel |
Consejero | Fernandez Villamandos Miguel Angel |
Datos registrales: T 8713 , F 184, S 8, H M 140231, I/A 51
02
Nov 2021
Con fecha 02/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Rojo Rivera Maria Elena |
Datos registrales: T 8713 , F 184, S 8, H M 140231, I/A 50
02
Nov 2021
Con fecha 02/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | De La Esperanza Rodriguez Pedro Ramon |
Datos registrales: T 8713 , F 184, S 8, H M 140231, I/A 50
25
Feb 2021
Con fecha 25/02/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 8713 , F 183, S 8, H M 140231, I/A 49
20
Oct 2020
Con fecha 20/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Santiago Vargas Maria Del Mar |
Datos registrales: T 8713 , F 183, S 8, H M 140231, I/A 48
20
Oct 2020
Con fecha 20/10/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Hernandez Sampelayo Matos Lourdes |
Datos registrales: T 8713 , F 183, S 8, H M 140231, I/A 48
29
Feb 2020
Con fecha 29/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Navarro Vigil Luis Javier |
Datos registrales: T 8713 , F 183, S 8, H M 140231, I/A 47
29
Feb 2020
Con fecha 29/02/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Salgado Villegas Vicente |
Datos registrales: T 8713 , F 183, S 8, H M 140231, I/A 47
10
Ene 2019
Con fecha 10/01/2019, la sociedad cambia su domicilio social a C/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11 (MADRID).
Datos registrales: T 8713 , F 183, S 8, H M 140231, I/A 46
20
Sep 2018
Con fecha 20/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Navarro Vigil Luis Javier |
Datos registrales: T 8713 , F 182, S 8, H M 140231, I/A 45
20
Sep 2018
Con fecha 20/09/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Nuñez-Lagos Moreno Luis |
Datos registrales: T 8713 , F 182, S 8, H M 140231, I/A 45
29
Ago 2017
Con fecha 29/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Salgado Villegas Vicente |
Datos registrales: T 8713 , F 182, S 8, H M 140231, I/A 44
29
Ago 2017
Con fecha 29/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 8713 , F 182, S 8, H M 140231, I/A 44
29
Ago 2017
Con fecha 29/08/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Del Castillo Ferrer-Vidal Santiago |
Datos registrales: T 8713 , F 182, S 8, H M 140231, I/A 44
02
Dic 2016
Con fecha 02/12/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Polo Flores Elena |
Consejero | Nuñez-Lagos Moreno Luis |
Consejero | Muñoz Alamillos Angel |
Consejero | Fernandez Villamandos Miguel Angel |
Auditor | Deloitte SL |
Consejero | Del Castillo Ferrer-Vidal Santiago |
Datos registrales: T 8713 , F 181, S 8, H M 140231, I/A 43
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-48-28 | Madrid | 09/03/2023 | |
BORME-A-2022-225-28 | Madrid | 25/11/2022 | |
BORME-A-2021-234-28 | Madrid | 09/12/2021 | |
BORME-A-2021-215-28 | Madrid | 10/11/2021 | |
BORME-A-2021-43-28 | Madrid | 04/03/2021 | |
BORME-A-2020-208-28 | Madrid | 27/10/2020 | |
BORME-A-2020-46-28 | Madrid | 06/03/2020 | |
BORME-A-2019-12-28 | Madrid | 18/01/2019 | |
BORME-A-2018-188-28 | Madrid | 28/09/2018 | |
BORME-A-2017-169-28 | Madrid | 05/09/2017 | |
BORME-A-2016-238-28 | Madrid | 16/12/2016 | |
BORME-A-2015-149-28 | Madrid | 07/08/2015 | |
BORME-A-2015-148-28 | Madrid | 06/08/2015 | |
BORME-A-2015-102-28 | Madrid | 02/06/2015 | |
BORME-A-2014-195-28 | Madrid | 13/10/2014 | |
BORME-A-2013-223-28 | Madrid | 21/11/2013 | |
BORME-A-2013-198-28 | Madrid | 16/10/2013 | |
BORME-A-2012-190-28 | Madrid | 02/10/2012 | |
BORME-A-2012-186-28 | Madrid | 26/09/2012 | |
BORME-A-2011-205-28 | Madrid | 27/10/2011 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades