Última actualización: 11 de Diciembre de 2020
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 3 años, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B63193023 |
Provincia | Barcelona |
Domicilio | Av Remolar Num.2 (Prat De Llobregat (El)). |
Capital social | 30.742.350,0 euros |
Motivo de la disolución | Judicial. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 16/09/2013 | 11/12/2020 |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 16/06/2016 | 11/12/2020 |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 16/06/2016 | 11/12/2020 |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 24/11/2010 | 11/12/2020 |
APODERADO | Parera Sole Jose Maria | 27/08/2012 | 11/12/2020 |
REP.ADM.CONC | Matas Torrellas Jorge | 12/12/2013 | 11/12/2020 |
AUDIT.CUENT. | Horwath Auditores España SLP | 01/09/2010 | 11/12/2020 |
ADM.CONCURS. | Forest Partners Estrada Y Asociados SL | 12/12/2013 | 11/12/2020 |
REP.ADM.CONC | Estrada Esteban Jose Vicente | 12/12/2013 | 11/12/2020 |
APODERADO | Romero Garcia Jose Maria | Desconocido | 02/12/2016 |
DTOR.GENERAL | Raoul Ferruz | Desconocido | 02/12/2016 |
APODERADO | Raoul Ferruz | Desconocido | 02/12/2016 |
APODERADO | Montero Lastres Maximino | 22/10/2012 | 02/12/2016 |
APODERADO | Lopez Gutierrez Alejandro | 27/02/2013 | 02/12/2016 |
APODERADO | Belles Subirats Xavier | Desconocido | 02/12/2016 |
APODERADO | Ardevol Ferrer Josep Maria | Desconocido | 02/12/2016 |
ADM.UNICO | La Seda De Barcelona SA | 01/09/2010 | 29/04/2015 |
REPR.143 RRM | Garcia Albi Gil De Biedma Jose Antonio | 24/07/2014 | 29/04/2015 |
REPR.143 RRM | Crous Millet Antonio | 05/07/2013 | 24/07/2014 |
REPR.143 RRM | Lopez Hernandez Abelardo | 27/08/2012 | 05/07/2013 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Industrias Quimicas Asociadas Lsb SL.
11
Dic 2020
Con fecha 11/12/2020 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 42411 , F 68, S 8, H B 272554, I/A 55
11
Dic 2020
JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 429/2013, AUTO FIRME DE FECHA 13/11/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO.
Datos registrales: T 42411 , F 68, S 8, H B 272554, I/A 55
11
Dic 2020
Con fecha 11/12/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REP.ADM.CONC | Matas Torrellas Jorge |
ADM.CONCURS. | Forest Partners Estrada Y Asociados SL |
REP.ADM.CONC | Estrada Esteban Jose Vicente |
Datos registrales: T 42411 , F 68, S 8, H B 272554, I/A 55
11
Oct 2017
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 429/2013, AUTO FIRME DE FECHA 05/09/2017, POR EL QUE SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE CALIFICACION DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 42411 , F 68, S 8, H B 272554, I/A 54
02
Dic 2016
Con fecha 02/12/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Romero Garcia Jose Maria |
APODERADO | Raoul Ferruz |
APODERADO | Montero Lastres Maximino |
APODERADO | Lopez Gutierrez Alejandro |
APODERADO | Belles Subirats Xavier |
APODERADO | Ardevol Ferrer Josep Maria |
Datos registrales: T 42411 , F 68, S 8, H B 272554, I/A 53
16
Jun 2016
Con fecha 16/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42411 , F 67, S 8, H B 272554, I/A 52
16
Jun 2016
Con fecha 16/06/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42411 , F 67, S 8, H B 272554, I/A 51
09
May 2016
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 429/2013, PROVIDENCIA FIRME DE FECHA 01/03/2016,CONSTANCIA DEL EJERCICIO INDISTINTO DE LAS FACULTADES DE LAS PERSONAS FISICAS REPRESENTANTES DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL.
Datos registrales: T 42411 , F 67, S 8, H B 272554, I/A 50
29
Abr 2015
Con fecha 29/04/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Judicial.
Datos registrales: T 42411 , F 65, S 8, H B 272554, I/A 49
29
Abr 2015
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 429/2013, RESOLUCIONES FIRMES, DE 13/10/2014: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y DE 16/02/2015:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION.
Datos registrales: T 42411 , F 65, S 8, H B 272554, I/A 49
29
Abr 2015
Con fecha 29/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.UNICO | La Seda De Barcelona SA |
REPR.143 RRM | Garcia Albi Gil De Biedma Jose Antonio |
Datos registrales: T 42411 , F 65, S 8, H B 272554, I/A 49
24
Jul 2014
Con fecha 24/07/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Garcia Albi Gil De Biedma Jose Antonio |
Datos registrales: T 42411 , F 65, S 8, H B 272554, I/A 48
24
Jul 2014
Con fecha 24/07/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Crous Millet Antonio |
Datos registrales: T 42411 , F 65, S 8, H B 272554, I/A 48
12
Dic 2013
JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ORDINARIO DE CONCURSO VOLUNTARIO 429/2013, AUTO FIRME DE FECHA 04/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DECLARADO CONJUNTAMENTE CON OTRAS SOCIEDADES.
Datos registrales: T 42411 , F 64, S 8, H B 272554, I/A 47
12
Dic 2013
Con fecha 12/12/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REP.ADM.CONC | Matas Torrellas Jorge |
ADM.CONCURS. | Forest Partners Estrada Y Asociados SL |
REP.ADM.CONC | Estrada Esteban Jose Vicente |
Datos registrales: T 42411 , F 64, S 8, H B 272554, I/A 47
16
Sep 2013
Con fecha 16/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42411 , F 64, S 8, H B 272554, I/A 46
05
Jul 2013
Con fecha 05/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Crous Millet Antonio |
Datos registrales: T 42411 , F 63, S 8, H B 272554, I/A 45
05
Jul 2013
Con fecha 05/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Lopez Hernandez Abelardo |
Datos registrales: T 42411 , F 63, S 8, H B 272554, I/A 45
27
Feb 2013
Con fecha 27/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Lopez Gutierrez Alejandro |
Datos registrales: T 42411 , F 63, S 8, H B 272554, I/A 44
16
Nov 2012
Con fecha 16/11/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Callejo Mascarell Judith |
Datos registrales: T 42411 , F 63, S 8, H B 272554, I/A 43
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2020-242-08 | Barcelona | 18/12/2020 | |
BORME-A-2017-200-08 | Barcelona | 19/10/2017 | |
BORME-A-2016-236-08 | Barcelona | 14/12/2016 | |
BORME-A-2016-120-08 | Barcelona | 24/06/2016 | |
BORME-A-2016-93-08 | Barcelona | 18/05/2016 | |
BORME-A-2015-85-08 | Barcelona | 07/05/2015 | |
BORME-A-2014-143-08 | Barcelona | 30/07/2014 | |
BORME-A-2013-242-08 | Barcelona | 19/12/2013 | |
BORME-A-2013-181-08 | Barcelona | 23/09/2013 | |
BORME-A-2013-131-08 | Barcelona | 12/07/2013 | |
BORME-A-2013-45-08 | Barcelona | 06/03/2013 | |
BORME-A-2012-228-08 | Barcelona | 28/11/2012 | |
BORME-A-2012-211-08 | Barcelona | 02/11/2012 | |
BORME-A-2012-171-08 | Barcelona | 06/09/2012 | |
BORME-A-2012-77-08 | Barcelona | 23/04/2012 | |
BORME-A-2011-33-08 | Barcelona | 17/02/2011 | |
BORME-A-2010-242-08 | Barcelona | 21/12/2010 | |
BORME-A-2010-233-08 | Barcelona | 07/12/2010 | |
BORME-A-2010-189-08 | Barcelona | 30/09/2010 | |
BORME-A-2010-184-08 | Barcelona | 23/09/2010 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades