Última actualización: 15 de Noviembre de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 1 año, 3 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad de Inversión de Capital Variable |
NIF | A83074039 |
Provincia | Madrid |
Domicilio | Paseo De La Castellana 51 (Madrid). |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Liquidador | Rocafort Sanchez Gonzalo | Desconocido | 16/01/2023 |
VsecrNoConsj | Laguens Marsal Carlos | 19/06/2018 | 16/01/2023 |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 05/01/2010 | 16/01/2023 |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 21/01/2009 | 16/01/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 19/06/2018 | 16/01/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 12/08/2021 | 16/01/2023 |
Auditor | Deloitte SL | 10/10/2012 | 16/01/2023 |
Presidente | De Olives Pons Antonio | 21/08/2014 | 16/01/2023 |
Presidente | De Olives Pons Antonio | 19/01/2009 | 16/01/2023 |
Consejero | De Olives Pons Antonio | 21/08/2014 | 16/01/2023 |
Consejero | De Olives Pons Antonio | 29/09/2020 | 16/01/2023 |
Con.Delegado | De Olives Pons Antonio | 19/01/2009 | 16/01/2023 |
Secretario | De Olives Levy Guillermo | 16/10/2015 | 16/01/2023 |
Secretario | De Olives Levy Guillermo | 29/09/2020 | 16/01/2023 |
Consejero | De Olives Levy Guillermo | 21/08/2014 | 16/01/2023 |
Consejero | De Olives Levy Guillermo | 19/01/2009 | 16/01/2023 |
Consejero | De Olives Levy Antonio | 29/09/2020 | 16/01/2023 |
Consejero | De Olives Levy Antonio | 19/01/2009 | 16/01/2023 |
EntidDeposit | Cecabank SA | 19/06/2018 | 16/01/2023 |
Apoderado | Caixabank Asset Management Sgiic SA | 19/06/2018 | 16/01/2023 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Ifol SICAV.
15
Nov 2023
ACTIVOS SOBREVENIDOS.
Datos registrales: T 34037 , F 32, S 8, H M 284316, I/A 32
16
Ene 2023
Con fecha 16/01/2023 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 34037 , F 26, S 8, H M 284316, I/A 31
16
Ene 2023
Con fecha 16/01/2023 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 34037 , F 26, S 8, H M 284316, I/A 31
16
Ene 2023
Cesada la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores" (IBERCLEAR) como entidad encargada del registro contable.
Datos registrales: T 34037 , F 26, S 8, H M 284316, I/A 31
16
Ene 2023
Con fecha 16/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Rocafort Sanchez Gonzalo |
Datos registrales: T 34037 , F 26, S 8, H M 284316, I/A 31
16
Ene 2023
Con fecha 16/01/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Liquidador | Rocafort Sanchez Gonzalo |
VsecrNoConsj | Laguens Marsal Carlos |
Auditor | Deloitte SL |
Consejero | De Olives Pons Antonio |
Consejero | De Olives Levy Guillermo |
Consejero | De Olives Levy Antonio |
EntidDeposit | Cecabank SA |
Ent. Gestora | Caixabank Asset Management Sgiic SA |
Datos registrales: T 34037 , F 26, S 8, H M 284316, I/A 31
12
Ago 2021
Con fecha 12/08/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 34037 , F 25, S 8, H M 284316, I/A 30
29
Sep 2020
Con fecha 29/09/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | De Olives Pons Antonio |
Secretario | De Olives Levy Guillermo |
Consejero | De Olives Levy Antonio |
Datos registrales: T 34037 , F 25, S 8, H M 284316, I/A 29
19
Jun 2018
Con fecha 19/06/2018, la sociedad cambia su domicilio social a PASEO DE LA CASTELLANA 51 (MADRID).
Datos registrales: T 34037 , F 24, S 8, H M 284316, I/A 28
19
Jun 2018
Con fecha 19/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 34037 , F 24, S 8, H M 284316, I/A 28
19
Jun 2018
Con fecha 19/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Laguens Marsal Carlos |
EntidDeposit | Cecabank SA |
Apoderado | Caixabank Asset Management Sgiic SA |
Datos registrales: T 34037 , F 24, S 8, H M 284316, I/A 28
19
Jun 2018
Con fecha 19/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Deutsche Asset Management S.G.I.I.C. SA |
Datos registrales: T 34037 , F 24, S 8, H M 284316, I/A 28
19
Jun 2018
Con fecha 19/06/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Diaz Chimeno Pedro Pablo |
EntidDeposit | Deutsche Bank Sae |
Ent. Gestora | Deutsche Asset Management S.G.I.I.C. SA |
Datos registrales: T 34037 , F 24, S 8, H M 284316, I/A 28
18
Nov 2015
Con fecha 18/11/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 34037 , F 24, S 8, H M 284316, I/A 27
06
Nov 2015
Con fecha 06/11/2015, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Modificación del Artículo 13º de los Estatutos Sociales.
Datos registrales: T 24666 , F 95, S 8, H M 284316, I/A 26
16
Oct 2015
Se publicó por error en la Inscripción 25& el nombramiento de GUILLERMO DE OLIVES LEVY como Secretario no Consejero, siendo lo correcto Consejero.
Datos registrales: T 24666 , F 95, S 8, H M 284316, I/A 25
16
Oct 2015
Con fecha 16/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | De Olives Levy Guillermo |
Datos registrales: T 24666 , F 95, S 8, H M 284316, I/A 25
16
Oct 2015
Con fecha 16/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Diaz Chimeno Pedro Pablo |
SecreNoConsj | De Olives Levy Guillermo |
Datos registrales: T 24666 , F 95, S 8, H M 284316, I/A 25
16
Oct 2015
Con fecha 16/10/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Diaz Chimeno Pedro Pablo |
Datos registrales: T 24666 , F 95, S 8, H M 284316, I/A 25
21
Ago 2014
Con fecha 21/08/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | De Olives Pons Antonio |
Datos registrales: T 24666 , F 95, S 8, H M 284316, I/A 24
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2023-222-28 | Madrid | 22/11/2023 |
BORME-A-2023-15-28 | Madrid | 23/01/2023 |
BORME-A-2021-159-28 | Madrid | 19/08/2021 |
BORME-A-2020-194-28 | Madrid | 06/10/2020 |
BORME-A-2018-125-28 | Madrid | 02/07/2018 |
BORME-A-2015-226-28 | Madrid | 26/11/2015 |
BORME-A-2015-220-28 | Madrid | 18/11/2015 |
BORME-A-2015-218-28 | Madrid | 16/11/2015 |
BORME-A-2015-204-28 | Madrid | 26/10/2015 |
BORME-A-2014-168-28 | Madrid | 04/09/2014 |
BORME-A-2012-204-28 | Madrid | 23/10/2012 |
BORME-A-2012-202-28 | Madrid | 19/10/2012 |
BORME-A-2011-191-28 | Madrid | 06/10/2011 |
BORME-A-2010-99-28 | Madrid | 26/05/2010 |
BORME-A-2010-11-28 | Madrid | 19/01/2010 |
BORME-A-2010-9-28 | Madrid | 15/01/2010 |
BORME-A-2009-20-28 | Madrid | 30/01/2009 |
BORME-A-2009-19-28 | Madrid | 29/01/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades