Última actualización: 13 de Febrero de 2012
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 12 años, 2 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A08373961 |
Provincia | Barcelona |
Motivo de la disolución | Voluntaria. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRE.COMS.LIQ | Madrid Abril Sonia | 01/08/2011 | 13/02/2012 |
MRO.COMS.LIQ | Madrid Abril Sonia | 01/08/2011 | 13/02/2012 |
APODERADO | Madrid Abril Sonia | 07/01/2009 | 13/02/2012 |
MRO.COMS.LIQ | Lopez Rodriguez Ricard | 01/08/2011 | 13/02/2012 |
APODERADO | Galan Saubi Jaume | 07/01/2009 | 13/02/2012 |
APODERADO | Ferreira Amaro Jose Luis | 07/01/2009 | 13/02/2012 |
APODERADO | Erwin Jorge Zwicky | 07/01/2009 | 13/02/2012 |
SEC.COMS.LIQ | Cruells Piñol Jordi | 01/08/2011 | 13/02/2012 |
MRO.COMS.LIQ | Cruells Piñol Jordi | 01/08/2011 | 13/02/2012 |
APODERADO | Cruells Piñol Jordi | 07/01/2009 | 13/02/2012 |
APODERADO | Christoph Stein | 07/01/2009 | 13/02/2012 |
APODERADO | Montaner Ribes Jose Antonio | Desconocido | 19/08/2011 |
CONSEJERO | Sociedad Española De Carburos Metalicos SA | Desconocido | 01/08/2011 |
CONSEJERO | Madrid Abril Sonia | 07/01/2009 | 01/08/2011 |
REPR.143 RRM | Ferreira Amaro Jose Luis | Desconocido | 01/08/2011 |
SECRETARIO | Cruells Piñol Jordi | 10/12/2010 | 01/08/2011 |
CONSEJERO | Cruells Piñol Jordi | 10/12/2010 | 01/08/2011 |
PRESIDENTE | Christoph Stein | 07/01/2009 | 01/08/2011 |
CONSEJERO | Christoph Stein | 07/01/2009 | 01/08/2011 |
CONSEJERO | Erwin Jorge Zwicky | 07/01/2009 | 10/12/2010 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Iberica De Gases SA.
13
Feb 2012
Con fecha 13/02/2012 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 38297 , F 86, S 8, H B 89517, I/A 70
19
Ago 2011
Con fecha 19/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Montaner Ribes Jose Antonio |
Datos registrales: T 38297 , F 86, S 8, H B 89517, I/A 69
01
Ago 2011
Con fecha 01/08/2011 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Voluntaria.
Datos registrales: T 38297 , F 85, S 8, H B 89517, I/A 68
01
Ago 2011
Con fecha 01/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
MRO.COMS.LIQ | Madrid Abril Sonia |
MRO.COMS.LIQ | Lopez Rodriguez Ricard |
MRO.COMS.LIQ | Cruells Piñol Jordi |
Datos registrales: T 38297 , F 85, S 8, H B 89517, I/A 68
01
Ago 2011
Con fecha 01/08/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Sociedad Española De Carburos Metalicos SA |
CONSEJERO | Madrid Abril Sonia |
REPR.143 RRM | Ferreira Amaro Jose Luis |
CONSEJERO | Cruells Piñol Jordi |
CONSEJERO | Christoph Stein |
Datos registrales: T 38297 , F 85, S 8, H B 89517, I/A 68
10
Dic 2010
Con fecha 10/12/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Cruells Piñol Jordi |
Datos registrales: T 38297 , F 85, S 8, H B 89517, I/A 67
10
Dic 2010
Con fecha 10/12/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECRETARIO | Erwin Jorge Zwicky |
Datos registrales: T 38297 , F 85, S 8, H B 89517, I/A 67
07
Ene 2009
Con fecha 07/01/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Madrid Abril Sonia |
APODERADO | Galan Saubi Jaume |
APODERADO | Ferreira Amaro Jose Luis |
APODERADO | Erwin Jorge Zwicky |
APODERADO | Cruells Piñol Jordi |
APODERADO | Christoph Stein |
Datos registrales: T 38297 , F 84, S 8, H B 89517, I/A 66
07
Ene 2009
Con fecha 07/01/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Perez Herce Garcia Carlos Antonio |
APODERADO | Mozo Gayo Jose Luis |
APODERADO | Masana Adam Joaquim |
APODERADO | Gandia Rovirosa Juan |
APODERADO | Erwin Jorge Zwicky |
APODERADO | Cruells Piñol Jordi |
Datos registrales: T 38297 , F 84, S 8, H B 89517, I/A 65
07
Ene 2009
Con fecha 07/01/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Madrid Abril Sonia |
CONSEJERO | Erwin Jorge Zwicky |
PRESIDENTE | Christoph Stein |
Datos registrales: T 38297 , F 83, S 8, H B 89517, I/A 64
07
Ene 2009
Con fecha 07/01/2009 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Masana Adam Joaquim |
CONSEJERO | Gandia Rovirosa Juan |
Datos registrales: T 38297 , F 83, S 8, H B 89517, I/A 64
CVE | Provincia | Fecha |
---|---|---|
BORME-A-2012-38-08 | Barcelona | 23/02/2012 |
BORME-A-2011-166-08 | Barcelona | 31/08/2011 |
BORME-A-2011-153-08 | Barcelona | 11/08/2011 |
BORME-A-2010-242-08 | Barcelona | 21/12/2010 |
BORME-A-2009-10-08 | Barcelona | 16/01/2009 |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades