Última actualización: 8 de Marzo de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 6 años |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A60537750 |
Provincia | Barcelona |
Capital social | 6.407.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.CUENT. | Vir Audit SLP | 29/05/2014 | 08/03/2018 |
APODERAD.SOL | Torrente Rodriguez Francisco Miguel | 27/10/2017 | 08/03/2018 |
AUDIT.CUENT. | Rsm Spain Auditores SLP | 11/10/2016 | 08/03/2018 |
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier | 31/05/2016 | 08/03/2018 |
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan | 18/05/2016 | 08/03/2018 |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL | 18/05/2016 | 08/03/2018 |
APOD.MANCOMU | Griño Tomas Miguel Jose | 30/03/2016 | 29/11/2016 |
APOD.MANCOMU | Gallego Rubio Jorge | 30/03/2016 | 29/11/2016 |
AUDIT.CUENT. | Vir Audit SLP | 20/12/2011 | 11/10/2016 |
REPR.143 RRM | Solesio Lopez Bosch Pablo | 01/03/2013 | 18/05/2016 |
ADM.SOLIDAR. | Hera Holding Habitat Ecologia Y Restauracion Ambie | 01/03/2013 | 18/05/2016 |
ADM.SOLIDAR. | Gallego Rubio Jorge | 01/03/2013 | 18/05/2016 |
APODERADO | Torrente Rodriguez Francisco Miguel | 30/03/2011 | 09/02/2016 |
APODERADO | Solesio Lopez-Bosch Pablo Jose | Desconocido | 09/02/2016 |
APODERADO | Latorre Guasch Maria Victoria | 07/01/2010 | 09/02/2016 |
APODERADO | Griño Tomas Miguel Jose | 18/02/2011 | 09/02/2016 |
APODERADO | Gallego Rubio Jorge | Desconocido | 09/02/2016 |
APODERADO | Fabrice Hermance | 07/02/2013 | 09/02/2016 |
APODERADO | Capella Lopez Oscar | 18/02/2011 | 09/02/2016 |
APODERADO | Abellan Marichalar Enrique | Desconocido | 09/02/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Hera Amasa SA.
08
Mar 2018
Con fecha 08/03/2018 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 43943 , F 159, S 8, H B 112434, I/A 74
08
Mar 2018
Con fecha 08/03/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Torrente Rodriguez Francisco Miguel |
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier |
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL |
Datos registrales: T 43943 , F 159, S 8, H B 112434, I/A 74
27
Oct 2017
Con fecha 27/10/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Torrente Rodriguez Francisco Miguel |
Datos registrales: T 42083 , F 170, S 8, H B 112434, I/A 73
29
Nov 2016
Con fecha 29/11/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Griño Tomas Miguel Jose |
APOD.MANCOMU | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 42083 , F 170, S 8, H B 112434, I/A 72
11
Oct 2016
Con fecha 11/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Rsm Spain Auditores SLP |
Datos registrales: T 42083 , F 169, S 8, H B 112434, I/A 71
11
Oct 2016
Con fecha 11/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Vir Audit SLP |
Datos registrales: T 42083 , F 169, S 8, H B 112434, I/A 71
31
May 2016
Con fecha 31/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Perez Fernandez Fernando Javier |
Datos registrales: T 42083 , F 168, S 8, H B 112434, I/A 70
18
May 2016
Con fecha 18/05/2016, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 11,13,23 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ESTRUCTURA DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL.
Datos registrales: T 42083 , F 167, S 8, H B 112434, I/A 69
18
May 2016
Con fecha 18/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Griño Piro Joan |
ADM.UNICO | Corporacio Griño SL |
Datos registrales: T 42083 , F 167, S 8, H B 112434, I/A 69
18
May 2016
Con fecha 18/05/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Solesio Lopez Bosch Pablo |
ADM.SOLIDAR. | Hera Holding Habitat Ecologia Y Restauracion Ambie |
ADM.SOLIDAR. | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 42083 , F 167, S 8, H B 112434, I/A 69
30
Mar 2016
Con fecha 30/03/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Griño Tomas Miguel Jose |
APOD.MANCOMU | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 42083 , F 165, S 8, H B 112434, I/A 68
09
Feb 2016
Con fecha 09/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Torrente Rodriguez Francisco Miguel |
APODERADO | Solesio Lopez-Bosch Pablo Jose |
APODERADO | Latorre Guasch Maria Victoria |
APODERADO | Lacoma Fernandez Francisco Javier |
APODERADO | Guillermo Alejandro Ramon D'Alessio Dellepiane |
APODERADO | Griño Tomas Miguel Jose |
APODERADO | Gallego Rubio Jorge |
APODERADO | Fabrice Hermance |
APODERADO | Capella Lopez Oscar |
APODERADO | Abellan Marichalar Enrique |
Datos registrales: T 42083 , F 164, S 8, H B 112434, I/A 67
09
Feb 2015
Con fecha 09/02/2015, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 4.023.000,0 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 62.79% de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 6.407.000,0€.
Datos registrales: T 42083 , F 164, S 8, H B 112434, I/A 66
03
Nov 2014
Con fecha 03/11/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Sanz Gonzalez Miguel Angel |
Datos registrales: T 42083 , F 164, S 8, H B 112434, I/A 65
29
May 2014
Con fecha 29/05/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Vir Audit SLP |
Datos registrales: T 42083 , F 163, S 8, H B 112434, I/A 64
14
Mar 2014
Con fecha 14/03/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Martinez Ferreira Rafael |
Datos registrales: T 42083 , F 163, S 8, H B 112434, I/A 63
15
May 2013
Con fecha 15/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Sanz Gonzalez Miguel Angel |
APODERADO | Plans Bartoli Joan |
APODERADO | Martinez Ferreira Rafael |
APODERADO | Fabrice Hermance |
Datos registrales: T 42083 , F 163, S 8, H B 112434, I/A 62
01
Mar 2013
Con fecha 01/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Solesio Lopez Bosch Pablo |
ADM.SOLIDAR. | Hera Holding Habitat Ecologia Y Restauracion Ambie |
ADM.SOLIDAR. | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 42083 , F 163, S 8, H B 112434, I/A 61
01
Mar 2013
Con fecha 01/03/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
REPR.143 RRM | Solesio Lopez Bosch Pablo |
ADM.SOLIDAR. | Solal SL |
ADM.SOLIDAR. | Hera Holding Habitat Ecologia Y Restauracion Ambie |
REPR.143 RRM | Gallego Rubio Jorge |
Datos registrales: T 42083 , F 163, S 8, H B 112434, I/A 61
07
Feb 2013
Con fecha 07/02/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Solal SL |
APODERADO | Fornieles Contreras Juan Antonio |
Datos registrales: T 42083 , F 162, S 8, H B 112434, I/A 60
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2018-54-08 | Barcelona | 16/03/2018 | |
BORME-A-2017-212-08 | Barcelona | 07/11/2017 | |
BORME-A-2016-232-08 | Barcelona | 07/12/2016 | |
BORME-A-2016-201-08 | Barcelona | 20/10/2016 | |
BORME-A-2016-108-08 | Barcelona | 08/06/2016 | |
BORME-A-2016-101-08 | Barcelona | 30/05/2016 | |
BORME-A-2016-98-08 | Barcelona | 25/05/2016 | |
BORME-A-2016-65-08 | Barcelona | 06/04/2016 | |
BORME-A-2016-31-08 | Barcelona | 16/02/2016 | |
BORME-A-2015-32-08 | Barcelona | 17/02/2015 | |
BORME-A-2014-216-08 | Barcelona | 12/11/2014 | |
BORME-A-2014-106-08 | Barcelona | 06/06/2014 | |
BORME-A-2014-56-08 | Barcelona | 21/03/2014 | |
BORME-A-2013-95-08 | Barcelona | 23/05/2013 | |
BORME-A-2013-47-08 | Barcelona | 08/03/2013 | |
BORME-A-2013-33-08 | Barcelona | 18/02/2013 | |
BORME-A-2013-32-08 | Barcelona | 15/02/2013 | |
BORME-A-2013-25-08 | Barcelona | 06/02/2013 | |
BORME-A-2012-125-38 | Santa Cruz De Tenerife | 03/07/2012 | |
BORME-A-2012-1-08 | Barcelona | 02/01/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades