Última actualización: 17 de Diciembre de 2014
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 9 años, 4 meses |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A81250243 |
Provincia | Madrid |
Motivo de la disolución | Fusion. |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Presidente | Wohlthat Jens | 04/06/2012 | 17/12/2014 |
Presidente | Wohlthat Jens | 24/03/2009 | 17/12/2014 |
Consejero | Wohlthat Jens | 04/06/2012 | 17/12/2014 |
Apoderado | Til Puyol Carlos | 10/12/2012 | 17/12/2014 |
Apo.Manc. | Sagi Vela Grande Jose Maria | 21/10/2009 | 17/12/2014 |
Apoderado | Ruiz Pastor Joaquin | 05/04/2013 | 17/12/2014 |
Apo.Manc. | Rodriguez Pioss Beatriz | 21/10/2009 | 17/12/2014 |
Apo.Sol. | Revenga Santurde Roberto-Javier | 05/06/2013 | 17/12/2014 |
Consejero | Martin Gil Santiago | 01/06/2010 | 17/12/2014 |
Consejero | Martin Gil Santiago | 13/05/2013 | 17/12/2014 |
Con.Delegado | Martin Gil Santiago | 13/05/2013 | 17/12/2014 |
Con.Delegado | Martin Gil Santiago | 05/06/2012 | 17/12/2014 |
Con.Delegado | Martin Gil Santiago | 02/06/2010 | 17/12/2014 |
Secretario | Maestro Martinez Jose Luis | 08/06/2011 | 17/12/2014 |
Secretario | Maestro Martinez Jose Luis | 13/05/2013 | 17/12/2014 |
Consejero | Maestro Martinez Jose Luis | 13/05/2013 | 17/12/2014 |
Consejero | Maestro Martinez Jose Luis | 01/06/2010 | 17/12/2014 |
Apo.Manc. | Lopez-Pelegrin Fernandez De Velasco Felix | 21/10/2009 | 17/12/2014 |
Auditor | Kpmg Auditores SL | 10/06/2011 | 17/12/2014 |
Apo.Manc. | Comas Regalado Cristina | 21/10/2009 | 17/12/2014 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Hdi Hannover International (España) Seguros Y Reaseguros SA.
17
Dic 2014
Con fecha 17/12/2014 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 27613 , F 26, S 8, H M 158031, I/A 79
17
Dic 2014
Con fecha 17/12/2014 se inscribe en el Registro Mercantil la disolución de la sociedad. Motivo de la disolución: Fusion.
Datos registrales: T 27613 , F 26, S 8, H M 158031, I/A 79
26
Ago 2014
CON FECHA 26 DE AGOSTO DE 2014, SE HA EXPEDIDO CERTIFICACION ACREDITATIVA DE QUE SE HAN REALIZADO CORRECTAMENTE TODOS LOS ACTOS Y TRAMITES PREVIOS A LA FUSION DE LA SOCIEDAD "HDI HANNOVER INTERNATIONAL (ESPAÑA) SEGUROS Y REASEGUROS SA" POR LA ALEMANA "HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG".
Datos registrales: T 27613 , F 25, S 8, H M 158031, I/A 78
05
Jun 2013
Con fecha 05/06/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Sol. | Revenga Santurde Roberto-Javier |
Datos registrales: T 27613 , F 25, S 8, H M 158031, I/A 77
13
May 2013
Con fecha 13/05/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Martin Gil Santiago |
Secretario | Maestro Martinez Jose Luis |
Datos registrales: T 27613 , F 24, S 8, H M 158031, I/A 76
05
Abr 2013
Con fecha 05/04/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Ruiz Pastor Joaquin |
Datos registrales: T 27613 , F 24, S 8, H M 158031, I/A 75
10
Dic 2012
Con fecha 10/12/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Til Puyol Carlos |
Apoderado | Lopez Pelgrin Fernandez Felix |
Datos registrales: T 27613 , F 24, S 8, H M 158031, I/A 74
06
Jun 2012
Con fecha 06/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Sigulla Stefan Adalbert |
Datos registrales: T 27613 , F 23, S 8, H M 158031, I/A 73
05
Jun 2012
Con fecha 05/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Martin Gil Santiago |
Datos registrales: T 27613 , F 23, S 8, H M 158031, I/A 72
05
Jun 2012
Con fecha 05/06/2012, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
inclusion del articulo 14 bis..
Datos registrales: T 27613 , F 23, S 8, H M 158031, I/A 71
04
Jun 2012
Con fecha 04/06/2012 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Wohlthat Jens |
Datos registrales: T 27613 , F 22, S 8, H M 158031, I/A 70
10
Jun 2011
Con fecha 10/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes reelecciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 27613 , F 22, S 8, H M 158031, I/A 69
08
Jun 2011
SE RATIFICA EL NOMBRAMIENTO DE D. JOSE LUIS MAESTRO MARTINEZ, COMO CONSEJERO INDEPENDIENTE DE LA SOCIEDAD.
Datos registrales: T 27613 , F 22, S 8, H M 158031, I/A 68
08
Jun 2011
Con fecha 08/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Maestro Martinez Jose Luis |
Datos registrales: T 27613 , F 22, S 8, H M 158031, I/A 68
08
Jun 2011
Con fecha 08/06/2011 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Secretario | Winkels Eduard |
Datos registrales: T 27613 , F 22, S 8, H M 158031, I/A 68
31
Dic 2010
Con fecha 31/12/2010 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG.
Datos registrales: T 27613 , F 21, S 8, H M 158031, I/A 67
23
Nov 2010
Con fecha 23/11/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Fenollar Rodriguez Gabriel |
Datos registrales: T 27613 , F 21, S 8, H M 158031, I/A 66
23
Nov 2010
Con fecha 23/11/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Peruga Puyuelo Antonio |
Apoderado | Barrasa Iglesias Francisco |
Datos registrales: T 27613 , F 21, S 8, H M 158031, I/A 65
05
Nov 2010
Con fecha 05/11/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Ruiz Benito Estrella |
Datos registrales: T 27613 , F 21, S 8, H M 158031, I/A 64
05
Nov 2010
Con fecha 05/11/2010 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Rios Carreras Jorge |
Datos registrales: T 27613 , F 21, S 8, H M 158031, I/A 63
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2014-245-28 | Madrid | 24/12/2014 | |
BORME-A-2014-167-28 | Madrid | 03/09/2014 | |
BORME-A-2013-111-28 | Madrid | 14/06/2013 | |
BORME-A-2013-94-28 | Madrid | 22/05/2013 | |
BORME-A-2013-70-28 | Madrid | 15/04/2013 | |
BORME-A-2012-241-28 | Madrid | 18/12/2012 | |
BORME-A-2012-114-28 | Madrid | 18/06/2012 | |
BORME-A-2012-113-28 | Madrid | 15/06/2012 | |
BORME-A-2012-112-28 | Madrid | 14/06/2012 | |
BORME-A-2011-118-28 | Madrid | 21/06/2011 | |
BORME-A-2011-117-28 | Madrid | 20/06/2011 | |
BORME-A-2011-8-28 | Madrid | 13/01/2011 | |
BORME-A-2010-233-28 | Madrid | 07/12/2010 | |
BORME-A-2010-220-28 | Madrid | 17/11/2010 | |
BORME-A-2010-113-28 | Madrid | 16/06/2010 | |
BORME-A-2010-110-28 | Madrid | 11/06/2010 | |
BORME-A-2010-90-28 | Madrid | 13/05/2010 | |
BORME-A-2010-88-28 | Madrid | 11/05/2010 | |
BORME-A-2009-209-28 | Madrid | 02/11/2009 | |
BORME-A-2009-129-28 | Madrid | 10/07/2009 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades