Última actualización: 8 de Marzo de 2016
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Extinguida desde hace 8 años, 1 mes |
---|---|
Forma jurídica | Agrupación de Interés Económico |
NIF | V86622487 |
Provincia | Barcelona |
Fecha de constitución | 16 de Enero de 2013 (hace 11 años, 3 meses) |
Domicilio | Cl Alcalde Barnils Num.63 (Sant Cugat Del Valles). |
Objeto social | Prestacion de servicios de contact center que encuadra todas aquellas actividades que tengan como objetivo contactar con o ser contactados por terceros ya fuera por via telefonica, .......... |
Capital social | 100.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Presidente | Vila Tortosa Jose | 13/03/2015 | 08/03/2016 |
Consejero | Vila Tortosa Jose | 13/03/2015 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Talavera Casado Manuel Cruz | 06/02/2013 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Ruiz Haya Roberto | 07/02/2013 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Rodriguez Ramos Lidia | 08/02/2013 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Perez Moreno Isaias Rafael | 08/02/2013 | 08/03/2016 |
Apoderado | Ocaña Ayuso Gerardo | 17/04/2015 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Ocaña Ayuso Gerardo | 12/02/2013 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Lorenzo Alguacil Andres | 06/02/2013 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Garrote Carrasco Pablo | 11/02/2013 | 08/03/2016 |
Vicepresid. | Garcia Vegas Pablo | 04/02/2015 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Garcia Vegas Pablo | 07/02/2013 | 08/03/2016 |
Consejero | Esclusa Rof Jose | 03/09/2014 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Esclusa Rof Jose | 12/02/2013 | 08/03/2016 |
Auditor | Deloitte SL | 04/07/2013 | 08/03/2016 |
Apoderado | De Santiago Gomez David | 06/03/2015 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | De Santiago Gomez David | 12/02/2013 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | De Los Reyes Leoz Francisco Javier | 06/02/2013 | 08/03/2016 |
SecreNoConsj | David De Santiago Gomez | 25/01/2013 | 08/03/2016 |
Apo.Man.Soli | Burgos Sordo Arturo Jesus | 08/02/2013 | 08/03/2016 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Grupo Plus Ultra Contact Center AIE.
08
Mar 2016
Con fecha 08/03/2016 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.
Datos registrales: T 44872 , F 222, S 8, H B 469997, I/A 36
08
Mar 2016
TRANSMISION DE PARTICIPACIONES DE LA AGRUPACION Y CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS MISMAS.
Datos registrales: T 44872 , F 222, S 8, H B 469997, I/A 36
29
Oct 2015
TRANSMISIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS MISMAS.
Datos registrales: T 44872 , F 221, S 8, H B 469997, I/A 35
15
Jun 2015
Con fecha 15/06/2015, la sociedad cambia su domicilio social a CL ALCALDE BARNILS Num.63 (SANT CUGAT DEL VALLES).
Datos registrales: T 44872 , F 221, S 8, H B 469997, I/A 34
11
May 2015
Con fecha 11/05/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Serrat Mesegar Francisco Antonio |
Datos registrales: T 30743 , F 19, S 8, H M 550579, I/A 33
17
Abr 2015
Con fecha 17/04/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Ocaña Ayuso Gerardo |
Datos registrales: T 30743 , F 19, S 8, H M 550579, I/A 32
13
Mar 2015
Con fecha 13/03/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Presidente | Vila Tortosa Jose |
Datos registrales: T 30743 , F 18, S 8, H M 550579, I/A 31
13
Mar 2015
Con fecha 13/03/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Hillaire Florent Louis Jean |
Datos registrales: T 30743 , F 18, S 8, H M 550579, I/A 31
06
Mar 2015
Con fecha 06/03/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | De Santiago Gomez David |
Datos registrales: T 30743 , F 18, S 8, H M 550579, I/A 30
06
Feb 2015
Los socios "SEGUROS BILBAO FONDOS S.A." y "DEPSA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS", han perdido la condición de socios de la agrupación por transmisión de sus participaciones a favor del socio "SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS". La sociedad "CLICKSEGUROS, SEGUROS Y REASEGUROS S.A." ha perdido el caracter de socio al haber sido absorbida por "PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.
Datos registrales: T 30743 , F 17, S 8, H M 550579, I/A 29
04
Feb 2015
Con fecha 04/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Con.Delegado | Garcia Vegas Pablo |
Datos registrales: T 30743 , F 17, S 8, H M 550579, I/A 28
04
Feb 2015
Con fecha 04/02/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Vicepresid. | Alvaro Jimenez Jacinto |
Datos registrales: T 30743 , F 17, S 8, H M 550579, I/A 28
05
Nov 2014
Con fecha 05/11/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Garcia Barcenas Angela |
Datos registrales: T 30743 , F 17, S 8, H M 550579, I/A 27
10
Oct 2014
Con fecha 10/10/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Man.Soli | Navarron Alarcon Pedro |
Apo.Man.Soli | Escudero Sanz Jose Luis |
Datos registrales: T 30743 , F 16, S 8, H M 550579, I/A 26
03
Sep 2014
Con fecha 03/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Esclusa Rof Jose |
Datos registrales: T 30743 , F 16, S 8, H M 550579, I/A 25
03
Sep 2014
Con fecha 03/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Navarron Alarcon Pedro |
Consejero | Burgos Sordo Arturo |
Datos registrales: T 30743 , F 16, S 8, H M 550579, I/A 25
21
Feb 2014
Con fecha 21/02/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Serrat Mesegar Francisco Antonio |
Datos registrales: T 30743 , F 16, S 8, H M 550579, I/A 24
10
Dic 2013
ADMITIDOS COMO NUEVOS SOCIOS DE LA AGRUPACION, LAS ENTIDADES: "SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS", "BILBAO, COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS", "NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.", "DEPSA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS", "COSALUD S.A., DE SEGUROS". ADMITIDOS COMO NUEVOS SOCIOS DE LA AGRUPACION, LAS ENTIDADES: "BILBAO HIPOTECARIA S.A., ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO", "SEGUROS BILBAO FONDOS, S.A., SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA", "BILBAO VIDA Y GESTORES FINANCIEROS, S.A.". SOCIOS DE LA AGRUPACION, LAS ENTIDADES: "S. ORBITA SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS S.A.", "CATALANA OCCIDENTE CAPITAL AGENCIA DE VALORES, S.A., (SOCIEDAD UNIPERSONAL)", "CATOC VIDA S.A. DE SEGUROS" Y "TECNISEGUROS SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS S.A.".
Datos registrales: T 30743 , F 14, S 8, H M 550579, I/A 23
16
Sep 2013
Con fecha 16/09/2013, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
SE HA MODIFICADO EL APARTADO 1 DEL ARTICULO 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. .
Datos registrales: T 30743 , F 13, S 8, H M 550579, I/A 22
04
Jul 2013
Con fecha 04/07/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Deloitte SL |
Datos registrales: T 30743 , F 13, S 8, H M 550579, I/A 21
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2016-50-08 | Barcelona | 14/03/2016 | |
BORME-A-2015-214-08 | Barcelona | 10/11/2015 | |
BORME-A-2015-119-08 | Barcelona | 26/06/2015 | |
BORME-A-2015-93-28 | Madrid | 20/05/2015 | |
BORME-A-2015-80-28 | Madrid | 29/04/2015 | |
BORME-A-2015-55-28 | Madrid | 23/03/2015 | |
BORME-A-2015-51-28 | Madrid | 16/03/2015 | |
BORME-A-2015-31-28 | Madrid | 16/02/2015 | |
BORME-A-2014-218-28 | Madrid | 14/11/2014 | |
BORME-A-2014-199-28 | Madrid | 17/10/2014 | |
BORME-A-2014-174-28 | Madrid | 12/09/2014 | |
BORME-A-2014-41-28 | Madrid | 28/02/2014 | |
BORME-A-2013-244-28 | Madrid | 23/12/2013 | |
BORME-A-2013-182-28 | Madrid | 24/09/2013 | |
BORME-A-2013-131-28 | Madrid | 12/07/2013 | |
BORME-A-2013-71-28 | Madrid | 16/04/2013 | |
BORME-A-2013-35-28 | Madrid | 20/02/2013 | |
BORME-A-2013-34-28 | Madrid | 19/02/2013 | |
BORME-A-2013-33-28 | Madrid | 18/02/2013 | |
BORME-A-2013-32-28 | Madrid | 15/02/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades