Última actualización: 20 de Diciembre de 2018
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Limitada |
NIF | B41961210 |
Denominación anterior | Dasy Organizacion SL |
Provincia | Sevilla |
Domicilio | Ctra Ecija - Almargen Km 27 - Apartado De Correos (Osuna). |
Capital social | 2.120.010,09 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Adm. Unico | Martinez Baeza Maria Encarnacion | 15/06/2015 | Actualidad |
Apoderado | Brias Gonzalez Maria Montserrat | 03/09/2014 | Actualidad |
Auditor | Proaudit SLP | 11/06/2014 | Actualidad |
Apoderado | Carrillo Bermudez Antonio | 07/11/2012 | Actualidad |
Auditor | Proaudit SLP | 25/10/2011 | Actualidad |
Apoderado | Rodriguez Monterde Rafael | 01/03/2011 | Actualidad |
Adm. Unico | Proteinas Y Grasas Gimeno SL | 18/03/2010 | Actualidad |
Auditor | Proaudit SLP | 18/03/2010 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Proaudit SLP | 08/05/2009 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Proaudit SLP | 05/01/2009 | Actualidad |
REPR.143 RRM | Gimeno Borras Jose Maria | 05/01/2009 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aud.Supl. | Sanchez Martinez Angel | 17/02/2016 | 27/01/2017 |
Auditor | Perez Conesa Juan | 17/02/2016 | 27/01/2017 |
Auditor | Proaudit SLP | 18/03/2010 | 17/02/2016 |
ADM.UNICO | Proteinas Y Grasas Gimeno SL | 05/01/2009 | 15/06/2015 |
Apoderado | Gimeno Brias Daniel | 07/01/2015 | 15/06/2015 |
Apoderado | Gimeno Borras Jose Maria | Desconocido | 15/06/2015 |
Apoderado | Carrillo Bermudez Antonio | 01/03/2011 | 15/06/2015 |
Apo.Sol. | Carrillo Bermudez Antonio | 18/03/2010 | 15/06/2015 |
APODERADO | Carrillo Bermudez Antonio | 21/01/2009 | 15/06/2015 |
Apoderado | Brias Gonzalez Maria Montserrat | 18/03/2010 | 15/06/2015 |
Apo.Manc. | Salgado Mora Marcelino | 07/11/2012 | 03/09/2014 |
Apo.Sol. | Rodriguez Monterde Rafael | 18/03/2010 | 03/09/2014 |
APODERADO | Rodriguez Monterde Rafael | 21/01/2009 | 03/09/2014 |
Apo.Manc. | Morales Trescents Xavier | 07/11/2012 | 03/09/2014 |
Apoderado | Duch Sole Montserrat | 01/03/2011 | 07/11/2012 |
Apoderado | Brias Gonzalez Maria Montserrat | 18/03/2010 | 16/11/2010 |
Apoderado | Brias Gonzalez Maria Montserrat | Desconocido | 18/03/2010 |
Adm. Unico | Brias Gonzalez Maria Montserrat | Desconocido | 18/03/2010 |
APODERADO | Brias Gonzalez Maria Montserrat | 21/01/2009 | 18/03/2010 |
APODERADO | Brias Gonzalez Maria Montserrat | 21/01/2009 | 21/01/2009 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Grasas Martinez Andalucia SL.
20
Dic 2018
Procedimiento concursal 392/2016. Fecha de resolución 11/04/2016. Revocación de administradores concursales. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA. Juez: SANTANA MIRALLES, JUAN FRANCISCO. Administrador Concursal. Fecha 14/12/2017, NIF/CIF 28927164H. GONZALEZ DIAZ ANTONIO JESUS.
Datos registrales: T 5594 , F 208, S 8, H SE 35656, I/A 34
20
Dic 2018
Procedimiento concursal 392/2016. FIRME: Si, Fecha de resolución 14/12/2017. Sentencia de aprobación del convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA. Juez: ANA MARIA GULLON GULLON. Resoluciones: CONVERTIDA EN INSCRIPCION LA ANOTACION LETRA B DE LA APROBACION DE LA PROPUESTA.DE CONVENIO Y APARTURA DE LA SECCION SEXTA.
Datos registrales: T 5594 , F 208, S 8, H SE 35656, I/A 34
05
Feb 2018
Con fecha 05/02/2018, la sociedad cambia su denominación social a GRASAS MARTINEZ ANDALUCIA SOCIEDAD LIMITADA
Datos registrales: T 5594 , F 208, S 8, H SE 35656, I/A 33
05
Feb 2018
Con fecha 05/02/2018, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
Artículo de los estatutos: 1. Denominación social.-.
Datos registrales: T 5594 , F 208, S 8, H SE 35656, I/A 33
19
Ene 2018
Procedimiento concursal 392/2016. FIRME: No, Fecha de resolución 14/12/2017. Sentencia de aprobación del convenio. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA. Juez: SANTANA MIRALLES, JUAN FRANCISCO. Resoluciones: SE PRACTICA ANOTACION PREVENTIVA DE LA APROBACION DE LA PROPUESTA DE CONVENIO Y APERTURA DE LA SECCION SEXTA DE CALIFICACION de la Sociedad , por el plazo de.cuatro años.
Datos registrales: T 5594 , F 201, S 8, H SE 35656, I/A B
19
Ene 2018
SE CESA EL REGIMEN DE INTERVENCION, PEE A LO CUAL CONTINUARA EN EL EJERCICIOS DE SUS FUNCIONES LA ADMINISTRACION CONCURSAL A LOS SOLOS EFECTOS DE LA SECCION DE CALIFICACION.
Datos registrales: T 5594 , F 201, S 8, H SE 35656, I/A B
13
Jun 2017
Procedimiento concursal 392/2016. FIRME: No, Fecha de resolución 11/05/2017. Auto de apertura de la fase de convenio. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA. Juez: SANTANA MIRALLES, JUAN FRANCISCO. Resoluciones: ANOTACION PREVENTIVA DE LA FINALIZACION DE LA FASE COMUN DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL , DE LA APERTURA DE LA FASE DE CONVENIO Y DE LA CONVOCARIA DE JUNTA DE.ACREEDORES.
Datos registrales: T 5594 , F 200, S 8, H SE 35656, I/A A
27
Ene 2017
Con fecha 27/01/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.Supl. | Sanchez Martinez Angel |
Auditor | Perez Conesa Juan |
Datos registrales: T 5594 , F 200, S 8, H SE 35656, I/A 32
31
May 2016
Procedimiento concursal 392/2016. FIRME: Si, Fecha de resolución 11/04/2016. Resoluciones acordando la intervención o suspensión de las factultades de administración y disposición del concursado. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA. Juez: SANTANA MIRALLES, JUAN FRANCISCO. Resoluciones: INTERVENCION.
Datos registrales: T 5594 , F 199, S 8, H SE 35656, I/A 31
31
May 2016
Procedimiento concursal 392/2016. Fecha de resolución 11/04/2016. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA. Juez: SANTANA MIRALLES, JUAN FRANCISCO. Administrador Concursal. Fecha 11/04/2016, NIF/CIF 28927164H. GONZALEZ DIAZ ANTONIO JESUS.
Datos registrales: T 5594 , F 199, S 8, H SE 35656, I/A 31
31
May 2016
Procedimiento concursal 392/2016. FIRME: Si, Fecha de resolución 11/04/2016. Auto de declaración de concurso. Voluntario. Juzgado: num. 2 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA. Juez: SANTANA MIRALLES, JUAN FRANCISCO. Resoluciones: PRACTICADA INSCRIPCION DE DECLARACION DE CONCURSO VOLUNARIO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR CONCURSAL.
Datos registrales: T 5594 , F 199, S 8, H SE 35656, I/A 31
17
Feb 2016
Con fecha 17/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Aud.Supl. | Sanchez Martinez Angel |
Auditor | Perez Conesa Juan |
Datos registrales: T 5594 , F 199, S 8, H SE 35656, I/A 30
17
Feb 2016
Con fecha 17/02/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Auditor | Proaudit SLP |
Datos registrales: T 5594 , F 199, S 8, H SE 35656, I/A 30
10
Nov 2015
Con fecha 10/11/2015 se inscribe en el Registro Mercantil la adquisición del carácter unipersonal de la sociedad, siendo el titular jurídico y formal de las acciones o participaciones societarias GRASAS MARTINEZ GONZALEZ SL.
Datos registrales: T 5594 , F 198, S 8, H SE 35656, I/A 29
15
Jun 2015
Con fecha 15/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Martinez Baeza Maria Encarnacion |
Datos registrales: T 5594 , F 197, S 8, H SE 35656, I/A 28
15
Jun 2015
Con fecha 15/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gimeno Brias Daniel |
Apoderado | Gimeno Borras Jose Maria |
Apoderado | Carrillo Bermudez Antonio |
Apoderado | Brias Gonzalez Maria Montserrat |
Datos registrales: T 5594 , F 197, S 8, H SE 35656, I/A 28
15
Jun 2015
Con fecha 15/06/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Adm. Unico | Proteinas Y Grasas Gimeno SL |
Datos registrales: T 5594 , F 197, S 8, H SE 35656, I/A 28
07
Ene 2015
Con fecha 07/01/2015 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Gimeno Brias Daniel |
Datos registrales: T 5594 , F 196, S 8, H SE 35656, I/A 27
03
Sep 2014
Con fecha 03/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apoderado | Brias Gonzalez Maria Montserrat |
Datos registrales: T 5594 , F 195, S 8, H SE 35656, I/A 25
03
Sep 2014
Con fecha 03/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Apo.Manc. | Salgado Mora Marcelino |
Apo.Manc. | Morales Trescents Xavier |
Datos registrales: T 5594 , F 195, S 8, H SE 35656, I/A 24
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2021-223-41 | Sevilla | 22/11/2021 | |
BORME-A-2019-5-41 | Sevilla | 09/01/2019 | |
BORME-A-2018-32-41 | Sevilla | 14/02/2018 | |
BORME-A-2018-25-41 | Sevilla | 05/02/2018 | |
BORME-A-2017-118-41 | Sevilla | 23/06/2017 | |
BORME-A-2017-27-41 | Sevilla | 08/02/2017 | |
BORME-A-2016-108-41 | Sevilla | 08/06/2016 | |
BORME-A-2016-40-41 | Sevilla | 29/02/2016 | |
BORME-A-2015-219-41 | Sevilla | 17/11/2015 | |
BORME-A-2015-116-41 | Sevilla | 23/06/2015 | |
BORME-A-2015-10-41 | Sevilla | 16/01/2015 | |
BORME-A-2014-175-41 | Sevilla | 15/09/2014 | |
BORME-A-2014-116-41 | Sevilla | 23/06/2014 | |
BORME-A-2013-140-41 | Sevilla | 25/07/2013 | |
BORME-A-2012-224-41 | Sevilla | 22/11/2012 | |
BORME-A-2011-213-41 | Sevilla | 10/11/2011 | |
BORME-A-2011-49-41 | Sevilla | 11/03/2011 | |
BORME-A-2010-228-41 | Sevilla | 29/11/2010 | |
BORME-A-2010-88-41 | Sevilla | 11/05/2010 | |
BORME-A-2010-73-41 | Sevilla | 20/04/2010 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades