Última actualización: 11 de Enero de 2024
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A58843731 |
Provincia | Barcelona |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIT.INDIV. | Rodl & Partner Auditores SLP | 11/01/2024 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz | 07/08/2023 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Marc Richard Deimling | 29/03/2023 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 28/11/2022 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 09/11/2021 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 13/11/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Sanchez Delgado Ismael | 20/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Marc Richard Deimling | 20/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz | 20/08/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Garcia Bujan Maria Amable | 20/08/2020 | Actualidad |
APODERAD.SOL | Buisan Lachen Belen Maria | 22/02/2019 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz | 17/07/2018 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Marc Richard Deimling | 23/04/2018 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL | 22/01/2018 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 22/09/2014 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 19/07/2013 | Actualidad |
ADM.CONJUNTO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz | 19/07/2013 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL | 15/01/2013 | Actualidad |
APODERADO | Garcia Bujan Maria Amable | 22/08/2012 | Actualidad |
APODERADO | Flor Garre Jose | 22/08/2012 | Actualidad |
Ver más |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APOD.SOL/MAN | Marc Richard Deimling | 25/01/2019 | 20/08/2020 |
APODERADO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz | 22/12/2009 | 20/08/2020 |
APODERADO | Garcia Bujan Maria Amable | 02/05/2011 | 20/08/2020 |
APODERAD.SOL | Garcia Bujan Maria Amable | 22/02/2019 | 20/08/2020 |
APODERADO | Flor Garre Jose | 02/05/2011 | 20/08/2020 |
APODERAD.SOL | Flor Garre Jose | 22/02/2019 | 20/08/2020 |
APOD.SOL/MAN | Jean Michel Robert Henri Ghislain Wins | 25/09/2013 | 25/01/2019 |
APODERAD.SOL | Ferrer Puig Carlos | 09/08/2013 | 25/01/2019 |
ADM.CONJUNTO | Jean Michel Robert Henri Ghislain Wins | 19/07/2013 | 23/04/2018 |
APODERADO | Serrano Mannsfeld Juan | 22/08/2012 | 25/09/2013 |
APODERADO | Matthias Peter Hunerwadel | 02/05/2011 | 25/09/2013 |
PRESIDENTE | Serrano Mannsfeld Juan | 30/11/2011 | 19/07/2013 |
CONSEJERO | Serrano Mannsfeld Juan | 30/11/2011 | 19/07/2013 |
CONS.DEL.MAN | Serrano Mannsfeld Juan | 30/11/2011 | 19/07/2013 |
CONSEJERO | Matthias Peter Hunerwadel | 22/08/2012 | 19/07/2013 |
CONSEJERO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz | 22/08/2012 | 19/07/2013 |
SECR.NO CONS | Ferrer Puig Carlos | Desconocido | 19/07/2013 |
CONSEJERO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz | Desconocido | 22/08/2012 |
APODERADO | Judith Anne Ilse Margareta Ulrike Matz | 02/05/2011 | 22/08/2012 |
APODERADO | Garcia Bujan Maria Amable | 22/12/2009 | 22/08/2012 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Forbo Siegling Iberica SA.
11
Ene 2024
Con fecha 11/01/2024 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.INDIV. | Rodl & Partner Auditores SLP |
Datos registrales: T 46714 , F 176, S 8, H B 22816, I/A 69
07
Ago 2023
Con fecha 07/08/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz |
Datos registrales: T 46714 , F 176, S 8, H B 22816, I/A 68
29
Mar 2023
Con fecha 29/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Marc Richard Deimling |
Datos registrales: T 46714 , F 176, S 8, H B 22816, I/A 67
28
Nov 2022
Con fecha 28/11/2022 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 46714 , F 176, S 8, H B 22816, I/A 66
09
Nov 2021
Con fecha 09/11/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 46714 , F 175, S 8, H B 22816, I/A 65
13
Nov 2020
Con fecha 13/11/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 46714 , F 175, S 8, H B 22816, I/A 64
20
Ago 2020
Con fecha 20/08/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Sanchez Delgado Ismael |
APOD.SOL/MAN | Marc Richard Deimling |
APOD.SOL/MAN | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz |
APOD.SOL/MAN | Garcia Bujan Maria Amable |
Datos registrales: T 46714 , F 173, S 8, H B 22816, I/A 63
20
Ago 2020
Con fecha 20/08/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Marc Richard Deimling |
APODERADO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz |
APODERADO | Garcia Bujan Maria Amable |
APODERAD.SOL | Flor Garre Jose |
Datos registrales: T 46714 , F 173, S 8, H B 22816, I/A 63
22
Feb 2019
Con fecha 22/02/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Garcia Bujan Maria Amable |
APODERAD.SOL | Flor Garre Jose |
APODERAD.SOL | Buisan Lachen Belen Maria |
Datos registrales: T 46714 , F 172, S 8, H B 22816, I/A 62
25
Ene 2019
Con fecha 25/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Marc Richard Deimling |
Datos registrales: T 42876 , F 140, S 8, H B 22816, I/A 61
25
Ene 2019
Con fecha 25/01/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Jean Michel Robert Henri Ghislain Wins |
APODERAD.SOL | Ferrer Puig Carlos |
Datos registrales: T 42876 , F 140, S 8, H B 22816, I/A 61
17
Jul 2018
Con fecha 17/07/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Judith Anne Ilse Margarete Ulrike Matz |
Datos registrales: T 42876 , F 140, S 8, H B 22816, I/A 60
23
Abr 2018
Con fecha 23/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Marc Richard Deimling |
Datos registrales: T 42876 , F 139, S 8, H B 22816, I/A 59
23
Abr 2018
Con fecha 23/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
ADM.CONJUNTO | Jean Michel Robert Henri Ghislain Wins |
Datos registrales: T 42876 , F 139, S 8, H B 22816, I/A 59
22
Ene 2018
Con fecha 22/01/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Kpmg Auditores SL |
Datos registrales: T 42876 , F 139, S 8, H B 22816, I/A 58
26
May 2015
SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: FORBO NL HOLDING BV.
Datos registrales: T 42876 , F 139, S 8, H B 22816, I/A 57
22
Sep 2014
Con fecha 22/09/2014 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Pricewaterhousecoopers Auditores SL |
Datos registrales: T 42876 , F 139, S 8, H B 22816, I/A 56
25
Sep 2013
Con fecha 25/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Jean Michel Robert Henri Ghislain Wins |
Datos registrales: T 42876 , F 137, S 8, H B 22816, I/A 55
25
Sep 2013
Con fecha 25/09/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Serrano Mannsfeld Juan |
APODERADO | Matthias Peter Hunerwadel |
Datos registrales: T 42876 , F 137, S 8, H B 22816, I/A 55
09
Ago 2013
Con fecha 09/08/2013 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERAD.SOL | Ferrer Puig Carlos |
Datos registrales: T 42876 , F 136, S 8, H B 22816, I/A 54
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2024-14-08 | Barcelona | 19/01/2024 | |
BORME-A-2023-155-08 | Barcelona | 16/08/2023 | |
BORME-A-2023-68-08 | Barcelona | 11/04/2023 | |
BORME-A-2022-233-08 | Barcelona | 09/12/2022 | |
BORME-A-2021-219-08 | Barcelona | 16/11/2021 | |
BORME-A-2020-225-08 | Barcelona | 23/11/2020 | |
BORME-A-2020-167-08 | Barcelona | 28/08/2020 | |
BORME-A-2019-43-08 | Barcelona | 04/03/2019 | |
BORME-A-2019-25-08 | Barcelona | 06/02/2019 | |
BORME-A-2019-18-08 | Barcelona | 28/01/2019 | |
BORME-A-2018-143-08 | Barcelona | 26/07/2018 | |
BORME-A-2018-83-08 | Barcelona | 30/04/2018 | |
BORME-A-2018-21-08 | Barcelona | 30/01/2018 | |
BORME-A-2015-102-08 | Barcelona | 02/06/2015 | |
BORME-A-2014-187-08 | Barcelona | 01/10/2014 | |
BORME-A-2013-188-08 | Barcelona | 02/10/2013 | |
BORME-A-2013-157-08 | Barcelona | 20/08/2013 | |
BORME-A-2013-142-08 | Barcelona | 29/07/2013 | |
BORME-A-2013-17-08 | Barcelona | 25/01/2013 | |
BORME-A-2012-169-08 | Barcelona | 04/09/2012 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades