Última actualización: 29 de Marzo de 2023
Fuente de los datos: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La información mostrada en esta página solamente reproduce el contenido de boletines oficiales y no identifica unívocamente a ninguna persona física.
Situación Mercantil | Activa |
---|---|
Forma jurídica | Sociedad Anónima |
NIF | A64936156 |
Provincia | Albacete |
Domicilio | C/ Blasco De Garay, 42 (Villarrobledo). |
Capital social | 437.000,0 euros |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Consejero | Vargas Lara Jose Antonio | 29/03/2023 | Actualidad |
Consejero | Varela Gomez Javier | 29/03/2023 | Actualidad |
Consejero | Franch Roman Juan | 29/03/2023 | Actualidad |
Presidente | Bolufer Garcia Francisco Jose | 29/03/2023 | Actualidad |
Consejero | Bolufer Garcia Francisco Jose | 29/03/2023 | Actualidad |
Con.Delegado | Bolufer Garcia Francisco Jose | 29/03/2023 | Actualidad |
VsecrNoConsj | Serra Garcia Salvio | 13/05/2021 | Actualidad |
SecreNoConsj | Vargas Lara Amparo | 15/01/2020 | Actualidad |
APOD.SOL/MAN | Vargas Lara Amparo | 28/08/2019 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Alter Bg Auditors SL | 15/11/2018 | Actualidad |
VICEPRESIDEN | Valera Gomez Javier | 18/04/2018 | Actualidad |
CONSEJERO | Valera Gomez Javier | 18/04/2018 | Actualidad |
CONS. DELEG. | Otero Rodriguez Jose Carlos | 23/09/2015 | Actualidad |
VICEPRESIDEN | Rosa Ruiz Jose Manuel | 23/08/2012 | Actualidad |
CONSEJERO | Rosa Ruiz Jose Manuel | 23/08/2012 | Actualidad |
CONSEJERO | De Las Moras Ruiz Pedro | 23/08/2012 | Actualidad |
AUDIT.CUENT. | Alter Bg Auditors SL | 16/08/2011 | Actualidad |
Cargo | Persona física/jurídica | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vicepresid. | Varela Gomez Javier | Desconocido | 29/03/2023 |
Consejero | Varela Gomez Javier | Desconocido | 29/03/2023 |
CONSEJERO | Franch Roman Juan | 18/04/2018 | 29/03/2023 |
PRESIDENTE | Bolufer Garcia Francisco Jose | 18/04/2018 | 29/03/2023 |
CONSEJERO | Bolufer Garcia Francisco Jose | 18/04/2018 | 29/03/2023 |
CONS. DELEG. | Bolufer Garcia Francisco Jose | 18/04/2018 | 29/03/2023 |
SECR.NO CONS | Muñoz Lozano Ingrid | 18/04/2018 | 15/01/2020 |
CONSEJERO | Gutierrez Villanueva Esther | 23/09/2015 | 15/11/2018 |
CONSEJERO | Alcala Romero Jose Manuel | 18/04/2018 | 15/11/2018 |
SECR.NO CONS | Rodriguez Carrera Alberto | 26/01/2016 | 18/04/2018 |
VICEPRESIDEN | Rodriguez Andujar Marco Antonio | 23/09/2015 | 18/04/2018 |
CONSEJERO | Rodriguez Andujar Marco Antonio | 05/11/2013 | 18/04/2018 |
PRESIDENTE | Otero Rodriguez Jose Carlos | 05/11/2013 | 18/04/2018 |
CONSEJERO | Otero Rodriguez Jose Carlos | 23/08/2012 | 18/04/2018 |
CONS. DELEG. | Otero Rodriguez Jose Carlos | 05/11/2013 | 18/04/2018 |
CONSEJERO | Franch Roman Juan | 23/08/2012 | 18/04/2018 |
CONSEJERO | Ferrer Benavent Enrique | 23/08/2012 | 18/04/2018 |
APOD.MANCOMU | Rodriguez Carrera Alberto | 14/09/2016 | 25/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Muñoz Lozano Ingrid | 14/09/2016 | 25/04/2017 |
APOD.MANCOMU | Franch Roman Juan | 14/09/2016 | 25/04/2017 |
Ver más |
Relación de inscripciones
Actos mercantiles publicados en la edición digital del BORME relacionados o inscritos por Euro Stock Negocios De Automocion SA.
29
Mar 2023
Con fecha 29/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Vargas Lara Jose Antonio |
Consejero | Varela Gomez Javier |
Consejero | Franch Roman Juan |
Consejero | Bolufer Garcia Francisco Jose |
Datos registrales: T 1031, L 795, F 147, S 8, H AB 27839, I/A 5
29
Mar 2023
Con fecha 29/03/2023 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
Consejero | Varela Gomez Javier |
Consejero | Franch Roman Juan |
Consejero | Bolufer Garcia Francisco Jose |
Datos registrales: T 1031, L 795, F 147, S 8, H AB 27839, I/A 5
13
May 2021
Con fecha 13/05/2021 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VsecrNoConsj | Serra Garcia Salvio |
Datos registrales: T 1012, L 776, F 110, S 8, H AB 27839, I/A 4
15
Ene 2020
Con fecha 15/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Vargas Lara Amparo |
Datos registrales: T 1012, L 776, F 110, S 8, H AB 27839, I/A 3
15
Ene 2020
Con fecha 15/01/2020 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes ceses/dimisiones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SecreNoConsj | Muñoz Lozano Ingrid |
Datos registrales: T 1012, L 776, F 110, S 8, H AB 27839, I/A 3
15
Nov 2019
Con fecha 15/11/2019, la sociedad cambia su domicilio social a C/ BLASCO DE GARAY, 42 (VILLARROBLEDO).
Datos registrales: T 1012, L 776, F 110, S 8, H AB 27839, I/A 2
28
Ago 2019
Con fecha 28/08/2019 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.SOL/MAN | Vargas Lara Amparo |
Datos registrales: T 43359 , F 30, S 8, H B 376265, I/A 25
18
Abr 2018
En el BORME no.82/2018 y con referencia 184589 SE RECTIFICA EN CUANTO AL PRIMER APELLIDO DEL CONSEJERO Y VICEPRESIDENTE NOMBRADO, DONDE SE LEE "VALERA" DEBE LEERSE "VARELA".
Datos registrales: T 43359 , F 28, S 8, H B 376265, I/A 23
15
Nov 2018
Con fecha 15/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
AUDIT.CUENT. | Alter Bg Auditors SL |
Datos registrales: T 43359 , F 29, S 8, H B 376265, I/A 24
15
Nov 2018
Con fecha 15/11/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Gutierrez Villanueva Esther |
CONSEJERO | Alcala Romero Jose Manuel |
Datos registrales: T 43359 , F 29, S 8, H B 376265, I/A 24
18
Abr 2018
Con fecha 18/04/2018, la sociedad hizo las siguientes modificaciones estatutarias:
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2.3, 6 Y 21 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Datos registrales: T 43359 , F 28, S 8, H B 376265, I/A 23
18
Abr 2018
Con fecha 18/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
CONSEJERO | Valera Gomez Javier |
CONSEJERO | Franch Roman Juan |
PRESIDENTE | Bolufer Garcia Francisco Jose |
CONSEJERO | Alcala Romero Jose Manuel |
Datos registrales: T 43359 , F 28, S 8, H B 376265, I/A 23
18
Abr 2018
Con fecha 18/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
VICEPRESIDEN | Rodriguez Andujar Marco Antonio |
PRESIDENTE | Otero Rodriguez Jose Carlos |
CONSEJERO | Franch Roman Juan |
CONSEJERO | Ferrer Benavent Enrique |
Datos registrales: T 43359 , F 28, S 8, H B 376265, I/A 23
18
Abr 2018
Con fecha 18/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes nombramientos en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Muñoz Lozano Ingrid |
Datos registrales: T 43359 , F 28, S 8, H B 376265, I/A 22
18
Abr 2018
Con fecha 18/04/2018 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
SECR.NO CONS | Rodriguez Carrera Alberto |
Datos registrales: T 43359 , F 28, S 8, H B 376265, I/A 22
19
Dic 2017
SE RECTIFICA LA INSCRIPCIEN 20, POR CUANTO SE REVOCO ERRONEAMENTE A LOS APODERADOS: DOÑA INGRID MUÑOZ LOZANO Y DON JUAN FRANCH ROMAN, QUEDANDO SUS PODERES VIGENTES.
Datos registrales: T 43359 , F 27, S 8, H B 376265, I/A 21
25
Abr 2017
En el BORME no.83/2017 y con referencia 186420 SE REVOCO ERRONEAMENTE A LOS APODERADOS: INGRID MUÑOZ LOZANO, JUAN FRANCH ROMAN, NO DEBIENDO HABER SIDO REVOCADOS.
Datos registrales: T 43359 , F 27, S 8, H B 376265, I/A 20
25
Abr 2017
Con fecha 25/04/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Rodriguez Carrera Alberto |
APOD.MANCOMU | Muñoz Lozano Ingrid |
APOD.MANCOMU | Franch Roman Juan |
Datos registrales: T 43359 , F 27, S 8, H B 376265, I/A 20
22
Feb 2017
Con fecha 22/02/2017 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APOD.MANCOMU | Mansilla Perez Joaquin |
Datos registrales: T 43359 , F 27, S 8, H B 376265, I/A 19
04
Oct 2016
Con fecha 04/10/2016 se inscriben en el Registro Mercantil los siguientes revocaciones en la sociedad:
Cargo | Persona física/jurídica |
---|---|
APODERADO | Muñoz Lozano Ingrid |
APODERADO | Mansilla Perez Joaquin |
Datos registrales: T 43359 , F 27, S 8, H B 376265, I/A 18
CVE | Provincia | Fecha | |
---|---|---|---|
BORME-A-2023-66-02 | Albacete | 05/04/2023 | |
BORME-A-2021-94-02 | Albacete | 20/05/2021 | |
BORME-A-2020-16-02 | Albacete | 24/01/2020 | |
BORME-A-2019-225-02 | Albacete | 22/11/2019 | |
BORME-A-2019-170-08 | Barcelona | 05/09/2019 | |
BORME-A-2019-53-08 | Barcelona | 18/03/2019 | |
BORME-A-2018-225-08 | Barcelona | 23/11/2018 | |
BORME-A-2018-82-08 | Barcelona | 27/04/2018 | |
BORME-A-2017-246-08 | Barcelona | 29/12/2017 | |
BORME-A-2017-243-08 | Barcelona | 26/12/2017 | |
BORME-A-2017-83-08 | Barcelona | 04/05/2017 | |
BORME-A-2017-43-08 | Barcelona | 02/03/2017 | |
BORME-A-2016-195-08 | Barcelona | 11/10/2016 | |
BORME-A-2016-183-08 | Barcelona | 23/09/2016 | |
BORME-A-2016-84-08 | Barcelona | 04/05/2016 | |
BORME-A-2016-22-08 | Barcelona | 03/02/2016 | |
BORME-A-2015-188-08 | Barcelona | 01/10/2015 | |
BORME-A-2015-88-08 | Barcelona | 12/05/2015 | |
BORME-A-2014-155-08 | Barcelona | 18/08/2014 | |
BORME-A-2013-216-08 | Barcelona | 12/11/2013 | |
Ver más |
Sé el primero en enterarte de nuestras novedades